Actos BORME de Samaprop Iberia Sl
20 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA. Cons.Del.Man: AUXADI CONTABLES &CONSULTORES SA. Consejero: RATCLIFFE RICHARD GORDON;EHIERS CHESTER WILLIAM. Cons.Del.Man: RATCLIFFERICHARD GORDON;EHIERS CHESTER WILLIAM. Presidente: RATCLIFFE RICHARD GORDON. Consejero: TANNER MATTHEWCOLENSO. Cons.Del.Man: TANNER MATTHEW COLENSO. Secretario: SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA. Representan:SALAMANCA CUEVAS VICTOR. Nombramientos. Liquidador: AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL. Representan:SALAMANCA CUEVAS VICTOR. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 21948 , F 220, S 8, H M 391105, I/A 22 (8.11.18).
12 de Marzo de 2018Revocaciones. Representan: SALAMANCA CARRASCO VICTOR. Nombramientos. Representan: SALAMANCA CUEVASVICTOR. Datos registrales. T 21948 , F 220, S 8, H M 391105, I/A 21 (28.02.18).
12 de Febrero de 2018Nombramientos. Apoderado: AUXADI CONTABLES & CONSULTORES SA;EHLERS CHESTER WILLIAM;TANNER MATTHEWCOLENSO;RATCLIFFE RICHARD GORDON. Datos registrales. T 21948 , F 219, S 8, H M 391105, I/A 20 ( 2.02.18).
22 de Febrero de 2017Cambio de domicilio social. C/ NANCLARES DE OCA NUMERO 1B (MADRID). Datos registrales. T 21948 , F 219, S 8, H M391105, I/A 19 (15.02.17).
12 de Agosto de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 6.607.434,24 Euros. Resultante Suscrito: 1.495.571,76 Euros. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 6. Capital social.-. Datos registrales. T 21948 , F 218, S 8, H M 391105, I/A 18 ( 5.08.16).
09 de Agosto de 2016Nombramientos. Cons.Del.Man: TANNER MATTHEW COLENSO. Datos registrales. T 21948 , F 218, S 8, H M 391105, I/A 17 (1.08.16).
04 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BLANCHARD ERIC PAUL. Cons.Del.Man: BLANCHARD ERIC PAUL. Nombramientos. Consejero:TANNER MATTHEW COLENSO. Datos registrales. T 21948 , F 218, S 8, H M 391105, I/A 16 (24.06.16).
18 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: DONALD CORNER STEPHEN. Cons.Del.Man: DONALD CORNER STEPHEN. Datos registrales. T21948 , F 218, S 8, H M 391105, I/A 15 (10.12.14).
11 de Diciembre de 2012Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Datos registrales. T 21948 , F 217, S 8, H M 391105, I/A 14(30.11.12).
06 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: SANDERS TIMOTHY JAMES. Cons.Del.Man: SANDERS TIMOTHY JAMES. Nombramientos.Consejero: DONALD CORNER STEPHEN. Cons.Del.Man: DONALD CORNER STEPHEN. Datos registrales. T 21948 , F 217, S 8, HM 391105, I/A 13 (24.06.11).
02 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: JAN VAN LIER HENDRIK. Cons.Del.Man: JAN VAN LIER HENDRIK;JAN VAN LIER HENDRIK.Consejero: SIJMONS ELS EANNA. Cons.Del.Man: SIJMONS ELS EANNA. Consejero: BITHELL DAVID. Cons.Del.Man: BITHELLDAVID. Presidente: BITHELL DAVID. Nombramientos. Consejero: SANDERS TIMOTHY JAMES;BLANCHARD ERICPAUL;RATCLIFFE RICHARD GORDON;EHIERS CHESTER WILLIAM;RATCLIFFE RICHARD GORDON. Cons.Del.Man: RATCLIFFERICHARD GORDON;SANDERS TIMOTHY JAMES;EHIERS CHESTER WILLIAM;BLANCHARD ERIC PAUL. Presidente: RATCLIFFERICHARD GORDON. Datos registrales. T 21948 , F 215, S 8, H M 391105, I/A 12 (22.11.10).
22 de Noviembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: BROWN NIGEL. Cons.Del.Man: BROWN NIGEL. Presidente: BROWN NIGEL. Nombramientos.Presidente: BITHELL DAVID. Datos registrales. T 21948 , F 215, S 8, H M 391105, I/A 11 ( 5.11.10).
16 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: BONO LANDALUCE CARIDAD. Datos registrales. T 21948 , F 214, S 8, H M 391105, I/A 10 (6.10.09).
24 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: LAMBERT GLYN. Cons.Del.Man: LAMBERT GLYN. Nombramientos. VsecrNoConsj: BONOLANDALUCE CARIDAD. Consejero: BITHELL DAVID. Cons.Del.Man: BITHELL DAVID. Apoderado: GORDON RATCLIFFE RICHARD.Otros conceptos: REVOCADO EL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DON GLYN LAMBERT CONFERIDO EN ESCRITURA QUECAUSO LA INSCRIPCION 6& DE LA HOJA SOCIAL.- Cambio de domicilio social. AVDA DE ARAGON 330 - PARQUEEMPRESARIAL LAS MERCED (MADRID). Datos registrales. T 21948 , F 213, S 8, H M 391105, I/A 9 (11.02.09).
14 de Enero de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.100.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.103.006,00 Euros. Datos registrales. T 21948 , F 213, S8, H M 391105, I/A 8 (30.12.08).