Buscador CIF Logo

Actos BORME San Jose Del Taller De Nazaret Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera San Jose Del Taller De Nazaret Sl

Actos BORME San Jose Del Taller De Nazaret Sl - B28363257

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para San Jose Del Taller De Nazaret Sl con CIF B28363257

馃敊 Perfil de San Jose Del Taller De Nazaret Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de San Jose Del Taller De Nazaret Sl

15 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: PEREZ MEDINA FRANCISCO JAVIER;BERNAT ENGUIDANOS RUBEN;BORRAS BARBER JAUMEJOSEP;MENDEZ RODRIGUEZ PABLO;BORRAS GONZALEZ JUAN MANUEL;MU脩IZ SAN SEGUNDO GEMA ISABEL;JORDANAREYNO JAIME;ONTOSO GARCIA MARIA CRISTINA;CASES MASSAGUER JOSEP MARIA;HIDALGO SANCHEZ PEDRO;MARCHVAZQUEZ JOSE BENITO;DEL CASTILLO COBA FRANCISCO JAVIER;RIVERA BLASCO DARIO;DE LA TORRE MARTINEZCAYETANO;VERDIER PEREZ ESTHER;PEREZ GOMEZ NOELIA;DEL SOL SANCHEZ ANA;MENAYO ESCRIBANODAVID;NOMBELA FERNANDEZ IVAN;AGUILAR HERNANEZ FRANCISCO JAVIER;FERRIOL TORRENS FRANCISCA;BONOESCRICHE JESUS. Datos registrales. T 42985 , F 25, S 8, H M 492171, I/A 20 ( 8.12.23).

17 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: URBANO LOPEZ JUAN CARLOS. Apo.Sol.: URBANO LOPEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T42985 , F 25, S 8, H M 492171, I/A 19 (12.11.23).

12 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apoderado: DEL SOL SANCHEZ ANA;GOMEZ LABRADOR CELSO LUIS;ALVAREZ GARCIA JAIRO;AGUILARHERNANDEZ FRANCISCO JAVIER;RUIZ DE ASSIN PAVON ISABEL. Datos registrales. T 42985 , F 24, S 8, H M 492171, I/A 18 (7.05.23).

15 de Marzo de 2023
Nombramientos. Apoderado: DEL SOL SANCHEZ ANA;GOMEZ LABRADOR CELSO;ALVAREZ GARCIA JAIRO;AGUILARHERNANEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 42985 , F 23, S 8, H M 492171, I/A 17 ( 8.03.23).

25 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: PEREZ MEDINA FRANCISCO JAVIER;BERNAT ENGUIDANOS RUBEN;BORRAS BARBER JAUME

10 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL. Datos registrales. T 27313 , F 224, S 8, H M 492171,I/A 15 ( 3.02.22).

03 de Enero de 2022
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: GARCIA MOLINA FRANCISCO. Consejero: DEL VAL COB MANUEL. Vicepresid.: DEL VAL COBMANUEL. Cons.Del.Man: DEL VAL COB MANUEL. Consejero: MU脩OZ SANCHEZ LORENZO;SUAREZ ALMAZOR RAFAEL DIEGO.Cons.Del.Man: SUAREZ ALMAZOR RAFAEL DIEGO. Consejero: HURTADO ZAPICO JUAN. Cons.Del.Man: HURTADO ZAPICOJUAN. Consejero: ZABARA CARRASCO ANDRES;GARCIA MOLINA FRANCISCO;PALACIOS GIL PABLO;RODRIGUEZ AVIALLLARDENT MARIANO. Secretario: RODRIGUEZ AVIAL LLARDENT MARIANO. Presidente: SUAREZ ALMAZOR RAFAEL DIEGO.Nombramientos. Adm. Unico: SATURN HOLDCO SA. Representan: PEREZ MEDINA FRANCISCO JAVIER. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social. C/ GENOVA27, PLANTA 2 (MADRID). Datos registrales. T 27313 , F 223, S 8, H M 492171, I/A 14 (27.12.21).

22 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: BUSTINDUY BATALLA MARCIAL. Datos registrales. T 27313 , F 222, S 8, H M 492171, I/A 13(15.11.21).

10 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE ALZOLA VILLAR JOSE MARIA. Presidente: DE ALZOLA VILLAR JOSE MARIA. Cons.Del.Man:DE ALZOLA VILLAR JOSE MARIA. Nombramientos. Presidente: SUAREZ ALMAZOR RAFAEL DIEGO. Datos registrales. T 27313, F 222, S 8, H M 492171, I/A 12 ( 1.12.20).

23 de Octubre de 2018
Nombramientos. Cons.Del.Man: GARCIA MOLINA FRANCISCO. Reelecciones. Tesorero: GARCIA MOLINA FRANCISCO.Consejero: DE ALZOLA VILLAR JOSE MARIA. Presidente: DE ALZOLA VILLAR JOSE MARIA. Cons.Del.Man: DE ALZOLA VILLARJOSE MARIA. Consejero: DEL VAL COB MANUEL. Vicepresid.: DEL VAL COB MANUEL. Cons.Del.Man: DEL VAL COB MANUEL.Consejero: MU脩OZ SANCHEZ LORENZO;SUAREZ ALMAZOR RAFAEL DIEGO. Cons.Del.Man: SUAREZ ALMAZOR RAFAELDIEGO. Consejero: HURTADO ZAPICO JUAN. Cons.Del.Man: HURTADO ZAPICO JUAN. Consejero: ZABARA CARRASCOANDRES;BUSTINDUY BATALLA MARCIAL;GARCIA MOLINA FRANCISCO;PALACIOS GIL PABLO;RODRIGUEZ AVIAL LLARDENTMARIANO. Secretario: RODRIGUEZ AVIAL LLARDENT MARIANO. Datos registrales. T 27313 , F 221, S 8, H M 492171, I/A 11(15.10.18).

29 de Septiembre de 2016
Modificaciones estatutarias. SUPRESION DEL ARTICULO 7. MODIFICACION DEL ARTICULO 8. Datos registrales. T 27313 , F221, S 8, H M 492171, I/A 10 (22.09.16).

28 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ SASTRE JOSE MANUEL. Datos registrales. T 27313 , F 221, S 8, H M 492171, I/A 8(16.03.16).

Cambio de domicilio social. C/ ARAGONESES 10 4潞 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 27313 , F 221, S 8, H M 492171, I/A 9(16.03.16).

13 de Noviembre de 2015
Modificaciones estatutarias. 12 Y 22.. Datos registrales. T 27313 , F 220, S 8, H M 492171, I/A 7 ( 3.11.15).

01 de Julio de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 856.198,75 Euros. Resultante Suscrito: 1.712.397,50 Euros. Datos registrales. T 27313 , F 219, S 8,H M 492171, I/A 6 (24.06.15).

26 de Junio de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA MOLINA FRANCISCO. Datos registrales. T 27313 , F 219, S 8, H M 492171, I/A 5(19.06.15).

23 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Secretario: MU脩OZ SANCHEZ LORENZO. Consejero: MORALES MOTOS MIGUEL. Nombramientos.Consejero: RODRIGUEZ AVIAL LLARDENT MARIANO. Secretario: RODRIGUEZ AVIAL LLARDENT MARIANO. Tesorero: GARCIAMOLINA FRANCISCO. Reelecciones. Consejero: DE ALZOLA VILLAR JOSE MARIA. Presidente: DE ALZOLA VILLAR JOSEMARIA. Cons.Del.Man: DE ALZOLA VILLAR JOSE MARIA. Consejero: DEL VAL COB MANUEL. Vicepresid.: DEL VAL COBMANUEL. Cons.Del.Man: DEL VAL COB MANUEL. Consejero: MU脩OZ SANCHEZ LORENZO;SUAREZ ALMAZOR RAFAEL DIEGO.Cons.Del.Man: SUAREZ ALMAZOR RAFAEL DIEGO. Consejero: HURTADO ZAPICO JUAN. Cons.Del.Man: HURTADO ZAPICOJUAN. Consejero: ZABARA CARRASCO ANDRES;BUSTINDUY BATALLA MARCIAL;GARCIA MOLINA FRANCISCO;PALACIOS GILPABLO;PEREZ SASTRE JOSE MANUEL. Datos registrales. T 27313 , F 218, S 8, H M 492171, I/A 4 (12.06.14).

11 de Octubre de 2011
Modificaciones estatutarias. 34. Otros.-. Cambio de domicilio social. AVDA DE LA INDUSTRIA 15 (ALCOBENDAS). Datosregistrales. T 27313 , F 217, S 8, H M 492171, I/A 3 (29.09.11).

06 de Julio de 2010
Otros conceptos: Comunicaci贸n de cancelaci贸n de asientos y cierre de hoja enel Registro de Cooperativas de la Comunidad deMadrid como consecuencia de la transformaci贸n en Sociedad Limitada de lamercantil. Datos registrales. T 27313 , F 195, S 8, H M492171, I/A 1M (11.06.10).

16 de Junio de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ AVIAL LLARDENT MARIANO. Presidente: RODRIGUEZ AVIAL LLARDENT MARIANO.Consejero: DEL VAL COB MANUEL. Vicepresid.: DEL VAL COB MANUEL. Consejero: DEL VALLE INCLAN BOLA脩O JOSE LUIS.Secretario: DEL VALLE INCLAN BOLA脩O JOSE LUIS. Consejero: HURTADO ZAPICO JUAN;MORALES MOTOSMIGUEL;ARAGONES BELTRAN JOSE MARIA;SASTRE PEREZ JOSE MANUEL;PALACIOS GIL PABLO;ZABARA CARRASCOANDRES;GARCIA MOLINA SALVADOR;DE ALZOLA VILLAR JOSE MARIA. Cons.Del.Man: RODRIGUEZ AVIAL LLARDENTMARIANO;DEL VAL COB MANUEL. Nombramientos. Consejero: DE ALZOLA VILLAR JOSE MARIA. Presidente: DE ALZOLAVILLAR JOSE MARIA. Cons.Del.Man: DE ALZOLA VILLAR JOSE MARIA. Consejero: DEL VAL COB MANUEL. Vicepresid.: DEL VALCOB MANUEL. Cons.Del.Man: DEL VAL COB MANUEL. Consejero: MU脩OZ SANCHEZ LORENZO. Secretario: MU脩OZ SANCHEZLORENZO. Consejero: SUAREZ ALMAZOR RAFAEL DIEGO. Cons.Del.Man: SUAREZ ALMAZOR RAFAEL DIEGO. Consejero:HURTADO ZAPICO JUAN. Cons.Del.Man: HURTADO ZAPICO JUAN. Consejero: SASTRE PEREZ JOSE MANUEL;ZABARACARRASCO ANDRES;MORALES MOTOS MIGUEL;BUSTINDUY BATALLA MARCIAL;GARCIA MOLINA FRANCISCO;PALACIOSGIL PABLO. Datos registrales. T 27313 , F 216, S 8, H M 492171, I/A 2 ( 4.06.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n