Buscador CIF Logo

Actos BORME San Juan De Las Nieves Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera San Juan De Las Nieves Sl

Actos BORME San Juan De Las Nieves Sl - B28322147

Tenemos registrados 7 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para San Juan De Las Nieves Sl con CIF B28322147

馃敊 Perfil de San Juan De Las Nieves Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de San Juan De Las Nieves Sl

05 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUIRALTE ABELLO NIEVES;QUIRALTE ABELLO ALVARO LUIS;QUIRALTE ABELLO SILVIAPALMIRA;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID;QUIRALTE ABELLO PABLO;QUIRALTE ABELLO BLAS IGNACIOPresidente:QUIRALTE ABELLO SILVIA PALMIRA. Secretario: QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE. Revocaciones. Apoderado: QUIRALTEABELLO PABLO;QUIRALTE ABELLO JORGE;CAMPO CAMPO LORENZO TOMAS;QUIRALTE ABELLO MARIA NIEVES;QUIRALTEABELLO PALMIRA SILVIA;QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID;QUIRALTE ABELLO BLASIGNACIO;QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID;QUIRALTE ABELLO ENRIQUE DOMINGO.Apo.Sol.: QUIRALTE ABELLO BLAS IGNACIO;QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID. Escisi贸ntotal. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: A脩AVETE SL. LAIROCSE SOCIEDAD LIMITADA. SOCITELLO SL. APODACAINVERSIONES INMOBILIARIAS SA. ALJIBESLLANOS SL. Disoluci贸n. Escision. Extinci贸n. Datos registrales. T 20609 , F 150, S8, H M 92175, I/A 22 (27.02.20).

29 de Octubre de 2014
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. ACTIVIDADES DE HOSTELERIATALES COMO HOTELES Y ALOJAMIENTOS SIMILARES, ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y OTROS ALOJAMIENTOS DE CORTAESTANCIA, RESTAURANTES, PROVISION DE COMIDAS PREPARADAS PARA EVENTOS Y OTROS SERVICIOS DE COMIDAS YESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS.- Datos registrales. T 20609 , F 149, S 8, H M 92175, I/A 21 (21.10.14).

20 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUIRALTE ABELLO ENRIQUE. Nombramientos. Apo.Sol.: QUIRALTE ABELLO BLASIGNACIO;QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID. Datos registrales. T 20609 , F 149, S 8, H M92175, I/A 20 (12.06.14).

05 de Mayo de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 30,00 Euros. Resultante Suscrito: 930.708,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital:184.260,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.114.968,00 Euros. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 8 DE LOSESTATUTOS SOCIALES EN RELACION A LA REMUNERACION DE LOS ADMINISTRADORES.. Datos registrales. T 20609 , F148, S 8, H M 92175, I/A 19 (23.04.14).

05 de Enero de 2011
Nombramientos. Apoderado: QUIRALTE ABELLO ENRIQUE DOMINGO. Datos registrales. T 20609 , F 147, S 8, H M 92175, I/A18 (27.12.10).

06 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: QUIRALTE ABELLO ENRIQUE. Consejero: ABELLO GALLO NIEVES. Secretario: QUIRALTEABELLO SILVIA PALMIRA. Cons.Del.Sol: ABELLO GALLO NIEVES. Nombramientos. Presidente: QUIRALTE ABELLO SILVIAPALMIRA. Secretario: QUIRALTE ABELLO PABLO-JOSE. Apoderado: QUIRALTE ABELLO BLAS IGNACIO;QUIRALTE ABELLOPABLO-JOSE;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID. Reelecciones. Consejero: QUIRALTE ABELLO NIEVES;QUIRALTE ABELLOENRIQUE;QUIRALTE ABELLO ALVARO LUIS;QUIRALTE ABELLO SILVIA PALMIRA;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID;QUIRALTEABELLO PABLO;QUIRALTE ABELLO BLAS IGNACIO. Cambio de domicilio social. C/ PONZANO 76 (MADRID). Datosregistrales. T 20609 , F 145, S 8, H M 92175, I/A 17 (27.07.10).

02 de Abril de 2009
Nombramientos. Apoderado: QUIRALTE ABELLO MARIA NIEVES;QUIRALTE ABELLO PALMIRA SILVIA;QUIRALTE ABELLOPABLO-JOSE;QUIRALTE ABELLO JORGE-DAVID. Datos registrales. T 20609 , F 143, S 8, H M 92175, I/A 16 (23.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n