Actos BORME de San Pablo Motor Sl
04 de Agosto de 2023Revocaciones. Apoderado: MESA NAVARRO GUSTAVO. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ IBAÑEZ JESUS. Datosregistrales. T 6542 , F 19, S 8, H SE 24139, I/A 61 (27.07.23).
22 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: C Y O CONSULTORES Y AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6542 , F 18, S 8, H SE 24139, I/A 59(14.11.22).
03 de Febrero de 2021Reelecciones. Auditor: C Y O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P. Datos registrales. T 6542 , F 17, S 8, H SE 24139, I/A 57(25.01.21).
19 de Enero de 2021Ampliación de capital. Capital: 749.772,45 Euros. Resultante Suscrito: 1.050.282,45 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículode los estatutos: 5. Capital social.-. Datos registrales. T 6542 , F 17, S 8, H SE 24139, I/A 56 (12.01.21).
28 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BORRAS MARTIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 6542 , F 16, S 8, H SE 24139, I/A 55(17.12.20).
15 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO. Nombramientos. Apoderado: MESA NAVARRO GUSTAVO.Otros conceptos: REVOCADOS TODOS los poderes conferidos por la sociedad a favor de don Pablo Rodríguez Rodríguez, tanto losinscritos como los posibles otorgados y no inscritos.- Datos registrales. T 6542 , F 15, S 8, H SE 24139, I/A 54 ( 4.12.20).
14 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apoderado: BAUTISTA PEREZ RAMON MANUEL. Datos registrales. T 6542 , F 15, S 8, H SE 24139, I/A 53 (3.12.20).
28 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: BORRAS MARTIN JOSE MARIA. Datos registrales. T 6542 , F 13, S 8, H SE 24139, I/A 52(19.11.19).
18 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MARTINEZ MEJIAS GARCIA DEL CID JOSE JOAQUIN;VILLAGRAN DE CARDENAS MANUEL.Vicepresid.: YBARRA MENDARO IGNACIO. Cons.Del.Sol: YBARRA MENDARO IGNACIO. Consejero: DELGADO DE COS CHOZASALFREDO;ESCRIBANO IVISON JOSE MARIA;ROCA DE TOGORES Y PEREZ DE GUZMAN MANUEL. Secretario: MORA CARAZOJUAN CARLOS. Consejero: YBARRA MENDARO IGNACIO;VILLAGRAN DE CARDENAS MANUEL;MORA CARAZO JUANCARLOS;MARTINEZ MEJIAS GARCIA DEL CID JOSE JOAQUIN;GONZALO DE BUSTOS FERNANDO;OSBORNE BORESEDUARDO;YBARRA OSBORNE FELIPE. Presidente: ROCA DE TOGORES Y PEREZ DE GUZMAN MANUEL. Cons.Del.Sol: ROCADE TOGORES Y PEREZ DE GUZMAN MANUEL. Vicepresid.: ESCRIBANO IVISON JOSE MARIA. Cons.Del.Sol: GONZALO DEBUSTOS FERNANDO. Consejero: ALVEAR ALMUNIA CRISTOBAL. Nombramientos. Adm. Solid.: COMERCIAL AUTOTRACTORSA;NITA SL. Auditor: C Y O CONSULTORES Y AUDITORES S.L.P. Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio:31/12. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios. Datosregistrales. T 4005 , F 61, S 8, H SE 24139, I/A 49 ( 7.05.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ESCRIBANO DEL CASTILLO CLARA MARIA;ZAMBRANOSANCHEZ MANUELA. Datos registrales. T 6542 , F 12, S 8, H SE 24139, I/A 50 ( 9.05.18).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO. Datos registrales. T 6542 , F 13, S 8, H SE 24139, I/A 51(10.05.18).
22 de Febrero de 2018Revocaciones. Apoderado: CRISTOBAL DE ALVEAR ZAMBRANO;GARCIA NIETO FRANCISCO;COSTILLA PURO ANGEL.Apo.Sol.: COSTILLA PURO ANGEL. Apoderado: ALFREDO DELGADO DE COS CHOZA;CALVO CREHUET PEDRO;JIMENEZPLANAS ESTEBAN. Apo.Sol.: LANCHA LANCHA JOSE MARIA;COSTILLA PURO ANGEL;ALFREDO DELGADO DE COS CHOZA.Apo.Manc.: LANCHA LANCHA JOSE MARIA;COSTILLA PURO ANGEL;ALFREDO DELGADO DE COS CHOZA. Apoderado: CALVOCREHUET PEDRO;VARELA GONZALEZ MARIA TERESA. Apo.Manc.: ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE;ESCRIBANO CASTILLOCLARA MARIA;ESCRIBANO CASTILLO CLARA MARIA;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE;COSTILLA PURO ANGEL. Apoderado:CORDERO ANDRADE JOSE ALFONSO. Apo.Sol.: ALVAREZ VAZQUEZ LUIS JAVIER. Apo.Manc.: COSTILLA PUROANGEL;LANCHA LANCHA JOSE MARIA;ESCRIBANO CASTILLO CLARA MARIA;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE;MORALESMORENO IGNACIO JAVIER. Apo.Sol.: MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE. Apoderado:RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO. Datos registrales. T 4005 , F 60, S 8, H SE 24139, I/A 48 (14.02.18).
15 de Septiembre de 2015Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 4005 , F 60, S 8, H SE 24139, I/A 47 ( 3.09.15).
24 de Abril de 2015Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO. Datos registrales. T 4005 , F 60, S 8, H SE 24139, I/A 46(15.04.15).
07 de Julio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: ESCRIBANO CASTILLO CLARA MARIA;MORALES MORENO IGNACIO JAVIER;ALVEAR ALMUNIAGUADALUPE. Datos registrales. T 4005 , F 59, S 8, H SE 24139, I/A 45 (26.06.14).
05 de Marzo de 2014Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 3º: Domicilio.-. Cambio de domicilio social. CTRA DE SUEMINENCIA 26 (SEVILLA). Datos registrales. T 4005 , F 59, S 8, H SE 24139, I/A 44 (24.02.14).
18 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: COSTILLA PURO ANGEL;LANCHA LANCHA JOSE MARIA;ESCRIBANO CASTILLO CLARAMARIA;ALVEAR ALMUNIA GUADALUPE;MORALES MORENO IGNACIO JAVIER. Datos registrales. T 4005 , F 58, S 8, H SE24139, I/A 42 ( 6.09.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ VAZQUEZ LUIS JAVIER. Datos registrales. T 4005 , F 58, S 8, H SE 24139, I/A 43 ( 6.09.13).
12 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apo.Sol.: NUÑEZ ALVAREZ ANTONIO. Apo.Manc.: NUÑEZ ALVAREZ ANTONIO;NUÑEZ ALVAREZ ANTONIO.Otros conceptos: La Sociedad REVOCA el PODER NO INSCRITO, conferido a favor de DON ANTONIO NUÑEZ ALVAREZ, envirtud de escritura autorizada en Sevilla, el día 3 de enero de 2.006, por el Notario Don Joaquín Serrano Valverde, bajo el número 9 desu protocolo.La Sociedad REVOCA el PODER NO INSCRITO, conferido a favor de DON ANTONIO NUÑEZ ALVAREZ, en virtud deescritura autorizada en Sevilla, el día 5 de mayo de 1.998, por el Notario Don Rafael Leña Fernández, bajo el número 1.472 de suprotocolo. Datos registrales. T 4005 , F 57, S 8, H SE 24139, I/A 41 (29.08.13).
13 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 4005 , F 57, S 8, H SE 24139, I/A 40 ( 3.12.12).
07 de Octubre de 2009Reelecciones. Auditor: AUDITORIA Y CONSULTA SA. Datos registrales. T 4005 , F 57, S 8, H SE 24139, I/A 39 (23.09.09).