Actos BORME de Sanea Tratamiento De Residuos Sl
16 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CORPORACIO GRI脩O SL. Socio 煤nico: GRI脩O ECOLOGIC SL. Revocaciones. Apoderado:CARRO GARCIA CESAR;DE BARTOLOME ESTEVEZ MIGUEL JUAN;ENFEDAQUE GONZALVO RICARDO;MICO FERNANDEZLUIS;ITURBE RECASENS FERNANDO;SANCHEZ TOLEDO SALVADOR;PALACIN ELTORO JOAQUIN;GARCIA ARROYO LUISA.;FERNANDEZ IZCO DAVID;SALANOVA SANET ALBERT. Apo.Manc.: BANZO RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO;CASTELLO BAROMONTSERRAT. Apo.Sol.: ITURBE RECASENS FERNANDO;MICO FERNANDEZ LUIS. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datosregistrales. T 594 , F 85, S 8, H L 10910, I/A 23 (31.05.11).
07 de Febrero de 2011Cambio de objeto social. La Sociedad tiene por objeto social la realizaci贸n en Espa帽a, o cualquier otro pa铆s del mundo, de lassiguientes actividades: a) La promoci贸n, construcci贸n y explotaci贸n de todo tipo de instalaci贸n de gesti贸n de residuos y tratamiento deaguas. b) La prestaci贸n de servicios de tratamiento, depuraci贸. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: AGROSCA SL.CENTRE D'INTEGRACIO ORGANICA SL. Datos registrales. T 594 , F 81, S 8, H L 10910, I/A 22 (25.01.11).
20 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: SALANOVA SANET ALBERT. Datos registrales. T 594 , F 34, S 8, H L 10910, I/A 21 (10.01.11).
26 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: PALACIN ELTORO JOAQUIN. Datos registrales. T 590 , F 132, S 8, H L 10910, I/A 17 (15.07.10).
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ TOLEDO SALVADOR. Datos registrales. T 590 , F 195, S 8, H L 10910, I/A 18 (15.07.10).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ARROYO LUIS A. Datos registrales. T 592 , F 52, S 8, H L 10910, I/A 19 (15.07.10).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ IZCO DAVID. Datos registrales. T 594 , F 10, S 8, H L 10910, I/A 20 (15.07.10).
23 de Junio de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: CASTELLO BARO MONTSERRAT;BANZO RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO. Datos registrales. T584 , F 170, S 8, H L 10910, I/A 11 (11.06.10).
Nombramientos. Apoderado: ITURBE RECASENS FERNANDO. Datos registrales. T 584 , F 173, S 8, H L 10910, I/A 12(11.06.10).
Nombramientos. Apoderado: MICO FERNANDEZ LUIS. Datos registrales. T 584 , F 198, S 8, H L 10910, I/A 13 (11.06.10).
Nombramientos. Apoderado: ENFEDAQUE GONZALVO RICARDO. Datos registrales. T 586 , F 136, S 8, H L 10910, I/A 14(11.06.10).
Nombramientos. Apoderado: DE BARTOLOME ESTEVEZ MIGUEL JUAN. Datos registrales. T 588 , F 85, S 8, H L 10910, I/A 15(11.06.10).
Nombramientos. Apoderado: CARRO GARCIA CESAR. Datos registrales. T 588 , F 87, S 8, H L 10910, I/A 16 (11.06.10).
02 de Noviembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.560,00 Euros. Resultante Suscrito: 373.760,00 Euros. Datos registrales. T 584 , F 169, S 8, H L10910, I/A 10 (22.10.09).
28 de Octubre de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 80.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 365.200,00 Euros. Datos registrales. T 584 , F 158, S 8, H L10910, I/A 9 (19.10.09).
06 de Marzo de 2009Nombramientos. Auditor: ABGL SL. Datos registrales. T 584 , F 158, S 8, H L 10910, I/A 8 (24.02.09).