Buscador CIF Logo

Actos BORME Santander Issuances Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Santander Issuances Sa

Actos BORME Santander Issuances Sa - A83916387

Tenemos registrados 38 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Santander Issuances Sa con CIF A83916387

馃敊 Perfil de Santander Issuances Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Santander Issuances Sa

07 de Febrero de 2018
Otros conceptos: COMUNICACION DEL REGISTRO MERCANTIL DE SANTANDER DE 3 DE ENERO DE 2018 DE HABER SIDOINSCRITA LA ABSORBCION DE LA SOCIEDAD POR LA DOMICILIADA ALLI "BANCO SANTANDER SA", QUEDANDOCANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS PRACTICADOS DE ESTA HOJA Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL. Extinci贸n. Datosregistrales. T 34842 , F 38, S 8, H M 347561, I/A 67 (29.01.18).

05 de Enero de 2018
Otros conceptos: Nota marginal de cierre provisional de la hoja registral, por plazo de seis meses, de conformidad con lo

31 de Marzo de 2017
Emisi贸n de obligaciones. Comisario: CORONEL DE PALMA Y MARTINEZ AGULLO LUIS. Importe de la emisi贸n: 50.000.000,00Euros. 24.03.17. Datos registrales. T 34842 , F 34, S 8, H M 347561, I/A 66 (24.03.17).

25 de Enero de 2017
Emisi贸n de obligaciones. Comisario: CORONEL DE PALMA Y MARTINEZ AGULLO LUIS. Importe de la emisi贸n: 1.000.000.000,00Euros. 19.01.17. Datos registrales. T 34842 , F 30, S 8, H M 347561, I/A 65 (17.01.17).

05 de Enero de 2017
Nombramientos. Comisario: CORONEL DE PALMA Y MARTINEZ AGULLO LUIS. Emisi贸n de obligaciones. Comisario:CORONEL DE PALMA Y MARTINEZ AGULLO LUIS. Importe de la emisi贸n: 50.000.000,00 Euros. 29.12.16. Datos registrales. T34842 , F 27, S 8, H M 347561, I/A 64 (28.12.16).

09 de Diciembre de 2016
Emisi贸n de obligaciones. Comisario: MERINO MERCHAN JESUS. Importe de la emisi贸n: 60.000.000,00 Euros. 1.12.16. Datosregistrales. T 34842 , F 16, S 8, H M 347561, I/A 61 (29.11.16).

Otros conceptos: EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS SERIE 33, CON VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2026, Y FECHADE DESEMBOLSO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR IMPORTE DE 200.000.000 DOLARES ESTADOUNIDENSES. Datosregistrales. T 34842 , F 20, S 8, H M 347561, I/A 62 (29.11.16).

Otros conceptos: EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS SERIE 34, CON VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2026, Y FECHADE DESEMBOLSO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR IMPORTE DE 50.000.000 DOLARES ESTADOUNIDENSES. Datosregistrales. T 34842 , F 23, S 8, H M 347561, I/A 63 (29.11.16).

26 de Octubre de 2016
Otros conceptos: OBLIGACIONES SUBORDINADAS SERIE 32, TIPO DE INTERES FIJO, CON VENCIMIENTO OCTUBRE 2026,CON FECHA DE DESEMBOLSO EL 19 DE OCTUBRE DE 2016, POR IMPORTE DE TRESCIENTOS MILLONES DE DOLARESESTADOUNIDENSES (300.000.000-USD) Y EL COMISARIO DEL SINDICATO DON JESUS MERINO MERCHAN. Datos registrales.T 34842 , F 13, S 8, H M 347561, I/A 60 (18.10.16).

27 de Septiembre de 2016
Emisi贸n de obligaciones. Comisario: MERINO MERCHAN JESUS. Importe de la emisi贸n: 0,00 Euros. 20.09.16. Otros conceptos:EL IMPORTE NOMINAL DE LA EMISION ES DE 140.000.000 DOLARES ESTADOUNIDENSES. Datos registrales. T 34842 , F 8, S8, H M 347561, I/A 59 (19.09.16).

29 de Agosto de 2016
Otros conceptos: OBLIGACIONES SUBORDINADAS SERIE 29, TIPO DE INTERES FIJO, CON VTO 23 DE AGOSTO DE 2026,CON FECHA DE DESEMBOLSO EL 23 DE AGOSTO Y EL 23 DE FEBRERO DE CADA A脩O , POR IMPORTE DE (5.100.000.000,-JPY) Y EL COMISARIO DEL SINDICATO DON JESUS MERINO MERCHAN. Datos registrales. T 34842 , F 5, S 8, H M 347561, I/A57 (22.08.16).

01 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Secretario: BUTRAGUE脩O RODRIGUEZ BORLADO NATALIA. Nombramientos. SecreNoConsj: OTEROROMERO EDUARDO. Datos registrales. T 34842 , F 4, S 8, H M 347561, I/A 56 (21.07.16).

14 de Julio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ VARONA MARIA VISITACION. Nombramientos. Consejero: URIGOEN IRUSTA JUAN.Reelecciones. Consejero: ROIG GARCIA BERNALT PABLO. Datos registrales. T 34842 , F 4, S 8, H M 347561, I/A 55 ( 6.07.16).

15 de Junio de 2016
Otros conceptos: OBLIGACIONES SUBORDINADAS SERIE 28, TIPO DE INTERES FIJO, CON VENCIMIENTO JUNIO 2026, CONFECHA DE DESEMBOLSO EL 8 DE JUNIO DE 2016, POR IMPORTE DE CINCO MIL MILLONES DE YENES JAPONESES(5.000.000.000,-JPY) Y EL COMISARIO DEL SINDICATO DON JESUS MERINO MERCHAN. Datos registrales. T 22599 , F 218, S8, H M 347561, I/A 54 ( 7.06.16).

01 de Junio de 2016
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 22599 , F 218, S 8, H M 347561,I/A 53 (24.05.16).

10 de Mayo de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22599 , F 218, S 8, H M 347561, I/A 52 (29.04.16).

11 de Abril de 2016
Emisi贸n de obligaciones. Comisario: MERINO MERCHAN JESUS. Importe de la emisi贸n: 1.500.000.000,00 Euros. 4.04.16. Datosregistrales. T 22599 , F 214, S 8, H M 347561, I/A 51 ( 1.04.16).

26 de Enero de 2016
Otros conceptos: CIERRE DE LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS SANTANDER ISSUANCES SAU SERIE 26,POR IMPORTE DE 1.500.000.000 DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. Datos registrales. T 22599 , F 214, S 8, H M 347561,I/A 50 (18.01.16).

26 de Noviembre de 2015
Otros conceptos: OBLIGACIONES SUBORDINADAS SERIE 26, CON VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2025, Y FECHA DEDESEMBOLSO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR IMPORTE DE MIL QUINIENTOS MILLONES DE DOLARES DE LOSESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Datos registrales. T 22599 , F 211, S 8, H M 347561, I/A 49 (18.11.15).

14 de Julio de 2015
Reelecciones. Consejero: DIAZ VARONA MARIA VISITACION. Datos registrales. T 22599 , F 211, S 8, H M 347561, I/A 47 (6.07.15).

Reelecciones. Consejero: SOLER RAMOS JOSE ANTONIO. Presidente: SOLER RAMOS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T22599 , F 211, S 8, H M 347561, I/A 48 ( 6.07.15).

26 de Marzo de 2015
Emisi贸n de obligaciones. Comisario: MERINO MERCHAN JESUS. Importe de la emisi贸n: 1.500.000.000,00 Euros. 18.03.15. Datosregistrales. T 22599 , F 206, S 8, H M 347561, I/A 46 (16.03.15).

15 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22599 , F 206, S 8, H M 347561, I/A 45 ( 8.10.14).

29 de Septiembre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22599 , F 206, S 8, H M 347561, I/A 44 (19.09.14).

06 de Marzo de 2014
Reelecciones. Consejero: TORIO MARTIN ANTONIO. Datos registrales. T 22599 , F 206, S 8, H M 347561, I/A 43 (26.02.14).

24 de Julio de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22599 , F 205, S 8, H M 347561, I/A 42 (17.07.13).

07 de Junio de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22599 , F 205, S 8, H M 347561, I/A 41 (28.05.12).

06 de Junio de 2012
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL;DELOITTE SL;DELOITTE SL;DELOITTE SL.Datos registrales. T 22599 , F 205, S 8, H M 347561, I/A 40 (25.05.12).

26 de Octubre de 2011
Reelecciones. Consejero: ROIG GARCIA BERNALT PABLO. Datos registrales. T 22599 , F 204, S 8, H M 347561, I/A 39(13.10.11).

19 de Octubre de 2010
Ceses/Dimisiones. Comisario: MERINO MERCHAN JESUS. Otros conceptos: CANCELADA TOTALMENTE LA EMISION DEOBLIGACIONES DENOMINADA "OBLIGACIONES SUBORDINADAS SANTANDER ISSUANCES SA UNIPERSONAL SERIE 2 CONVENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2014". Datos registrales. T 22599 , F 204, S 8, H M 347561, I/A 38 ( 6.10.10).

02 de Agosto de 2010
Otros conceptos: MODIFICADAS LAS CONDICIONES FINALES DE LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS SERIE 17,VENCIMIENTO FINAL JULIO DE 2022. Datos registrales. T 22599 , F 204, S 8, H M 347561, I/A 37 (21.07.10).

27 de Julio de 2010
Reelecciones. Consejero: SOLER RAMOS JOSE ANTONIO. Presidente: SOLER RAMOS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T22599 , F 204, S 8, H M 347561, I/A 36 (16.07.10).

12 de Noviembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTON SAN PABLO JAVIER. Nombramientos. Consejero: DIAZ VARONA MARIA VISITACION.Datos registrales. T 22599 , F 103, S 8, H M 347561, I/A 35 ( 2.11.09).

20 de Agosto de 2009
Nombramientos. Comisario: MERINO MERCHAN JESUS. Otros conceptos: EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADASSERIE 22, TIPO DE INTERES FIJO A VARIABLE, CON OPCION DE VTO ANTICIPADO Y VTO FINAL EN AGOSTO DE 2019; PORIMPORTE DE 257.500.000 DOLARES AMERICANOS. Datos registrales. T 22599 , F 193, S 8, H M 347561, I/A 33 (10.08.09).

Nombramientos. Comisario: MERINO MERCHAN JESUS. Otros conceptos: EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADASSERIE 24 TRAMO 2, TIPODE INTERES FIJO A VARIABLE, CON OPCION DE VTO ANTICIPADO Y VTO FINAL EN JULIO DE 2019;POR IMPORTE DE 131.250.000 LIBRAS ESTERLINAS. Datos registrales. T 22599 , F 198, S 8, H M 347561, I/A 34 (10.08.09).

05 de Agosto de 2009
Emisi贸n de obligaciones. Comisario: MERINO MERCHAN JESUS. Importe de la emisi贸n: 449.250.000,00 Euros. 27.07.09. Datosregistrales. T 22599 , F 182, S 8, H M 347561, I/A 31 (27.07.09).

Otros conceptos: EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS SERIE 24 TRAMO 1, TIPODE INTERES FIJO A VARIABLE,CON OPCION DE VTO ANTICIPADO Y VTO FINAL EN JULIO DE 2019; POR IMPORTE DE 712.100.000 LIBRAS ESTERLINAS.Datos registrales. T 22599 , F 187, S 8, H M 347561, I/A 32 (27.07.09).

15 de Julio de 2009
Reelecciones. Consejero: TORIO MARTIN ANTONIO. Datos registrales. T 22599 , F 182, S 8, H M 347561, I/A 30 ( 3.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n