Actos BORME de Sarfa Sl
04 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apo.Manc.: ENRIQUE JOSE GIMENO ARAGONES;MARIA DOLORES PUIGNAU LINARES. Datos registrales. T2935 , F 109, S 8, H GI 25923, I/A 31 (28.11.23).
21 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2935 , F 109, S 8, H GI 25923, I/A 30 (15.11.23).
14 de Febrero de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: TRANSGRUP XXI S.L.U. Datos registrales. T 2935 , F 109, S 8, HGI 25923, I/A 29 ( 8.02.23).
11 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2935 , F 109, S 8, H GI 25923, I/A 28 ( 2.12.20).
19 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: ENRIQUE JOSE GIMENO ARAGONES;MARIA DOLORES PUIGNAU LINARES. Datos registrales. T2935 , F 108, S 8, H GI 25923, I/A 27 (11.12.18).
09 de Febrero de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2935 , F 108, S 8, H GI 25923, I/A 26 ( 2.02.18).
18 de Enero de 2018Declaración de unipersonalidad. Socio único: MARFINA SL. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Apo.Manc.: ENRIQUEJOSE GIMENO ARAGONES;MARIA DOLORES PUIGNAU LINARES. Datos registrales. T 2935 , F 108, S 8, H GI 25923, I/A 25(11.01.18).
23 de Marzo de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2935 , F 108, S 8, H GI 25923, I/A 24 (12.03.15).
18 de Febrero de 2014Fe de erratas: En el Boletín 18 de fecha 28/01/14 se publicó por error en la escritura el nombramiento como apoderada de la Sra.María Dolores Linares Puignau, cuando en realidad su nombre correcto y rectificado mediante diligencia es MARIA DOLORESPUIGNAU LINARES. Datos registrales. T 1786 , F 154, S 8, H GI 25923, I/A NM.1 ( 7.02.14).
28 de Enero de 2014Cancelaciones de oficio de nombramientos. Apo.Manc.: MIGUEL ANGEL SALAS ARAGUAS;JULIO HERNAIZ OLIAS. Apoderado:JULIO HERNAIZ OLIAS. Nombramientos. Apo.Manc.: ENRIQUE JOSE GIMENO ARAGONES;MARIA DOLORES LINARESPUIGNAU. Datos registrales. T 1786 , F 154, S 8, H GI 25923, I/A 23 (21.01.14).
17 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1786 , F 154, S 8, H GI 25923, I/A 22 ( 7.11.11).
29 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOSE LUIS PINO MORENO. Datos registrales. T 1786 , F 154, S 8, H GI 25923, I/A 21 (16.11.10).
21 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Presidente: MIQUEL MARTI CARCELLER. Vicepresid.: MIQUEL MARTI ESCURSELL. Secretario: JOSEP MARIAMARTI ESCURSELL. Nombramientos. Adm. Unico: MARFINA SL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 1786 , F 152, S 8, H GI 25923, I/A 18(12.08.09).
Nombramientos. Apoderado: MIQUEL MARTI ESCURSELL. Datos registrales. T 1786 , F 152, S 8, H GI 25923, I/A 19 (12.08.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: MIGUEL PEDRO COSTA RAMIREZ;NAIARA BUENO AYBAR;AINARA ANTON ARAGON;BLANCAEMMA GONZALEZ BANCHS. Datos registrales. T 1786 , F 154, S 8, H GI 25923, I/A 20 (12.08.09).
28 de Enero de 2009Cambio de domicilio social. C/ MAS RESPLANDIS 6 (BEGUR). Datos registrales. T 1786 , F 151, S 8, H GI 25923, I/A 15(19.01.09).
Nombramientos. Apo.Manc.: ENRIQUE JOSE GIMENO ARAGONES;MARIA DOLORES LINARES PUIGNAU. Datos registrales. T1786 , F 151, S 8, H GI 25923, I/A 16 (19.01.09).
Revocaciones. Apo.Manc.: ENRIQUE JOSE GIMENO ARAGONES;ROGELIO OLIVA GASULL. Datos registrales. T 1786 , F 152, S8, H GI 25923, I/A 17 (19.01.09).