Buscador CIF Logo

Actos BORME Savor Ediciones Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Savor Ediciones Sa

Actos BORME Savor Ediciones Sa - A58407313

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Savor Ediciones Sa con CIF A58407313

馃敊 Perfil de Savor Ediciones Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Savor Ediciones Sa

23 de Marzo de 2021
Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO838/2017, AUTO FIRME DE FECHA 09/02/2021, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Extinci贸n.Datos registrales. T 41001 , F 168, S 8, H B 61780, I/A 42 (15.03.21).

22 de Mayo de 2019
Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO838/2017, AUTO FIRME DE FECHA 12/09/2018, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LASOCIEDAD. Datos registrales. T 41001 , F 167, S 8, H B 61780, I/A 41 (15.05.19).

16 de Agosto de 2018
Revocaciones. CONSEJERO: ESCOLA HERRERO JOSE. PRESIDENTE: ESCOLA HERRERO JOSE. CONSEJERO: SERRACAROL AGUSTIN;FOLCH FRANCO RAMON;PEREZ DE BRI脩AS CARLOS. CONS. DELEG.: ESCOLA HERRERO JOSE. Otrosconceptos: JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 838/2017, DECRETOFIRME DE FECHA 05/06/2018, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. Disoluci贸n. Judicial. Datosregistrales. T 41001 , F 167, S 8, H B 61780, I/A 40 ( 8.08.18).

23 de Mayo de 2018
Revocaciones. SECRETARIO: SERRA CAROL AGUSTIN. Datos registrales. T 41001 , F 167, S 8, H B 61780, I/A 39 (16.05.18).

23 de Enero de 2018
Nombramientos. ADM.CONCURS.: MM ABOGADOS PARTNERSHIP SLP. REP.ADM.CONC: HERNANDEZ MONTES MARIANO.Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO838/2017, AUTO FIRME DE FECHA 15/12/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Datosregistrales. T 41001 , F 166, S 8, H B 61780, I/A 38 (16.01.18).

20 de Mayo de 2015
Revocaciones. SECRETARIO: MARROQUIN SAGALES JUAN. Nombramientos. SECRETARIO: SERRA CAROL AGUSTIN.Datos registrales. T 41001 , F 165, S 8, H B 61780, I/A 36 (12.05.15).

Revocaciones. CONSEJERO: MARROQUIN SAGALES JUAN. Datos registrales. T 41001 , F 166, S 8, H B 61780, I/A 37(12.05.15).

15 de Octubre de 2014
Nombramientos. CONSEJERO: ESCOLA HERRERO JOSE. PRESIDENTE: ESCOLA HERRERO JOSE. CONSEJERO:MARROQUIN SAGALES JUAN. SECRETARIO: MARROQUIN SAGALES JUAN. CONSEJERO: SERRA CAROL AGUSTIN;FOLCHFRANCO RAMON;PEREZ DE BRI脩AS CARLOS. CONS. DELEG.: ESCOLA HERRERO JOSE. Datos registrales. T 41001 , F 165, S8, H B 61780, I/A 35 ( 7.10.14).

30 de Noviembre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 30.001,92 Euros. Desembolsado: 30.001,92 Euros. Resultante Suscrito: 2.045.587,64 Euros.Resultante Desembolsado: 2.045.587,64 Euros. Datos registrales. T 41001 , F 165, S 8, H B 61780, I/A 34 (19.11.12).

02 de Noviembre de 2012
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 800.003,12 Euros. Desembolsado: 800.003,12 Euros. Resultante Suscrito: 2.015.585,72 Euros.Resultante Desembolsado: 2.015.585,72 Euros. Datos registrales. T 41001 , F 164, S 8, H B 61780, I/A 33 (23.10.12).

09 de Enero de 2012
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PARES AUDITORES SLP. Datos registrales. T 41001 , F 163, S 8, H B 61780, I/A 32 (28.12.11).

29 de Noviembre de 2011
Revocaciones. APODERADO: RASCON PASTOR SANTOS. Datos registrales. T 41001 , F 163, S 8, H B 61780, I/A 31 (17.11.11).

26 de Mayo de 2010
Nombramientos. APODERADO: FOLCH FRANCO RAMON;ESCOLA HERRERO JOSE;SERRA CAROL AGUSTIN;PEREZ LOPEZDE BRI脩AS CARLOS. Otros conceptos: RECTIFICADA LA INSCRIPCION 25, PUBLICADA EN EL BORME 9/2009, REFERENCIA20466, POR CUANTO SE CONSIGNO ERRONEAMENTE EL APELLIDO DE DON CARLOS PEREZ DE BRI脩AS, SIENDO ELCORRECTO DON CARLOS PEREZ LOPEZ DE BRI脩AS. Datos registrales. T 41001 , F 161, S 8, H B 61780, I/A 30 (14.05.10).

04 de Marzo de 2009
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 532.486,00 Euros. Desembolsado: 532.486,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.215.582,60 Euros.Resultante Desembolsado: 1.215.582,60 Euros. Datos registrales. T 41001 , F 161, S 8, H B 61780, I/A 29 (20.02.09).

20 de Febrero de 2009
Nombramientos. APODERADO: HERRERO GIMENEZ JOAN. Datos registrales. T 34056 , F 48, S 8, H B 61780, I/A 26 (10.02.09).

Nombramientos. APODERADO: ESCOLA HERRERO JOSE;FOLCH FRANCO RAMON;SERRA CAROL AGUSTIN. Datosregistrales. T 34056 , F 49, S 8, H B 61780, I/A 27 (10.02.09).

Revocaciones. AUDIT.CUENT.: DELOITTE AND TOUCHE ESPA脩A SL. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PARES AUDITORESSL. Datos registrales. T 34056 , F 50, S 8, H B 61780, I/A 28 (10.02.09).

27 de Enero de 2009
Cancelaciones de oficio de nombramientos. ADM.CONJUNTO: GABARRO AURELL ALBERTO. Datos registrales. T 34056 , F41, S 8, H B 61780, I/A 17 N ( 2.01.09).

15 de Enero de 2009
Revocaciones. APODERADO: SERRA CAROL AGUSTIN;BLANCO LUCAS ADOLFO;SERRA CAROL AGUSTIN;REIXAC BELTRANEDUARD;ESCOLA HERRERO JOSE;SERRA CAROL AGUSTIN;FOLCH FRANCO RAMON;HERRERO JIMENEZ JOAN.ADM.CONJUNTO: ESCOLA HERRERO JOSE. APODERADO: RIGAU ABAD JORDI. Nombramientos. CONSEJERO: ESCOLAHERRERO JOSE. PRESIDENTE: ESCOLA HERRERO JOSE. CONS. DELEG.: ESCOLA HERRERO JOSE. CONSEJERO:MARROQUIN SAGALES JUAN. SECRETARIO: MARROQUIN SAGALES JUAN. CONSEJERO: SERRA CAROL AGUSTIN;FOLCHFRANCO RAMON;PEREZ DE BRI脩AS CARLOS. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOSESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 34056 , F 45, S 8, H B 61780, I/A 25 (2.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n