Actos BORME de Saybo Sl
22 de Noviembre de 2021Cambio de domicilio social. AV PEDRALBES Num.54 P.5 PTA.2 (BARCELONA). Datos registrales. T 43004 , F 53, S 8, H B90793, I/A 19 (15.11.21).
07 de Diciembre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 128.614,00 Euros. Resultante Suscrito: 502.646,35 Euros. Modificaciones estatutarias.ARTICULO 9 BIS.-RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 43004 , F 52, S 8, H B 90793, I/A 18(29.11.18).
16 de Mayo de 2012Revocaciones. CONSEJERO: BOFILL MONTORO ANA MARIA. PRESIDENTE: BOFILL MONTORO ANA MARIA. CONS. DELEG.:BOFILL MONTORO ANA MARIA. CONSEJERO: SASTRE BOFILL ANA. SECRETARIO: SASTRE BOFILL ANA. CONSEJERO:SASTRE BOFILL JORDI. Nombramientos. CONSEJERO: BOFILL MONTORO ANA MARIA. PRESIDENTE: BOFILL MONTOROANA MARIA. CONS. DELEG.: BOFILL MONTORO ANA MARIA. CONSEJERO: SASTRE BOFILL ANA. SECRETARIO: SASTREBOFILL ANA. CONSEJERO: SASTRE BOFILL JORDI. Modificaciones estatutarias. ART.9:MODIFICACION DEL PLAZO DEDURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 43004 , F 51, S 8, H B 90793, I/A 17 ( 4.05.12).
13 de Febrero de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 558.419,15 Euros. Resultante Suscrito: 631.260,35 Euros. Datos registrales. T 25589 , F 35, S 8, HB 90793, I/A 16 ( 1.02.12).
29 de Julio de 2010Cambio de domicilio social. CL RAMBLA DE CATALUNYA Num.53 P.7 PTA.G (BARCELONA). Datos registrales. T 25589 , F 35,S 8, H B 90793, I/A 15 (19.07.10).
14 de Junio de 2010Modificaciones estatutarias. ART.9 BIS.- ATRIBUCION DE CARACTER GRATUITO AL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datosregistrales. T 25589 , F 34, S 8, H B 90793, I/A 14 (31.05.10).
10 de Marzo de 2010Nombramientos. APODERADO: SASTRE BOFILL JORDI. Datos registrales. T 25589 , F 33, S 8, H B 90793, I/A 13 (25.02.10).