Actos BORME de Schneider Electric Systems Iberica Sl
20 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: CABEZAS CARDENAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 41738 , F 16, S 8, H M 343799, I/A 82(13.12.23).
Nombramientos. Apoderado: FRASSETTO MATTEO. Datos registrales. T 41738 , F 16, S 8, H M 343799, I/A 83 (13.12.23).
03 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: GASCON MIGUEIS ANA RITA DE ALBURQUERQUE. Datos registrales. T 41738 , F 14, S 8, H M343799, I/A 80 (26.09.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GASCON MIGUEIS ANA RITA DE ALBURQUERQUE. Datos registrales. T 41738 , F 15, S 8, H M343799, I/A 81 (26.09.23).
27 de Abril de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GREGORI HERNANDEZ MARTA. Datos registrales. T 41738 , F 12, S 8, H M 343799, I/A 78 (20.04.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA ALONSO BEATRIZ MERCEDES. Datos registrales. T 41738 , F 13, S 8, H M 343799, I/A 79(20.04.23).
04 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLE-ORTISE JELENA. Presidente: VALLE-ORTISE JELENA. Nombramientos. Consejero:GROSS ELISE SALOME. Presidente: GROSS ELISE SALOME. Datos registrales. T 41738 , F 12, S 8, H M 343799, I/A 77(28.03.23).
13 de Febrero de 2023Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 41738 , F 12, S 8, H M 343799, I/A 76 ( 6.02.23).
09 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: PICAVET XAVIER. Presidente: PICAVET XAVIER. Nombramientos. Presidente: VALLE-ORTISEJELENA. Vicepresid.: VIDAL SANCHEZ SERGIO. Datos registrales. T 41738 , F 11, S 8, H M 343799, I/A 74 (30.12.22).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PORCEL MEIJIDE YARA;PICAVET XAVIER. Apo.Manc.: PROCEL MEJIDE YARA;PICAVET XAVIER.Apoderado: PROCEL MEJIDE YARA;PICAVET XAVIER;PORCEL MEIJIDE YARA;PICAVET XAVIER. Datos registrales. T 41738 , F11, S 8, H M 343799, I/A 75 (30.12.22).
19 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: VALERO BELINCHON SARA. Datos registrales. T 41738 , F 10, S 8, H M 343799, I/A 73 (11.10.22).
30 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: JOHNSON CHRISTOPHER;ORTIZ ORTEGA ARANZAZU. Datos registrales. T 41738 , F 9, S 8, H M
27 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: GRUPELL JIMENEZ JORGE. Datos registrales. T 41738 , F 9, S 8, H M 343799, I/A 71 (20.09.22).
12 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: PORTILLO BENITEZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 41738 , F 8, S 8, H M 343799, I/A 70 (5.07.22).
11 de Julio de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: GOMEZ CABEZAS IRENE. Datos registrales. T 41738 , F 7, S 8, H M 343799, I/A 69 ( 4.07.22).
25 de Mayo de 2022Nombramientos. Apoderado: EXPOSITO ROMERO LORENA. Datos registrales. T 41738 , F 6, S 8, H M 343799, I/A 68 (18.05.22).
10 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: ESTEBAN AGUEDA LUIS MARIA. Apo.Manc.: TORRAS CHIVA ROSA. Apo.Sol.: PAPPALARDOVALDERRAMA HUMBERTO. Apoderado: TORRAS CHIVA ROSA. Datos registrales. T 41738 , F 5, S 8, H M 343799, I/A 66 (3.03.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: LORENZO PEREZ SILKA. Apo.Sol.: LORENZO PEREZ SILKA. Datos registrales. T 41738 , F 5, S 8,H M 343799, I/A 67 ( 3.03.22).
29 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 41738 , F 4, S 8, H M 343799, I/A 65 (22.12.21).
14 de Diciembre de 2021Nombramientos. Consejero: VALLE-ORTISE JELENA. Datos registrales. T 41738 , F 4, S 8, H M 343799, I/A 64 ( 3.12.21).
08 de Octubre de 2021Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ VELASCO ALVARO. Datos registrales. T 41738 , F 4, S 8, H M 343799, I/A 63 ( 1.10.21).
22 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: CORTES MARTIN SANDRA. Datos registrales. T 41738 , F 2, S 8, H M 343799, I/A 61 (15.07.21).
Revocaciones. Apo.Manc.: ABAD YUSTE MIGUEL. Apo.Sol.: SANZ MAURELLES ROBERTO. Apo.Manc.: SANZ MAURELLESROBERTO. Apoderado: ALVAREZ GONZALEZ RODOLFO. Datos registrales. T 41738 , F 3, S 8, H M 343799, I/A 62 (15.07.21).
02 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GALAN SERRANO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 41738 , F 1, S 8, H M 343799, I/A 60(26.05.21).
27 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: GARCIA JIMENEZ MARTA;GONZALEZ GONZALEZ CESAR;TORRAS CHIVA ROSA;CARRASCOIGLESIAS GABRIEL;GONZALEZ-ANTA RODRIGUEZ-ORTA ELENA;PORCEL MEIJIDE YARA;PANZERI VITTORIO;PICAVETXAVIER;VIDAL SANCHEZ SERGIO. Datos registrales. T 36349 , F 216, S 8, H M 343799, I/A 59 (20.04.21).
05 de Abril de 2021Nombramientos. Apoderado: GARCIA JIMENEZ MARTA. Datos registrales. T 36349 , F 215, S 8, H M 343799, I/A 58 (25.03.21).
03 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 36349 , F 215, S 8, H M 343799, I/A 57 (24.02.21).
09 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MURIEL RICART SONIA. Datos registrales. T 36349 , F 211, S 8, H M 343799, I/A 52 (30.11.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: CABEZAS CARDENAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 36349 , F 212, S 8, H M 343799, I/A 53(30.11.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ SANGUINO ALBERTO. Apoderado: GONZALEZ-RODILES CARDENAS ANA. Datosregistrales. T 36349 , F 213, S 8, H M 343799, I/A 54 (30.11.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA MUÑOZ MARIA JESUS;GRUPELL JIMENEZ JORGE;ROCA MAZA EVA;ARCE SALDIVAR ANALUCIA. Datos registrales. T 36349 , F 214, S 8, H M 343799, I/A 55 (30.11.20).
Revocaciones. Apoderado: BONE GANDIA FERNANDO. Datos registrales. T 36349 , F 214, S 8, H M 343799, I/A 56 (30.11.20).
10 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 36349 , F 211, S 8, H M 343799, I/A 51 ( 3.02.20).
15 de Enero de 2020Nombramientos. Apoderado: SOLANO BOTELLA NURIA. Datos registrales. T 36349 , F 209, S 8, H M 343799, I/A 48 ( 8.01.20).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MORENO FRANCISCO TOMAS. Datos registrales. T 36349 , F 209, S 8, H M 343799,I/A 49 ( 8.01.20).
Nombramientos. Apoderado: MAROTO VELASCO JOSE LUIS. Datos registrales. T 36349 , F 210, S 8, H M 343799, I/A 50 (8.01.20).
05 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ-RODILES CARDENAS ANA. Datos registrales. T 36349 , F 208, S 8, H M 343799, I/A 47(28.10.19).
18 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: SANZ MAURELLES ROBERTO. Nombramientos. Consejero: VIDAL SANCHEZ SERGIO. Datosregistrales. T 36349 , F 207, S 8, H M 343799, I/A 45 (11.07.19).
Nombramientos. Apoderado: VIDAL SANCHEZ SERGIO;PROCEL MEJIDE YARA;PANZERI VITTORIO;PICAVET XAVIER. Datosregistrales. T 36349 , F 207, S 8, H M 343799, I/A 46 (11.07.19).
19 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ GONZALEZ RODOLFO. Datos registrales. T 36349 , F 205, S 8, H M 343799, I/A 43(12.06.19).
Nombramientos. Apoderado: FORNELLS LOPEZ CLAUDIA. Datos registrales. T 36349 , F 206, S 8, H M 343799, I/A 44(12.06.19).
18 de Marzo de 2019Revocaciones. Apoderado: MERCADO LOPEZ MONICA. Datos registrales. T 36349 , F 205, S 8, H M 343799, I/A 42 (11.03.19).
01 de Marzo de 2019Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. AVDA DE TENERIFE 4 (SANSEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 36349 , F 205, S 8, H M 343799, I/A 41 (22.02.19).
02 de Octubre de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 23183 , F 193, S 8, H M 343799, I/A 40 (25.09.18).
13 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: FONCILLAS RIVERO BELEN MARIA. Datos registrales. T 23183 , F 193, S 8, H M 343799, I/A 39 (5.04.18).
19 de Septiembre de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 23183 , F 192, S 8, H M 343799, I/A 38 (11.09.17).
13 de Julio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: PAPPALARDO VALDERRAMA HUMBERTO. Datos registrales. T 23183 , F 191, S 8, H M 343799, I/A36 ( 5.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ SANGUINO ALBERTO. Datos registrales. T 23183 , F 191, S 8, H M 343799, I/A 37 (5.07.17).
27 de Abril de 2017Nombramientos. Apoderado: CARRILLO MORALES MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 23183 , F 190, S 8, H M 343799,I/A 35 (19.04.17).
03 de Agosto de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 23183 , F 190, S 8, H M 343799, I/A 34 (26.07.16).