Actos BORME de Schwartz Hautmont Ingenieria Y Comercial Sa
01 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: AYNETO SENDRA LUIS;RODRIGUEZ CASTELLANOS MIGUEL. Nombramientos. Adm. Solid.:SENDRA RION GERARD;IGLESIAS FONOLL ALBERT. Datos registrales. T 16622 , F 162, S 8, H M 68053, I/A 32 (24.11.23).
09 de Mayo de 2023Reelecciones. Adm. Solid.: AYNETO SENDRA LUIS;RODRIGUEZ CASTELLANOS MIGUEL. Datos registrales. T 16622 , F 162, S8, H M 68053, I/A 31 (28.04.23).
10 de Enero de 2020Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ RIVAS MIGUEL JESUS. Datos registrales. T 16622 , F 162, S 8, H M 68053, I/A 29(27.12.19).
27 de Diciembre de 2019Nombramientos. Apoderado: ALDECOA LLAURADO ANTONIO. Datos registrales. T 16622 , F 161, S 8, H M 68053, I/A 28(19.12.19).
11 de Marzo de 2019Cambio de domicilio social. C/ ALSASUA 16 - LOCAL C (MADRID). Datos registrales. T 16622 , F 161, S 8, H M 68053, I/A 27 (4.03.19).
19 de Febrero de 2018Ceses/Dimisiones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP. Datos registrales. T 16622 , F 160, S 8, H M 68053, I/A 25 (12.02.18).
Nombramientos. Apoderado: FUSTER GOMEZ DEL CAMPO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 16622 , F 160, S 8, H M 68053,I/A 26 (12.02.18).
23 de Marzo de 2017Fe de erratas: El auditor de cuentas de la Sociedad pasa a denominarse "AUREN AUDITORES SP, SLP" como consecuencia de lafusi贸n por absorci贸n. Datos registrales. T 16622 , F 160, S 8, H M 68053, I/A 24 ( 7.03.17).
15 de Marzo de 2017Otros conceptos: El auditor de cuentas de la Sociedad pasa a denominarse "AUREN HOLDING SP, SLP" como consecuencia de lafusi贸n por absorci贸n. Datos registrales. T 16622 , F 160, S 8, H M 68053, I/A 24 ( 7.03.17).
02 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: CRESPO CANO JOSE MARIA;MALO DE MOLINA MARTINEZ RAFAEL;RODRIGUEZ AMEZJAVIER;TINTORE PASCUAL ESTANISLAO. Presidente: MALO DE MOLINA MARTINEZ RAFAEL. Secretario: RODRIGUEZ AMEZJAVIER. Cons.Del.Sol: MALO DE MOLINA MARTINEZ RAFAEL;CRESPO CANO JOSE MARIA;RODRIGUEZ AMEZ JAVIER.Nombramientos. Adm. Solid.: AYNETO SENDRA LUIS;RODRIGUEZ CASTELLANOS MIGUEL. Modificaciones estatutarias.
28 de Diciembre de 2015Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORS BCN SLP. Datos registrales. T 16622 , F 159, S 8, H M 68053, I/A 22 (17.12.15).
02 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Presidente: MALO DE MOLINA Y JUSTO ALBERTO. Secretario: RODRIGUEZ AMEZ JAVIER. Consejero:CRESPO CANO JOSE MARIA;TINTORE PASCUAL ESTANISLAO. Cons.Del.Sol: CRESPO CANO JOSE MARIA;MALO DE MOLINAY JUSTO ALBERTO;RODRIGUEZ AMEZ JAVIER. Consejero: MALO DE MOLINA Y JUSTO ALBERTO;RODRIGUEZ AMEZ JAVIER.Nombramientos. Consejero: CRESPO CANO JOSE MARIA;MALO DE MOLINA MARTINEZ RAFAEL;RODRIGUEZ AMEZJAVIER;TINTORE PASCUAL ESTANISLAO. Presidente: MALO DE MOLINA MARTINEZ RAFAEL. Secretario: RODRIGUEZ AMEZJAVIER. Cons.Del.Sol: MALO DE MOLINA MARTINEZ RAFAEL;CRESPO CANO JOSE MARIA;RODRIGUEZ AMEZ JAVIER. Datosregistrales. T 16622 , F 158, S 8, H M 68053, I/A 21 (24.11.15).
03 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: MALO DE MOLINA MARTINEZ RAFAEL. Datos registrales. T 16622 , F 158, S 8, H M 68053, I/A 20(26.03.14).
01 de Marzo de 2012Reelecciones. Presidente: MALO DE MOLINA Y JUSTO ALBERTO. Secretario: RODRIGUEZ AMEZ JAVIER. Consejero: CRESPOCANO JOSE MARIA;TINTORE PASCUAL ESTANISLAO. Cons.Del.Sol: CRESPO CANO JOSE MARIA;MALO DE MOLINA Y JUSTOALBERTO;RODRIGUEZ AMEZ JAVIER. Consejero: MALO DE MOLINA Y JUSTO ALBERTO;RODRIGUEZ AMEZ JAVIER. Datosregistrales. T 16622 , F 158, S 8, H M 68053, I/A 19 (20.02.12).
10 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ RIVAS MIGUEL JESUS. Datos registrales. T 16622 , F 156, S 8, H M 68053, I/A 18(25.02.10).