Buscador CIF Logo

Actos BORME Scp Pool Distributors Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Scp Pool Distributors Spain Sl

Actos BORME Scp Pool Distributors Spain Sl - B83749531

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Scp Pool Distributors Spain Sl con CIF B83749531

馃敊 Perfil de Scp Pool Distributors Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Scp Pool Distributors Spain Sl

31 de Octubre de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: MONFORT SILVIA YVETTE;HUBBARD CRAIG K;MEYER DONALD. Apo.Manc.: MONFORT SYLVIAYVETTE. Apoderado: MAURI ARANDA SALVADOR. Apo.Manc.: MORAL IGLESIA JOSE MANUEL;MAURI ARANDASALVADOR;MAURI ARANDA SALVADOR;AREVALILLO GONZALEZ SARA. Otros conceptos: SE SUSTITUYE A SALVADORMAURI ARANDA Y A JOSE MANUEL MORAL IGLESIA POR SARA AREVALILLO GONZALEZ COMO APODERADA CON LAS QUEMIGUEL CASASOLA BENITEZ PUEDE EJERCITAR MANCOMUNADAMENTE LAS FACULTADES CONFERIDAS A SU FAVOR ENLA ESCRITURA DE PODER QUE CAUSO LA INSCRIPCION 28陋,. Datos registrales. T 28110 , F 168, S 8, H M 336414, I/A 35(24.10.23).

21 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: NER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28110 , F 168, S 8, H M 336414, I/A 34 (14.12.22).

06 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: MAURI ARANDA SALVADOR;CASADO GARCIA MARIA PAZ. Apo.Manc.: CASADO GARCIA MARIAPAZ. Nombramientos. Apo.Manc.: MAURI ARANDA SALVADOR;AREVALILLO GONZALEZ SARA. Otros conceptos: SESUSTITUYE A MARIA PAZ CASADO GARCIA POR SARA AREVALILLO GONZALEZ COMO UNA DE LAS PERSONAS CON LASQUE MIGUEL CASASOLA BENITEZ Y JOSE MANUEL MORAL IGLESIA PUEDEN EJERCITAR MANCOMUNADAMENTE LASFACULTADES CONFERIDAS A SU FAVOR EN ESCRITURAS QUE CAUSARON LAS INSCRIPCIONES 28 Y 22RESPECTIVAMENTE. Datos registrales. T 28110 , F 167, S 8, H M 336414, I/A 33 (28.04.22).

04 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MONFORT SYLVIA YVETTE. Nombramientos. Adm. Solid.: ALBOUY JEAN LOUIS. Datosregistrales. T 28110 , F 166, S 8, H M 336414, I/A 32 (28.05.21).

25 de Febrero de 2020
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SCP INTERNATIONAL INC. Datos registrales. T 28110 , F 166, S8, H M 336414, I/A 31 (18.02.20).

10 de Enero de 2020
Reelecciones. Auditor: NER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28110 , F 166, S 8, H M 336414, I/A 30 (27.12.19).

06 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PEREZ DE LA MESA MANUEL J. Nombramientos. Adm. Solid.: ARVAN PETER D. Datosregistrales. T 28110 , F 166, S 8, H M 336414, I/A 29 (30.05.19).

06 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apoderado: CASASOLA BENITEZ MIGUEL. Datos registrales. T 28110 , F 165, S 8, H M 336414, I/A 28(25.04.19).

23 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ DE LA MESA MANUEL J. Datos registrales. T 28110 , F 165, S 8, H M 336414, I/A 27 (12.04.19).

04 de Diciembre de 2018
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SCP POOL INTERMARK DISTRIBUTORS MALAGA SL. Datos registrales. T 28110, F 163, S 8, H M 336414, I/A 26 (27.11.18).

24 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: NER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28110 , F 163, S 8, H M 336414, I/A 25 (16.10.18).

07 de Diciembre de 2017
Reelecciones. Auditor: NER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28110 , F 163, S 8, H M 336414, I/A 24 (29.11.17).

18 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: NER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 28110 , F 162, S 8, H M 336414, I/A 23 (10.01.17).

11 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apo.Manc.: MORAL IGLESIA JOSE MANUEL;MAURI ARANDA SALVADOR;CASADO GARCIA MARIA PAZ.Datos registrales. T 28110 , F 162, S 8, H M 336414, I/A 22 ( 3.11.15).

10 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ DE LA MESA MANUEL J. Presidente: PEREZ DE LA MESA MANUEL J. Consejero: COOKARTHUR DAVID;MONFORT SYLVIA YVETTE. Secretario: MODREGO IBA脩EZ ANGEL LUIS. Nombramientos. Adm. Solid.:MONFORT SYLVIA YVETTE;PEREZ DE LA MESA MANUEL J. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejode administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 28110 , F 161, S 8, H M 336414, I/A 20 ( 2.09.14).

Nombramientos. Apoderado: MODREGO IBA脩EZ ANGEL LUIS. Datos registrales. T 28110 , F 162, S 8, H M 336414, I/A 21 (2.09.14).

26 de Febrero de 2014
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SCP POOL BV. Datos registrales. T 28110 , F 161, S 8, H M336414, I/A 19 (19.02.14).

26 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: NER AUDITORES SLP. Cambio de domicilio social. C/ NARDOS 16-18 - POLIGONO INDUSTRIAL ELMOLINO (HUMANES DE MADRID). Datos registrales. T 28110 , F 161, S 8, H M 336414, I/A 18 (15.11.13).

15 de Octubre de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 260.000,00 Euros. Datos registrales. T 28110 , F 160, S 8, HM 336414, I/A 17 ( 7.10.13).

20 de Septiembre de 2011
Revocaciones. Apoderado: MAURI ARANDA SALVADOR;CASADO GARCIA MARIA PAZ;GARCIA LEON ANGEL;MONFORTSYLVIA. Datos registrales. T 28110 , F 160, S 8, H M 336414, I/A 16 ( 5.09.11).

09 de Junio de 2011
Revocaciones. Apo.Manc.: MAURI ARANDA SALVADOR;GARCIA LEON ANGEL. Datos registrales. T 28110 , F 160, S 8, H M

28 de Febrero de 2011
Nombramientos. Apoderado: MAURI ARANDA SALVADOR;AMIOT MARC-RENE-RAYMOND. Datos registrales. T 28110 , F 160,S 8, H M 336414, I/A 14 (17.02.11).

20 de Enero de 2011
Nombramientos. Auditor: NER AUDITORES SLP. Datos registrales. T 19214 , F 108, S 8, H M 336414, I/A 13 (11.01.11).

26 de Julio de 2010
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL. Datos registrales. T 19214 , F 108, S 8, H M 336414, I/A 12 (15.07.10).

23 de Abril de 2010
Nombramientos. Apo.Manc.: MAURI ARANDA SALVADOR;GARCIA LEON ANGEL;MONFORT SYLVIA YVETTE. Datosregistrales. T 19214 , F 108, S 8, H M 336414, I/A 11 (13.04.10).

29 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: HUBBARD CRAIG K;POLIZZOTTO RICHARD P. Nombramientos. Consejero: COOK ARTHURDAVID;MONFORT SYLVIA YVETTE. Cambio de domicilio social. AVDA DE LAS NIEVES, NUMERO 35 - POLIGONO INDUSTRI(MOSTOLES). Datos registrales. T 19214 , F 107, S 8, H M 336414, I/A 10 (17.09.09).

15 de Abril de 2009
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL;MAURIARANDA SALVADOR;CASADO GARCIA MARIA PAZ;GARCIA LEON ANGEL;MONFORT SYLVIA. Datos registrales. T 19214 , F106, S 8, H M 336414, I/A 9 ( 2.04.09).

18 de Marzo de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 246.994,00 Euros. Resultante Suscrito: 250.000,00 Euros. Datos registrales. T 19214 , F 105, S 8,H M 336414, I/A 8 ( 6.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n