Actos BORME de Sea Land Iberica Sa
07 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: JESUS ALFREDO CACERES MARGARIT. Nombramientos. Apo.Sol.: JOSE MIGUEL CARREÑOGINER;ZSANETT BALLA. Otros conceptos: LA REVOCACION DEL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DON JESUS ALFREDOCACERES MARGARIT TENDRA VALIDEZ A PARTIR DEL DIA UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, por lo que hasta dichafecha el poder se encontrará vigente y el apoderado seguirá estando facultado para actuar en nombre de la. Datos registrales. T1513 , F 64, S 8, H CA 3448, I/A 59 (28.11.22).
08 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: APM TERMINALS ALGECIRAS SA. Nombramientos. Adm. Unico: APM TERMINALS ALGECIRASSA. Datos registrales. T 1513 , F 63, S 8, H CA 3448, I/A 58 (29.09.20).
03 de Diciembre de 2019Otros conceptos: cese del representante persona física del administrador único de la sociedad de esta hoja, Don Hartmut HelmutGoeritz, nombrándose en su lugar a DON KELD PEDERSEN con NIE número Y7165020-M. Datos registrales. T 1513 , F 63, S 8, HCA 3448, I/A 57 (26.11.19).
23 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: CACERES MARGARIT JESUS ALFREDO. Datos registrales. T 1513 , F 62, S 8, H CA 3448, I/A 56(15.05.18).
30 de Junio de 2017Revocaciones. Apoderado: GARCIA VILLAESCUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 1513 , F 62, S 8, H CA 3448, I/A 55 (21.06.17).
05 de Mayo de 2017Otros conceptos: Inscrito el cambio de representante físico de la entidad APM Terminals Algeciras SA siendo ahora don HartmutHelmut Goeritz. Datos registrales. T 1513 , F 61, S 8, H CA 3448, I/A 54 (25.04.17).
28 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: GARCIA VILLAESCUSA AGUSTIN. Datos registrales. T 1513 , F 61, S 8, H CA 3448, I/A 53(21.10.15).
16 de Septiembre de 2015Revocaciones. Apoderado: THOMSEN.JOHN ERWIN. Datos registrales. T 1513 , F 60, S 8, H CA 3448, I/A 52 ( 2.06.15).
11 de Junio de 2015Revocaciones. Apoderado: LUQUE JIMENEZ ALONSO;ZUMALACARREGUI BENITEZ ALFONSO;AMORES MOLINAFRANCISCO;BENAVENT QUILIS EMILIO;LAUMANN GUNTHER;SARRASQUETA REONDO JUAN JESUS. Apo.Man.Soli: LUQUEJIMENEZ ALONSO. Apoderado: TOHMSEN JOHN E;LUQUE JIMENEZ ALONSO;ANDERSEN RUNE HOLMBERG;ALBERTSENHENRIK. Datos registrales. T 1513 , F 60, S 8, H CA 3448, I/A 52 ( 2.06.15).
30 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: REYES BARRANQUERO MARIA DE LOS ANGELES;UGLVIG LAURIDS;KJELDSEN ANDERS.Secretario: REYES BARRANQUERO MARIA DE LOS ANGELES. Vicepresid.: UGLVIG LAURIDS. Presidente: KJELDSEN ANDERS.Dir. General: DAMGAARD NIELSEN JORGEN;THOMSEN.JOHN ERWIN. Nombramientos. Adm. Unico: APM TERMINALSALGECIRAS SA. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 19, 20, 21 Y 22 DE LOS ESTATUTOS Y SESUPRIMEN LOS ARTICULOS 18 Y 23.-. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.Datos registrales. T 1513 , F 60, S 8, H CA 3448, I/A 51 (19.12.14).
08 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: KJELDSEN ANDERS. Reelecciones. Consejero: KJELDSEN ANDERS;UGLVIGLAURIDS;REYES BARRANQUERO MARIA DE LOS ANGELES. Presidente: KJELDSEN ANDERS. Secretario: REYESBARRANQUERO MARIA DE LOS ANGELES. Vicepresid.: UGLVIG LAURIDS. Datos registrales. T 1513 , F 60, S 8, H CA 3448, I/A50 (25.04.12).
27 de Mayo de 2009Nombramientos. Consejero: KJELDSEN ANDERS;UGLVIG LAURIDS;REYES BARRANQUERO MARIA DE LOS ANGELES.Presidente: KJELDSEN ANDERS. Vicesecret.: UGLVIG LAURIDS. Secretario: REYES BARRANQUERO MARIA DE LOS ANGELES.Con.Delegado: KJELDSEN ANDERS. Datos registrales. T 1513 , F 60, S 8, H CA 3448, I/A 49 (14.05.09).
17 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BART VOS LUCAS. Presidente: BART VOS LUCAS. Con.Delegado: BART VOS LUCAS. Consejero:ALBERTSEN HENRIK. Secretario: ALBERTSEN HENRIK. Consejero: THOMSEN.JOHN ERWIN. Datos registrales. T 1513 , F 59, S8, H CA 3448, I/A 48 ( 4.02.09).