Actos BORME de Secorbus Sl
09 de Mayo de 2023Nombramientos. Auditor: EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE SL. Datos registrales. T 9008 , F 225, S 8, H M144919, I/A 29 ( 1.05.23).
14 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 9008 , F 224, S 8, H M 144919, I/A 28 ( 7.02.22).
17 de Enero de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA BALLANO ANA-BELEN;MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 9008 , F 224, S 8,H M 144919, I/A 27 (10.01.22).
03 de Enero de 2020Nombramientos. Auditor: EUROPEAN TAX LAW GLOBAL AUDIT ASSURANCE SL. Datos registrales. T 9008 , F 224, S 8, H M144919, I/A 26 (26.12.19).
11 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: DELGADO MORA RAFAEL. Datos registrales. T 9008 , F 223, S 8, H M 144919, I/A 25 ( 4.06.19).
19 de Febrero de 2019Revocaciones. Apoderado: PEREZ PEDRAZA MARIA GLORIA. Datos registrales. T 9008 , F 223, S 8, H M 144919, I/A 24(12.02.19).
06 de Abril de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: GARCIA BALLANO ANA-BELEN;MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 9008 , F 223, S8, H M 144919, I/A 23 (27.03.18).
21 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apoderado: PEREZ PEDRAZA MARIA GLORIA. Datos registrales. T 9008 , F 222, S 8, H M 144919, I/A 22(14.12.17).
25 de Julio de 2017Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ CABEZAS DE HERRERA JOSE LUIS. Datos registrales. T 9008 , F 221, S 8, H M144919, I/A 20 (17.07.17).
Nombramientos. Apo.Sol.: ORDAS MATAS VICTOR. Datos registrales. T 9008 , F 221, S 8, H M 144919, I/A 21 (17.07.17).
07 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Secretario: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Consejero: ROMERO GOMEZ FAUSTINO. Presidente:ROMERO GOMEZ FAUSTINO. Cons.Del.Man: ROMERO GOMEZ FAUSTINO. Nombramientos. Consejero: ROMERO GARCIAFAUSTINO JESUS. Secretario: ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Presidente: JUAN Y PASCUAL ANGEL. Cons.Del.Man:ROMERO GARCIA FAUSTINO JESUS. Datos registrales. T 9008 , F 221, S 8, H M 144919, I/A 19 (24.02.17).
20 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: HORWATH AUDITORES ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA PROFESI. Datos registrales. T 9008 , F 221, S8, H M 144919, I/A 18 (13.01.17).
10 de Agosto de 2016Ampliacion del objeto social. EXPLOTACION DEL TRANSPORTE POR FERROCARRIL DE VIAJEROS, MERCANCIAS O MIXTO,CON MEDIOS PROPIOS O AJENOS... Datos registrales. T 9008 , F 220, S 8, H M 144919, I/A 17 ( 2.08.16).
28 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: MORENO MARTINEZ CESAR. Datos registrales. T 9008 , F 220, S 8, H M 144919, I/A 16 (17.03.16).
01 de Marzo de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 39.666,00 Euros. Resultante Suscrito: 320.934,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 5潞. Capital.-. Datos registrales. T 9008 , F 184, S 8, H M 144919, I/A 15 (19.02.13).
22 de Febrero de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 7,26 Euros. Resultante Suscrito: 360.600,00 Euros. Datos registrales. T 9008 , F 184, S8, H M 144919, I/A 14 (14.02.13).
24 de Abril de 2012Revocaciones. Apoderado: GARCIA CARCELES ROBERTO CAMILO. Datos registrales. T 9008 , F 183, S 8, H M 144919, I/A 12(11.04.12).
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ CABEZAS DE HERRERA JOSE LUIS. Datos registrales. T 9008 , F 183, S 8, H M144919, I/A 13 (12.04.12).
02 de Febrero de 2012Revocaciones. Apoderado: PEREZ PITA JOSE LUIS. Datos registrales. T 9008 , F 183, S 8, H M 144919, I/A 10 (23.01.12).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA CARCELES ROBERTO CAMILO. Datos registrales. T 9008 , F 183, S 8, H M 144919, I/A 11(23.01.12).