Actos BORME de Segre Distribucions De Premsa Sl
16 de Marzo de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BAS ESPARGARO KRISHNA. Consejero: DISTRIBUCIONES GENERALES BOYACASL;BOYACA SERVICIOS CORPORATIVOS SL. Nombramientos. SecreNoConsj: SERRA DE ARVIZU PABLO. Datos registrales.T 548 , F 150, S 8, H L 10042, I/A 26 ( 8.03.23).
Ceses/Dimisiones. Consejero: COSTA MIRANDA SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: SANS MIR SANTI. Datos registrales.T 548 , F 150, S 8, H L 10042, I/A 27 ( 8.03.23).
Revocaciones. Apoderado: CASOL TORRUELLA JORDI;CASOL TORRUELLA JORDI. Apo.Manc.: HERRERA DORADO MARIAPILAR;SOLSONA BARBE GENOVEVA. Nombramientos. Apo.Manc.: SANS MIR SANTI;HERRERA DORADO MARIA PILAR.Datos registrales. T 548 , F 151, S 8, H L 10042, I/A 28 ( 8.03.23).
19 de Enero de 2023Nombramientos. Apoderado: SANS MIR SANTIAGO. Datos registrales. T 548 , F 150, S 8, H L 10042, I/A 25 (11.01.23).
30 de Septiembre de 2022Nombramientos. VsecrNoConsj: LLEBERIA SEDO INMACULADA. Datos registrales. T 548 , F 149, S 8, H L 10042, I/A 23(22.09.22).
22 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FORN BONE RAFAEL. Nombramientos. SecreNoConsj: BAS ESPARGARO KRISHNA. Datosregistrales. T 548 , F 149, S 8, H L 10042, I/A 22 ( 3.12.20).
02 de Septiembre de 2019Nombramientos. Consejero: BOYACA SERVICIOS CORPORATIVOS SL. Datos registrales. T 548 , F 130, S 8, H L 10042, I/A 21(23.08.19).
09 de Abril de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: REDPRENSA SL;RED DE DISTRIBUCIONES EDITORIALES SL. Nombramientos. Consejero:DISTRIBUCIONES GENERALES BOYACA SL. Datos registrales. T 548 , F 130, S 8, H L 10042, I/A 19 ( 2.04.19).
Ceses/Dimisiones. Secretario: SAPENA GRAU FRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: FORN BONE RAFAEL. Datosregistrales. T 548 , F 130, S 8, H L 10042, I/A 20 ( 2.04.19).
02 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO AGUADO PEDRO. Nombramientos. Consejero: RED DE DISTRIBUCIONESEDITORIALES SL. Datos registrales. T 548 , F 129, S 8, H L 10042, I/A 18 (24.03.14).
20 de Noviembre de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 45.075,00 Euros. Resultante Suscrito: 135.225,00 Euros. Datos registrales. T 548 , F 129,S 8, H L 10042, I/A 17 ( 8.11.12).
30 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apoderado: ALEGRE BAS JUAN. Fe de erratas: En el BORME 226 DE 29 de noviembre de 2011 se han publicadolos actos de la inscripci贸n 15 de la Sociedad, habi茅ndose omitido, por error, el de revocaci贸n de poder de Don Juan Alegre Bas, lo quese indica para su subsanaci贸n. Datos registrales. T 548 , F 128, S 8, H L 10042, I/A 15 (11.11.11).
29 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: LEAL HERRERO VICENTE;MOYANO BARRIOS MIGUEL;DE JUAN LUQUE MANUEL;SOTOPADILLA DIDAC. Nombramientos. Consejero: ALONSO AGUADO PEDRO;GRUPO GODO DE COMUNICACION SA.Modificaciones estatutarias. 22. Administraci贸n y Representacion.-. Otros conceptos: Queda fijado en 6 el n煤mero de miembrosdel Consejo de Administraci贸n. Datos registrales. T 548 , F 128, S 8, H L 10042, I/A 15 (11.11.11).
29 de Junio de 2009Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo que regula la transmisi贸n voluntariae intervivos de las participaciones sociales..Datos registrales. T 548 , F 127, S 8, H L 10042, I/A 12 (19.06.09).