Buscador CIF Logo

Actos BORME Septiembre 74 Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Septiembre 74 Sa

Actos BORME Septiembre 74 Sa - A28342723

Tenemos registrados 9 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Septiembre 74 Sa con CIF A28342723

🔙 Perfil de Septiembre 74 Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Septiembre 74 Sa

29 de Julio de 2022
Declaración de unipersonalidad. Socio único: MARTINEZ AVIAL MARIN MARIA TERESA. Ceses/Dimisiones. Consejero:GARCIA MARTINEZ-AVIAL CARMEN;GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARTA-FERNANDA;GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN.Presidente: GARCIA MARTINEZ-AVIAL CARMEN. Secretario: GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN. Con.Delegado: GARCIAMARTINEZ-AVIAL CARMEN;GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARTA-FERNANDA;GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN. Nombramientos.Adm. Unico: GARCIA MARTINEZ AVIAL MARIA TERESA. Reducción de capital. Importe reducción: 363.027,21 Euros. ResultanteSuscrito: 165.020,79 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 3. Capital social.-. Artículo de los estatutos: 2.Objeto social.-. Otros conceptos: Renumeradas las acciones de la sociedad del 1 al 85.503, ambos inclusive, modificando el artículo3º de los Estatutos Sociales. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Modificados losartículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9, 10, 11º, 12, 13º, 14º, 15º y 17º de los Estatutos Sociales, eliminación de los artículos 15º y 16º delos citados Estatutos y renumeración de los artículos siguientes. Cambio de objeto social. La adqusición, administración y gestión,por cuenta propia de todo tipo de bienes mobiliarios, valores activos líquidos, acciones, participaciones... Datos registrales. T 26407 ,F 203, S 8, H M 101406, I/A 30 (21.07.22).

07 de Noviembre de 2018
Reducción de capital. Importe reducción: 1.120.442,40 Euros. Resultante Suscrito: 526.629,60 Euros. Ampliación de capital.Suscrito: 1.418,40 Euros. Desembolsado: 1.418,40 Euros. Resultante Suscrito: 528.048,00 Euros. Resultante Desembolsado:528.048,00 Euros. Datos registrales. T 26407 , F 202, S 8, H M 101406, I/A 29 (30.10.18).

25 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARIA TERESA;GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARTA-FERNANDA;GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN. Presidente: GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARIA TERESA. Secretario: GARCIAMARTINEZ-AVIAL JUAN. Cons.Del.Sol: GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARIA TERESA;GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN.Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ AVIAL MARIN MARIA TERESA;GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN;AMUNARRIZ URUÑUELAMARIA LOURDES. Apo.Sol.: GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN;GARCIA MARTINEZ AVIAL CARMEN;ARCE LOZANO ANTONIO.Nombramientos. Consejero: GARCIA MARTINEZ-AVIAL CARMEN;GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARTA-FERNANDA;GARCIAMARTINEZ-AVIAL JUAN. Presidente: GARCIA MARTINEZ-AVIAL CARMEN. Secretario: GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN.Con.Delegado: GARCIA MARTINEZ-AVIAL CARMEN;GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARTA-FERNANDA;GARCIA MARTINEZ-AVIALJUAN. Apoderado: GARCIA MARTINEZ AVIAL MARIA TERESA. Datos registrales. T 26407 , F 201, S 8, H M 101406, I/A 28(17.10.18).

15 de Octubre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MARTINEZ AVIAL MARIA TERESA;GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN. Presidente: GARCIAMARTINEZ AVIAL MARIA TERESA. Secretario: GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN. Cons.Del.Sol: GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN.Consejero: GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARTA-FERNANDA. Nombramientos. Consejero: GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARIATERESA;GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARTA-FERNANDA;GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN. Presidente: GARCIA MARTINEZ-AVIALMARIA TERESA. Secretario: GARCIA MARTINEZ-AVIAL JUAN. Cons.Del.Sol: GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARIA TERESA;GARCIAMARTINEZ-AVIAL JUAN. Datos registrales. T 26407 , F 200, S 8, H M 101406, I/A 27 ( 8.10.13).

20 de Septiembre de 2010
Nombramientos. Consejero: GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARTA-FERNANDA. Datos registrales. T 26407 , F 200, S 8, H M101406, I/A 26 ( 8.09.10).

23 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MARTIN JULIO. Cons.Del.Sol: GARCIA MARTIN JULIO. Nombramientos. Consejero:GARCIA MARTINEZ-AVIAL MARTA-FERNANDA. Datos registrales. T 26407 , F 200, S 8, H M 101406, I/A 25 (11.08.10).

02 de Noviembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA MARTINEZ AVIAL CARMEN. Datos registrales. T 26407 , F 200, S 8, H M 101406, I/A 24(20.10.09).

08 de Mayo de 2009
Ampliación de capital. Suscrito: 1.493.923,20 Euros. Desembolsado: 373.480,80 Euros. Resultante Suscrito: 1.647.072,00 Euros.Resultante Desembolsado: 526.629,60 Euros. Datos registrales. T 6221 , F 152, S 8, H M 101406, I/A 23 (27.04.09).

26 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: GARCIA MARTINEZ AVIAL JUAN. Nombramientos. Consejero: GARCIA MARTINEZ AVIALMARIA TERESA;GARCIA MARTIN JULIO;GARCIA MARTINEZ AVIAL JUAN. Cons.Del.Sol: GARCIA MARTIN JULIO;GARCIAMARTINEZ AVIAL JUAN. Reelecciones. Consejero: GARCIA MARTINEZ AVIAL CARMEN. Presidente: GARCIA MARTINEZ AVIALMARIA TERESA. Secretario: GARCIA MARTINEZ AVIAL JUAN. Datos registrales. T 6221 , F 152, S 8, H M 101406, I/A 22(14.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información