Actos BORME de Sercelo Sa
23 de Julio de 2021Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: HOSPITAL BARTRES JUAN;PAUL MARIE FRANCOIS FOUREZ. Datos registrales. T 41205 , F13, S 8, H B 24674, I/A 35 (15.07.21).
30 de Marzo de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.001.048,00 Euros. Desembolsado: 2.001.048,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.001.572,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.001.572,00 Euros. Datos registrales. T 41205 , F 13, S 8, H B 24674, I/A 34 (23.03.20).
21 de Junio de 2018Nombramientos. APOD.SOL/MAN: ALFARO CARDIEL GRISELDA CAROLINA. Datos registrales. T 41205 , F 11, S 8, H B 24674,I/A 33 (13.06.18).
19 de Agosto de 2015Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: HOSPITAL BARTRES JUAN;PAUL MARIE FRANCOIS FOUREZ. Datos registrales. T 41205 , F11, S 8, H B 24674, I/A 32 (12.08.15).
07 de Noviembre de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 875.910,00 Euros. Desembolsado: 875.910,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.524,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.000.524,00 Euros. Datos registrales. T 41205 , F 11, S 8, H B 24674, I/A 31 (24.10.11).
19 de Mayo de 2009Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: PAUL MARIE FRANCOIS FOUREZ;HOSPITAL BARTRES JUAN. Datos registrales. T 33815 , F118, S 8, H B 24674, I/A 28 ( 6.05.09).
Nombramientos. APODERADO: VIDAL MONTA脩O GERMAN. Datos registrales. T 33815 , F 119, S 8, H B 24674, I/A 29 (6.05.09).
Revocaciones. APODERADO: GOMEZ BERBEGAL ESTELA;JARA SALAGARAY MARI CARMEN;MAUREL ALBARICHMAXIMO;FORNES FERNANDEZ MIGUEL;MORON CAMPOS MARIA BELEN. Datos registrales. T 33815 , F 120, S 8, H B 24674,I/A 30 ( 6.05.09).