Actos BORME de Sermansur Sa
11 de Septiembre de 2013Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 2136 , F 128, S 8, H CO 29035, I/A 14 ( 5.09.13).
08 de Agosto de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2136 , F 127, S 8, H CO 29035, I/A 13 ( 1.08.13).
27 de Diciembre de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 4.200.000,00 Euros. Desembolsado: 4.200.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 38.110.102,00 Euros.Resultante Desembolsado: 38.110.102,00 Euros. Datos registrales. T 2136 , F 127, S 8, H CO 29035, I/A 12 (19.12.12).
07 de Diciembre de 2012Cambio de domicilio social. RONDA TEJARES 22 7 (CORDOBA). Datos registrales. T 2136 , F 127, S 8, H CO 29035, I/A 11(28.11.12).
10 de Agosto de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2136 , F 126, S 8, H CO 29035, I/A 10 ( 2.08.12).
04 de Octubre de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2136 , F 126, S 8, H CO 29035, I/A 9 (23.09.11).
02 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: PANIAGUA AMO FRANCISCO ASIS. Secretario: PANIAGUA AMO FRANCISCO ASIS.Cons.Del.Man: PANIAGUA AMO FRANCISCO ASIS. Consejero: CA脩ADILLA MOYANO ANGEL MARIA. Cons.Del.Man: CA脩ADILLAMOYANO ANGEL MARIA. Consejero: GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL. Cons.Del.Man: GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL.Consejero: LOPEZ GONZALEZ RAFAEL. Cons.Del.Man: LOPEZ GONZALEZ RAFAEL. Consejero: CUELLAR RAMOS JOSE PABLO.Cons.Del.Man: CUELLAR RAMOS JOSE PABLO. Presidente: CA脩ADILLA MOYANO ANGEL MARIA. Nombramientos. Adm.Mancom.: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SA;COLUMBA 2010 SL. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 9.Administraci贸n y Representacion.-. Art铆culo de los estatutos: 16. Administraci贸n y Representacion.-. Art铆culo de los estatutos: 18.Administraci贸n y Representacion.-. Art铆culo de los estatutos: 20. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 2136 , F125, S 8, H CO 29035, I/A 8 (21.02.11).
07 de Enero de 2011Nombramientos. Presidente: CA脩ADILLA MOYANO ANGEL MARIA. Datos registrales. T 2136 , F 125, S 8, H CO 29035, I/A 7(28.12.10).
23 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ARACENA JIMENEZ ROSARIO. Presidente: ARACENA JIMENEZ ROSARIO. Cons.Del.Man:ARACENA JIMENEZ ROSARIO. Datos registrales. T 2136 , F 125, S 8, H CO 29035, I/A 6 (14.09.10).
12 de Abril de 2010Revocaciones. Auditor: VALDAURA Y ASOCIADOS SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2136 , F125, S 8, H CO 29035, I/A 5 (30.03.10).
12 de Agosto de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.850.000,00 Euros. Desembolsado: 1.850.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 33.910.102,00 Euros.Resultante Desembolsado: 33.910.102,00 Euros. Datos registrales. T 2136 , F 124, S 8, H CO 29035, I/A 4 ( 3.08.09).
23 de Julio de 2009Cambio de domicilio social. RONDA DE LOS TEJARES 22 2 1 (CORDOBA). Datos registrales. T 2136 , F 123, S 8, H CO 29035,I/A 2 (14.07.09).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CUELLAR RAMOS JOSE PABLO. Cons.Del.Man: PRIEGO DE MONTIANO ANTONIO;CUELLARRAMOS JOSE PABLO. Consejero: PRIEGO DE MONTIANO ANTONIO;TRIGO DE AIZPURU MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Man:PRIEGO DE MONTIANO ANTONIO. Presidente: TRIGO DE AIZPURU MIGUEL ANGEL. Consejero: FI脩ANA RODRIGUEZMARIANO;SERRANO MEJIA JESUS. Cons.Del.Sol: TRIGO DE AIZPURU MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Man: FI脩ANA RODRIGUEZMARIANO;SERRANO MEJIA JESUS;CUELLAR RAMOS JOSE PABLO. SecreNoConsj: HINOJOSA DIOS JUAN MARIA.Nombramientos. Consejero: ARACENA JIMENEZ ROSARIO. Presidente: ARACENA JIMENEZ ROSARIO. Cons.Del.Man:
17 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Auditor: MB CONSULTORES Y AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: VALDAURA Y ASOCIADOS SL.Datos registrales. T 3943 , F 68, S 8, H SE 57589, I/A 12 ( 2.06.09).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR SL. Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man:RAMOS CATALINA FLORIDO JAIME;JIMENEZ GARCIA JERONIMO. Secretario: JIMENEZ GARCIA JERONIMO. Cons.Del.Man:ROLDAN ARJONA MARIA ISABEL. Consejero: ROLDAN ARJONA MARIA ISABEL. Presidente: RODRIGUEZ ELIAS HILARIO.Cons.Del.Man: RODRIGUEZ ELIAS HILARIO. Consejero: RODRIGUEZ ELIAS HILARIO;RAMOS CATALINA FLORIDOJAIME;JIMENEZ GARCIA JERONIMO. Nombramientos. Consejero: PRIEGO DE MONTIANO ANTONIO;RODRIGUEZ DETEMBLEQUE CARRERE IGNACIO;CUELLAR RAMOS JOSE PABLO. Presidente: PRIEGO DE MONTIANO ANTONIO.Cons.Del.Man: CUELLAR RAMOS JOSE PABLO;PRIEGO DE MONTIANO ANTONIO;RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE CARREREIGNACIO. SecreNoConsj: HINOJOSA DIOS JUAN MARIA. Datos registrales. T 3943 , F 68, S 8, H SE 57589, I/A 13 ( 2.06.09).
Ceses/Dimisiones. Presidente: PRIEGO DE MONTIANO ANTONIO. Consejero: RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE CARREREIGNACIO. Cons.Del.Man: RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE CARRERE IGNACIO. Nombramientos. Consejero: TRIGO DE AIZPURUMIGUEL ANGEL;SERRANO MEJIA JESUS;FI脩ANA RODRIGUEZ MARIANO. Presidente: TRIGO DE AIZPURU MIGUEL ANGEL.Cons.Del.Man: PRIEGO DE MONTIANO ANTONIO;CUELLAR RAMOS JOSE PABLO;SERRANO MEJIA JESUS;FI脩ANARODRIGUEZ MARIANO. Cons.Del.Sol: TRIGO DE AIZPURU MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3943 , F 69, S 8, H SE 57589,I/A 14 ( 3.06.09).
Otros conceptos: Extendida diligencia provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberseexpedido con fecha de hoy certificaci贸n literal para traslado de domicilio social a la provincia de CORDOBA.- Datos registrales. T3943 , F 69, S 8, H SE 57589, I/A 14 A ( 5.06.09).