Buscador CIF Logo

Actos BORME Serveis Integrals Lafuente Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Serveis Integrals Lafuente Sl

Actos BORME Serveis Integrals Lafuente Sl - B96265020

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Serveis Integrals Lafuente Sl con CIF B96265020

🔙 Perfil de Serveis Integrals Lafuente Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Serveis Integrals Lafuente Sl

15 de Septiembre de 2023
Cambio de denominación social. LAFUENTE SERVICIOS INTEGRALES SL. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 54, S 8, H V33797, I/A 78 (11.09.23).

16 de Junio de 2023
Declaración de unipersonalidad. Socio único: CLECE SA. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 54, S 8, H V 33797, I/A 77 (9.06.23).

09 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 54, S 8, H V 33797, I/A 76 (30.11.22).

10 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: COMIN PERNAS CARLOS. Nombramientos. Apoderado: URQUIZU GIMENEZ MERCEDES.Apo.Man.Soli: HIDALGO LOPEZ JOSE LUIS;ALEJO GARCIA RAUL. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 52, S 8, H V 33797, I/A 75( 3.03.22).

29 de Noviembre de 2021
Otros conceptos: Don Vicente Arnau Vazquez ha sido sustituido por Don Raúl Gutiérrez Rodríguez como persona fisicarepresentante de la mercantil "CLECE SA", Administradora unica de la sociedad de esta hoja. Datos registrales. T 9087, L 6371, F206, S 8, H V 33797, I/A 43 M (22.11.21).

14 de Abril de 2021
Fe de erratas: La fecha correcta del nombramiento de auditor es el 25/06/2019 y no la que como por error se publicó en el Boletín 50de fecha 15/03/21 y referencia 01222562021. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 52, S 8, H V 33797, I/A 74 ( 8.03.21).

15 de Marzo de 2021
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 52, S 8, H V 33797, I/A 74 ( 8.03.21).

16 de Marzo de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: PORTA ALAPONT MARIA BELEN;LAFUENTE ARMERO MARIA ESTHER. Datos registrales. T 9854, L7136, F 52, S 8, H V 33797, I/A 73 ( 9.03.20).

06 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: ROMAN HERNANDO JAVIER;AGUSTINA CUSI SARA;LAFUENTE ARMERO MARIA ESTHER;LOPEZBUENO RAFAEL;VALDERAS ALVARADO ORENCIO. Apo.Man.Soli: ELIZAGA CORRALES JOSE ANDRES;BENITO GARCIAIGNACIO;MOLITERNI MOYA MIGUEL;GIL SANCHEZ MARTA;CALVO FELIX JOSE MARIA;LOPEZ NAVARRO MARINA;MARTIN DEALVARO ANGEL. Apo.Sol.: LLAMAS VARELA ROSA. Apo.Man.Soli: NOGALES CALDERON JESUS;ESPINAS JANER JOSEMANUEL;GARCIA ARANDA GRISELDA;JIMENEZ ROSADO RAQUEL;MUÑOZ HURTADO PEDRO;JIMENEZ MARTINEZMARIO;SANCHEZ-SECO PEÑA SANTIAGO;LAZARO TORRES FRANCISCO-CIPRIANO;ALONSO MARTIN MYRIAM;PALENCIANOOLIVARES ANTONIO DANIEL;SALA SANCHEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 51, S 8, H V 33797, I/A 72(29.10.19).

08 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ HORTA RAUL;LERMA NAVARRO ANTONIO;MICO PASCUAL VICENTE JOSE. Datosregistrales. T 9854, L 7136, F 51, S 8, H V 33797, I/A 71 ( 1.02.19).

28 de Diciembre de 2018
Otros conceptos: Don Jose Javier Román Hernando ha sido sustituido por Don Vicente Arnau Vazquez, como persona fisicarepresentante de la mercantil "CLECE SA", que es Administradora Unica de la sociedad de esta hoja. Datos registrales. T 9087, L6371, F 205, S 8, H V 33797, I/A43/M2 (20.12.18).

05 de Diciembre de 2018
Reelecciones. Auditor: ANDREU ROMERO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PROFESI. Datos registrales. T 9854, L 7136, F50, S 8, H V 33797, I/A 70 (28.11.18).

12 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: CAMIÑA MONTERDE MARIA ANGELES. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 50, S 8, H V 33797, I/A69 ( 5.09.18).

15 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: ANDREU ROMERO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PROFESI. Datos registrales. T 9854, L 7136, F50, S 8, H V 33797, I/A 68 ( 7.11.17).

20 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: ANDREU ROMERO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PROFESI. Datos registrales. T 9854, L 7136, F50, S 8, H V 33797, I/A 67 (13.01.17).

23 de Junio de 2016
Revocaciones. Apoderado: CARRION HERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 49, S 8, H V 33797, I/A 66(16.06.16).

02 de Noviembre de 2015
Reelecciones. Auditor: ANDREU ROMERO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PROFESI. Datos registrales. T 9854, L 7136, F49, S 8, H V 33797, I/A 65 (26.10.15).

10 de Septiembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: SEGOVIA LOPEZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PALENCIANO OLIVARESANTONIO DANIEL;SALA SANCHEZ JUAN JOSE;SEGOVIA LOPEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 9854, L 7136, F 48, S 8,H V 33797, I/A 64 ( 3.09.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información