Actos BORME de Serveis Tres 2003 Sl
05 de Enero de 2023Cierre provisional de la hoja registral por revocación del NIF. Datos registrales. T 1884 , F 37, S 8, H T 26853, I/ARVCIF(15.11.22).
14 de Noviembre de 2016Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. Datos registrales. T 1884 , F 37, S 8, H T 26853,I/A NOTA (27.10.16).
25 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RULL DUART FRANCISCO. Presidente: RULL DUART FRANCISCO. Datos registrales. T 1884 , F41, S 8, H T 26853, I/A 6 (18.02.13).
13 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: FUSTER ABENOZA JUAN JOSE. Secretario: FUSTER ABENOZA JUAN JOSE. Datos registrales. T1884 , F 41, S 8, H T 26853, I/A 5 ( 3.09.12).
26 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTRO SORINAS JOSE. Presidente: CASTRO SORINAS JOSE. Consejero: FUSTER ABENOZAJUAN JOSE. Secretario: FUSTER ABENOZA JUAN JOSE. Consejero: RULL DUART FRANCISCO. Nombramientos. Auditor:GIRALT CIURANA JOSEP. Aud.Supl.: ROIG LLEVAT ECONOMISTES AUDITORS SLP. Consejero: RULL DUART FRANCISCO.Presidente: RULL DUART FRANCISCO. Consejero: FUSTER ABENOZA JUAN JOSE. Secretario: FUSTER ABENOZA JUAN JOSE.Consejero: ALQUEZAR SORRIBAS RAFAEL ELIAS. Datos registrales. T 1884 , F 41, S 8, H T 26853, I/A 4 (15.05.09).