Actos BORME de Servicios Auxiliares De Puertos Sa
29 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 112 , F 169, S 8, H CE 210, I/A 145(21.12.23).
03 de Febrero de 2022Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ ANTON JOSE LUIS. Datos registrales. T 112 , F 169, S 8, H CE 210, I/A 144 (17.01.22).
28 de Mayo de 2021Reelecciones. Adm. Unico: BOLUDA FOS VICENTE. Datos registrales. T 112 , F 169, S 8, H CE 210, I/A 143 (20.05.21).
17 de Febrero de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOSE ANTONIO MERCHAN RUIZ;JORGE MANUEL ROSETY MOLINS. Datos registrales. T 112 ,F 168, S 8, H CE 210, I/A 142 ( 8.02.21).
31 de Diciembre de 2020Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 112 , F 168, S 8, H CE 210, I/A 141(22.12.20).
25 de Noviembre de 2020Revocaciones. Apoderado: LOZANO TORRES MARIA LUISA. Datos registrales. T 112 , F 168, S 8, H CE 210, I/A 140 (17.11.20).
23 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 112 , F 167, S 8, H CE 210, I/A 139(11.12.19).
14 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 112 , F 167, S 8, H CE 210, I/A 138(17.01.19).
25 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 112 , F 167, S 8, H CE 210, I/A 137(29.12.17).
28 de Junio de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: BENITEZ FORNELL MANUEL. Apoderado: PULIDO ALCAIDE MIGUEL. Datos registrales. T 112 , F166, S 8, H CE 210, I/A 135 (20.06.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTAÑEDA PALENZUELA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 112 , F 166, S 8, H CE 210,I/A 136 (20.06.17).
23 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ MARTINEZ JUAN. Datos registrales. T 112 , F 166, S 8, H CE 210, I/A 134 (15.02.17).
20 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 112 , F 16, S 8, H CE 210, I/A 132(13.12.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BORDILS MONTERO ANTONIO;BOLUDA CEBALLOS IGNACIO DEL CARMEN. Datos registrales.T 112 , F 16, S 8, H CE 210, I/A 133 (13.01.17).
29 de Enero de 2016Revocaciones. Apoderado: VEGA CHOZAS JOSE MANUEL. Nombramientos. Apoderado: DE LA CRUZ VARGAS ADOLFO.Datos registrales. T 112 , F 16, S 8, H CE 210, I/A 131 (13.01.16).
15 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 112 , F 16, S 8, H CE 210, I/A 130 (1.12.15).
17 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BOLUDA FOS VICENTE. Nombramientos. Adm. Unico: BOLUDA FOS VICENTE. Datos
18 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ MARTINEZ JUAN. Apo.Sol.: GONZALEZ MARTINEZ JUAN;GONZALEZ CHORENRESPALDIZA VERONICA;ALMAGRO BERLANGA JOSEApo.Man.Soli: PULIDO ALCAIDE MIGUEL. Nombramientos. Apoderado:PULIDO ALCAIDE MIGUEL. Datos registrales. T 112 , F 14, S 8, H CE 210, I/A 128 ( 3.03.15).
26 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 112 , F 14, S 8, H CE 210, I/A 127 (5.12.14).
29 de Enero de 2014Revocaciones. Apoderado: MARTIN GARACHANA ALICIA. Datos registrales. T 112 , F 14, S 8, H CE 210, I/A 126 (10.01.14).
16 de Diciembre de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 112 , F 14, S 8, H CE 210, I/A 125 (2.12.13).
17 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: BOLUDA CEBALLOS VICENTE DEL CARMEN. Datos registrales. T 112 , F 13, S 8, H CE 210, I/A124 ( 7.10.13).
23 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: LOZANO TORRES MARIA LUISA. Datos registrales. T 112 , F 13, S 8, H CE 210, I/A 123 (13.05.13).
24 de Enero de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 112 , F 13, S 8, H CE 210, I/A 122(17.12.12).
17 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: VEGA CHOZAS JOSE MANUEL. Datos registrales. T 101 , F 80, S 8, H CE 210, I/A 121 (14.08.12).
26 de Diciembre de 2011Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 101 , F 80, S 8, H CE 210, I/A120 (15.12.11).
18 de Abril de 2011Revocaciones. Apoderado: SEDANO GARCIA JUAN RAMON. Datos registrales. T 101 , F 80, S 8, H CE 210, I/A 119 ( 5.04.11).
20 de Octubre de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVAREZ GUTIERREZ JUAN MANUEL. Nombramientos. Apoderado: SEDANO GARCIA JUANRAMON. Datos registrales. T 101 , F 80, S 8, H CE 210, I/A 118 (28.09.09).
15 de Septiembre de 2009Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ BAUSET JESUS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DUQUE LUDEÑAESTHER;CALATAYUD GOMEZ MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 101 , F 79, S 8, H CE 210, I/A 117 (27.08.09).
22 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BOLUDA CRESPO VICENTE;BOLUDA FOS VICENTE. Nombramientos. Adm. Unico: BOLUDAFOS VICENTE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradorúnico.a designada como Administrador único ejercerá su cargo por un plazo de seis años, pudiendo ser indefinidamente reelegido porperiodos de igual duración máxima.. Datos registrales. T 101 , F 79, S 8, H CE 210, I/A 116 ( 1.06.09).
19 de Mayo de 2009Revocaciones. Apo.Man.Soli: DEUSTO IPIÑA ELENA. Datos registrales. T 101 , F 79, S 8, H CE 210, I/A 115 ( 6.05.09).
13 de Enero de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: DOMINGO GONZALEZ LUIS ENRIQUE. Apo.Man.Soli: BARONA DE GUZMAN TOMAS. Datosregistrales. T 101 , F 78, S 8, H CE 210, I/A 113 (19.12.08).
Nombramientos. Apo.Sol.: BARONA DE GUZMAN TOMAS. Datos registrales. T 101 , F 78, S 8, H CE 210, I/A 114 (19.12.08).