Buscador CIF Logo

Actos BORME Servicios Comunitarios De Molina Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Servicios Comunitarios De Molina Sa

Actos BORME Servicios Comunitarios De Molina Sa - A30243976

Tenemos registrados 45 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Servicios Comunitarios De Molina Sa con CIF A30243976

馃敊 Perfil de Servicios Comunitarios De Molina Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Servicios Comunitarios De Molina Sa

03 de Noviembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE DE HARO GONZALEZ;DAVID VELARDE TRIGUEROS;ELISEO GARCIA CANTO. Presidente:ELISEO GARCIA CANTO. Consejero: MANUEL JOSE SALVADOR CASADO;JOSE MARIA RUBIO HERNANDEZ;JOSE LUIS LACALDEL VAL. SecreNoConsj: JOAQUIN GARCIA ALONSO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: FRANCISCO DE ASIS AGUADOJIMENEZ;DANIEL ROMAN ACOSTA;ROCIO RAMOS AZNAR;PEDRO MANUEL GARCIA MARTINEZ;CLEOFE LOPEZ GARCIA.Nombramientos. Consejero: JOSE ANGEL ALFONSO HERNANDEZ;FRANCISCO HERNANDEZ GOMEZ;PEDRO-ANTONIOALMELA ALBALADEJO;ISABEL GADEA MARTINEZ;RAFAEL MONDEJAR BERNAL;ALEJANDRO FONT CA脩AS;ARTUROALBALADEJO RUIZ;SILVIA GARCES MARTINEZ;JOSE LUIS LACAL DEL VAL. Presidente: JOSE ANGEL ALFONSO HERNANDEZ.Vicesecret.: JOSE LUIS LACAL DEL VAL. Apo.Man.Soli: PEDRO MANUEL GARCIA MARTINEZ;DANIEL ROMAN ACOSTA;ROCIORAMOS AZNAR. Apo.Sol.: CLEOFE LOPEZ GARCIA. SecreNoConsj: JOAQUIN GARCIA ALONSO. Datos registrales. T 3611 , F 93,S 8, H MU 2063, I/A 80 (26.10.23).

16 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDO LOPEZ ROMAN. Nombramientos. Consejero: JOSE MARIA RUBIO HERNANDEZ.Datos registrales. T 3611 , F 93, S 8, H MU 2063, I/A 79 ( 9.02.23).

05 de Enero de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FRANCISCO DE ASIS AGUADO JIMENEZ;DANIEL ROMAN ACOSTA;ROCIO RAMOS AZNAR.Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRANCISCO DE ASIS AGUADO JIMENEZ;DANIEL ROMAN ACOSTA;ROCIO RAMOSAZNAR;PEDRO MANUEL GARCIA MARTINEZ;CLEOFE LOPEZ GARCIA. Datos registrales. T 3224 , F 196, S 8, H MU 2063, I/A 78(30.12.22).

02 de Agosto de 2022
Nombramientos. Auditor: BRAINSTORMING AUDIT SLP. Datos registrales. T 3224 , F 196, S 8, H MU 2063, I/A 77 (26.07.22).

02 de Julio de 2021
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 51.926,87 Euros. Resultante Suscrito: 7.471.218,80 Euros. Datos registrales. T 3224 , F195, S 8, H MU 2063, I/A 76 (25.06.21).

11 de Mayo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: ESTHER CLAVERO MIRA;FUENSANTA MARTINEZ JIMENEZ. Presidente: ESTHER CLAVEROMIRA. Nombramientos. Consejero: ELISEO GARCIA CANTO. Presidente: ELISEO GARCIA CANTO. Consejero: MANUEL JOSESALVADOR CASADO. Datos registrales. T 3224 , F 195, S 8, H MU 2063, I/A 75 ( 4.05.21).

22 de Abril de 2020
Otros conceptos: Al practicar la precedente inscripcion 73陋 no se hizo constar la creacion de la pagina web corporativa. P谩gina webde la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.sercomosa.es. Datos registrales. T 3224 , F 195, S 8, H MU 2063, I/A74 (15.04.20).

19 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: SONIA CARRILLO MARMOL;TOMAS FRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ. Nombramientos.Auditor: BLAZQUEZ Y ASOCIADOS AUDITORES SL. Consejero: FERNANDO LOPEZ ROMAN;DAVID VELARDE TRIGUEROS.Datos registrales. T 3224 , F 195, S 8, H MU 2063, I/A 73 (13.03.20).

08 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: SONIA CARRILLO MARMOL;FRANCISCO CANO GARCIA;JOSE DE HARO GONZALEZ;JAIMELEON JOVER MEDINA;ALEJANDRO FONT CA脩AS;SILVIA GARCES MARTINEZ;ESTHER CLAVERO MIRA. Presidente: ESTHERCLAVERO MIRA. Consejero: ARTURO ALBALADEJO RUIZ;JOSE LUIS LACAL DEL VAL. Nombramientos. Consejero: ESTHERCLAVERO MIRA;SONIA CARRILLO MARMOL;JOSE DE HARO GONZALEZ;FUENSANTA MARTINEZ JIMENEZ;TOMASFRANCISCO FERNANDEZ MARTINEZ;ALEJANDRO FONT CA脩AS;ARTURO ALBALADEJO RUIZ;SILVIA GARCESMARTINEZ;JOSE LUIS LACAL DEL VAL. Presidente: ESTHER CLAVERO MIRA. Datos registrales. T 3224 , F 194, S 8, H MU 2063,I/A 72 ( 1.10.19).

27 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: DAVID SERRANO PEREZ. Nombramientos. Consejero: JOSE LUIS LACAL DEL VAL. Datosregistrales. T 3224 , F 194, S 8, H MU 2063, I/A 71 (21.06.19).

05 de Octubre de 2018
Otros conceptos: Modificacion del Articulo 11 y 26 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 3224 , F 194, S 8, H MU 2063, I/A70 (28.09.18).

30 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VICTOR NU脩EZ ESPINOSA;DANIEL ROMAN ACOSTA;ROCIO RAMOS AZNAR. Datos registrales.T 3224 , F 193, S 8, H MU 2063, I/A 68 (23.05.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRANCISCO DE ASIS AGUADO JIMENEZ;DANIEL ROMAN ACOSTA;ROCIO RAMOS AZNAR.Datos registrales. T 3224 , F 193, S 8, H MU 2063, I/A 69 (23.05.18).

04 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Apo.Man.Soli: JUAN ROMERO GASPAR. Nombramientos. Apo.Man.Soli: VICTOR NU脩EZESPINOSA;DANIEL ROMAN ACOSTA;ROCIO RAMOS AZNAR. Datos registrales. T 3224 , F 192, S 8, H MU 2063, I/A 67(27.11.17).

01 de Diciembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: JUAN ROMERO GASPAR;DANIEL ROMAN ACOSTA. Datos registrales. T 3224 , F 191, S 8, H MU2063, I/A 66 (24.11.17).

30 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Consejero: ARTURO ALBALADEJO RUIZ. Datos registrales. T 3224 , F 191, S 8, H MU 2063, I/A 65 (23.11.17).

28 de Abril de 2017
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 3224 , F 191, S 8, H MU 2063, I/A 64 (21.04.17).

15 de Marzo de 2017
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion decuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2710 , F 12, S 8, H MU 2063, I/A60 ( 8.03.17).

Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2015 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2710 , F 12, S 8, H MU 2063, I/A 61 ( 8.03.17).

Nombramientos. Auditor: ABANTE AUDIEST AUDITORES SAP. Datos registrales. T 3224 , F 191, S 8, H MU 2063, I/A 62 (8.03.17).

Nombramientos. Apoderado: DANIEL ROMAN ACOSTA. Datos registrales. T 3224 , F 191, S 8, H MU 2063, I/A 63 ( 8.03.17).

31 de Octubre de 2016
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2710 , F 12, S 8, H MU 2063, I/A 59 (24.10.16).

01 de Septiembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: EDUARDO CONTRERAS LINARES. Presidente: EDUARDO CONTRERAS LINARES.Nombramientos. Consejero: ESTHER CLAVERO MIRA. Presidente: ESTHER CLAVERO MIRA. SecreNoConsj: JOAQUIN GARCIAALONSO. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012mediante certificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de noaprobacion de cuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2710 , F 12, S 8, HMU 2063, I/A 58 (25.08.16).

28 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDRES SANTIAGO ARNALDOS CASCALES. Secretario: ANDRES SANTIAGO ARNALDOSCASCALES. Datos registrales. T 2710 , F 12, S 8, H MU 2063, I/A 57 (20.06.16).

14 de Abril de 2016
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2710 , F 12, S 8, H MU 2063, I/A 56 ( 7.04.16).

08 de Enero de 2016
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion decuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2710 , F 12, S 8, H MU 2063, I/A55 (31.12.15).

03 de Noviembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: EDUARDO JAVIER CONTRERAS LINARES;JOSE OLIVA ORTIZ;FRANCISCO CANOGARCIA;ENCARNA HERNANDEZ RODRIGUEZ;ANDRES SANTIAGO ARNALDOS CASCALES;SILVIA GARCES MARTINEZ.Secretario: ANDRES SANTIAGO ARNALDOS CASCALES. Presidente: EDUARDO JAVIER CONTRERAS LINARES. Consejero:ALEJANDRO FONT CA脩AS;DAVID SERRANO PEREZ;SONIA CARRILLO MARMOL. Nombramientos. Consejero: EDUARDOCONTRERAS LINARES. Presidente: EDUARDO CONTRERAS LINARES. Consejero: ANDRES SANTIAGO ARNALDOS CASCALES.Secretario: ANDRES SANTIAGO ARNALDOS CASCALES. Consejero: SONIA CARRILLO MARMOL;FRANCISCO CANOGARCIA;JOSE DE HARO GONZALEZ;JAIME LEON JOVER MEDINA;DAVID SERRANO PEREZ;ALEJANDRO FONT CA脩AS;SILVIAGARCES MARTINEZ. Datos registrales. T 2710 , F 11, S 8, H MU 2063, I/A 53 (27.10.15).

Reelecciones. Auditor: SECONAUDIT SOCIEDAD ESPA脩OLA DE CONSULTORES Y AUDI. Datos registrales. T 2710 , F 11, S 8,H MU 2063, I/A 54 (27.10.15).

15 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: VICTORIA EUGENIA GOMEZ ALCAZAR. Nombramientos. Consejero: SONIA CARRILLOMARMOL. Datos registrales. T 2710 , F 11, S 8, H MU 2063, I/A 51 ( 7.10.15).

Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2710 , F 11, S 8, H MU 2063, I/A 52 ( 7.10.15).

24 de Junio de 2015
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2710 , F 11, S 8, H MU 2063, I/A 50 (17.06.15).

30 de Enero de 2015
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2710 , F 11, S 8, H MU 2063, I/A 49 (23.01.15).

17 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANSELMO GUILLEN RIOS;MANUEL NAVARRO AGULLO. Nombramientos. Consejero:ALEJANDRO FONT CA脩AS;DAVID SERRANO PEREZ. Reelecciones. Auditor: SECONAUDIT SOCIEDAD ESPA脩OLA DECONSULTORES Y AUDI. Datos registrales. T 2710 , F 11, S 8, H MU 2063, I/A 48 (10.10.14).

Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2710 , F 11, S 8, H MU 2063, I/A 47 (10.10.14).

24 de Enero de 2014
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2710 , F 11, S 8, H MU 2063, I/A 46 (17.01.14).

23 de Octubre de 2013
Reelecciones. Auditor: SECONAUDIT SOCIEDAD ESPA脩OLA DE CONSULTORES Y AUDI. Datos registrales. T 2710 , F 10, S 8,H MU 2063, I/A 45 (16.10.13).

08 de Febrero de 2013
Reelecciones. Auditor: SECONAUDIT SOCIEDAD ESPA脩OLA DE CONSULTORES Y AUDI. Datos registrales. T 2710 , F 9, S 8, HMU 2063, I/A 44 ( 1.02.13).

31 de Diciembre de 2012
Otros conceptos: no aprobacion de cuentas anuales del ejercicio 2011. Datos registrales. T 2710 , F 9, S 8, H MU 2063, I/A 43(20.12.12).

10 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Secretario: ANDRES SANTIAGO ARNALDOS CASCALES. Presidente: EDUARDO JAVIER CONTRERASLINARES. Apo.Man.Soli: JUAN ROMERO GASPAR. Apo.Manc.: DANIEL ROMAN ACOSTA. Datos registrales. T 2710 , F 9, S 8, HMU 2063, I/A 42 (29.11.12).

07 de Diciembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: SILVIA GARCES MARTINEZ;ALEJANDRO FONT CA脩AS;FRANCISCO CANO GARCIA;JOSE OLIVAORTIZ;MANUEL NAVARRO AGULLO;EDUARDO JAVIER CONTRERAS LINARES;VICTORIA EUGENIA GOMEZ

07 de Febrero de 2012
Nombramientos. Presidente: EDUARDO JAVIER CONTRERAS LINARES. Con.Delegado: ANSELMO GUILLEN RIOS.SecreNoConsj: DAVID SERRANO PEREZ. Datos registrales. T 2710 , F 8, S 8, H MU 2063, I/A 40 (27.01.12).

13 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSE ANGEL ALFONSO HERNANDEZ;JUAN ANTONIO HERNANDEZ LUNA;ADORACION MOLINALOPEZ.Presidente: JOSE ANGEL ALFONSO HERNANDEZ. Consejero: RAUL GONZALEZ RODRIGUEZ. Con.Delegado: ANSELMOGUILLEN RIOS. Nombramientos. Consejero: MANUEL NAVARRO AGULLO;EDUARDO JAVIER CONTRERASLINARES;VICTORIA EUGENIA GOMEZ ALCAZAR;ANDRES SANTIAGO ARNALDOS CASCALES. Reelecciones. Consejero:

02 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Auditor: SECONAUDIT SOCIEDAD ESPA脩OLA DE CONSULTORES Y AUDI. Datos registrales. T 2710 , F 8, S8, H MU 2063, I/A 38 (23.10.09).

28 de Agosto de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: JORGE PEIRANO SERRANO;JORGE GOYENA SALGADO. Secretario: JORGE GOYENASALGADO. Nombramientos. Consejero: SILVIA GARCES MARTINEZ;RAUL GONZALEZ RODRIGUEZ. SecreNoConsj: DAVIDSERRANO PEREZ. Datos registrales. T 1543 , F 135, S 8, H MU 2063, I/A 37 (20.08.09).

08 de Abril de 2009
Nombramientos. Auditor: SECONAUDIT SOCIEDAD ESPA脩OLA DE CONSULTORES Y AUDI. Datos registrales. T 1543 , F 135,S 8, H MU 2063, I/A 36 (27.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n