Actos BORME de Servicios De Depilacion Bloc Sl
27 de Diciembre de 2023Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIMAR AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 45905 , F 160, S 8, H B418286, I/A 63 (19.12.23).
01 de Diciembre de 2023Nombramientos. APODERAD.SOL: GILA LORENZO CARLOS. Datos registrales. T 45905 , F 157, S 8, H B 418286, I/A 62(22.11.23).
15 de Junio de 2023Revocaciones. CONSEJERO: CASANOVAS GARCES FRANCESC. PRESIDENTE: CASANOVAS GARCES FRANCESC.CONSEJERO: JONAMA FERNANDEZ DE SEVILLA LUIS;CASANOVAS GARCES DANIEL;CORTINA MARUENDA JOSE JUAN.SECRETARIO: CORTINA MARUENDA JOSE JUAN. CONSEJERO: LANCE EDWARD CONTENTO;MARCELLO BOTTOLI.VICEPRESIDEN: MARCELLO BOTTOLI. CONS. DELEG.: CASANOVAS GARCES FRANCESC. Nombramientos. ADM.UNICO: SDBLOC CAPITAL SL. REPR.143 RRM: CASANOVAS GARCES FRANCESC. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOSARTICULOS 18 Y 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y DEJACION SIN CONTENIDO DEL ARTICULO 23 DE LOS MISMOS.CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 45905 , F 157, S 8, H B 418286, I/A 61 ( 7.06.23).
09 de Mayo de 2023Revocaciones. APODERAD.SOL: DE URRUTIA RIVERA BEGO脩A MARIA. Datos registrales. T 45905 , F 157, S 8, H B 418286,I/A 60 (27.04.23).
25 de Enero de 2023Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIMAR AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 45905 , F 156, S 8, H B418286, I/A 59 (19.01.23).
28 de Enero de 2022Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIMAR AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 45905 , F 156, S 8, H B418286, I/A 58 (21.01.22).
05 de Abril de 2021Revocaciones. APODERAD.SOL: BLANCO MARTINEZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 45905 , F 156, S 8, H B 418286, I/A 57(24.03.21).
16 de Febrero de 2021Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIMAR AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 45905 , F 156, S 8, H B418286, I/A 56 ( 8.02.21).
15 de Febrero de 2019Revocaciones. DTOR.GENERAL: JONAMA FERNANDEZ DE SEVILLA LUIS. Datos registrales. T 45905 , F 155, S 8, H B 418286,I/A 55 ( 7.02.19).
10 de Agosto de 2018Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIMAR AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 45905 , F 155, S 8, H B418286, I/A 54 ( 2.08.18).
20 de Marzo de 2018Revocaciones. APODERAD.SOL: PALLAROLS TAYLOR GEMMA. Datos registrales. T 45905 , F 155, S 8, H B 418286, I/A 53(12.03.18).
27 de Octubre de 2017Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: OCHAL MESETA SL. OCHAL NORTE SL. OCHAL SUR SL. OCHAL LEVANTE SL.Datos registrales. T 45470 , F 200, S 8, H B 418286, I/A 52 (19.10.17).
06 de Octubre de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: DE URRUTIA RIVERA BEGO脩A MARIA. Datos registrales. T 45470 , F 199, S 8, H B 418286,I/A 51 (28.09.17).
24 de Mayo de 2017Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN RELACION A LAPERIODICIDAD EN EL PAGO DE LA RETRIBUCION A LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datos registrales.T 45470 , F 198, S 8, H B 418286, I/A 50 (17.05.17).
14 de Marzo de 2017Nombramientos. CONS. DELEG.: CASANOVAS GARCES FRANCESC. Datos registrales. T 45470 , F 196, S 8, H B 418286, I/A48 ( 3.03.17).
Revocaciones. APODERAD.SOL: JONAMA FERNANDEZ DE SEVILLA LLUIS. Nombramientos. DTOR.GENERAL: JONAMAFERNANDEZ DE SEVILLA LUIS. Datos registrales. T 45470 , F 197, S 8, H B 418286, I/A 49 ( 3.03.17).
24 de Febrero de 2017Revocaciones. ADM.UNICO: CASANOVAS GARCES FRANCESC. Nombramientos. CONSEJERO: CASANOVAS GARCESFRANCESC. PRESIDENTE: CASANOVAS GARCES FRANCESC. CONSEJERO: JONAMA FERNANDEZ DE SEVILLALUIS;CASANOVAS GARCES DANIEL;CORTINA MARUENDA JOSE JUAN. SECRETARIO: CORTINA MARUENDA JOSE JUAN.CONSEJERO: LANCE EDWARD CONTENTO;MARCELLO BOTTOLI. VICEPRESIDEN: MARCELLO BOTTOLI. Modificacionesestatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: SD BLOC CAPITAL SL. Datos registrales. T 45470 ,F 191, S 8, H B 418286, I/A 47 (17.02.17).
05 de Agosto de 2016Otros conceptos: RECTIFICADA LA INS.43 EN CUANTO AL DNI DE LA APODERDA DO脩A CAROLINA SANCHO GARCERA.Datos registrales. T 43024 , F 108, S 8, H B 418286, I/A 44 (27.07.16).
Nombramientos. APODERAD.SOL: JONAMA FERNANDEZ DE SEVILLA LLUIS. Datos registrales. T 43024 , F 108, S 8, H B418286, I/A 45 (27.07.16).
Revocaciones. APODERAD.SOL: GUELL TORENT PAU. Datos registrales. T 45470 , F 191, S 8, H B 418286, I/A 46 (27.07.16).
26 de Febrero de 2016Revocaciones. APODERAD.SOL: SANCHO GARCERA CAROLINA. Datos registrales. T 43024 , F 106, S 8, H B 418286, I/A 40(18.02.16).
Nombramientos. APODERAD.SOL: PALLAROLS TAYLOR GEMMA. Datos registrales. T 43024 , F 106, S 8, H B 418286, I/A 41(18.02.16).
Nombramientos. APODERAD.SOL: BLANCO MARTINEZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 43024 , F 107, S 8, H B 418286, I/A42 (18.02.16).
Nombramientos. APODERAD.SOL: SANCHO GARCERA CAROLINA. Datos registrales. T 43024 , F 107, S 8, H B 418286, I/A 43(18.02.16).
12 de Febrero de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 415.135,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.615,00 Euros. Datos registrales. T 43024 , F105, S 8, H B 418286, I/A 39 ( 4.02.16).
28 de Abril de 2015Revocaciones. APODERADO: SILLA QUILES MARIAM. Datos registrales. T 43024 , F 105, S 8, H B 418286, I/A 38 (21.04.15).
17 de Enero de 2014Modificaciones estatutarias. ART.20.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 43024 , F 105, S 8, H B 418286, I/A 37 ( 8.01.14).
04 de Septiembre de 2013Nombramientos. APODERAD.SOL: GUELL TORENT PAU. Datos registrales. T 43024 , F 103, S 8, H B 418286, I/A 34 (27.08.13).
Nombramientos. APODERAD.SOL: SANCHO GARCERA CAROLINA. Datos registrales. T 43024 , F 104, S 8, H B 418286, I/A 35(27.08.13).
Revocaciones. APODERADO: OCHANDIO GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 43024 , F 104, S 8, H B 418286, I/A 36(27.08.13).
18 de Febrero de 2013Revocaciones. APODERADO: DEL POZUELO MARTINEZ ANA. Datos registrales. T 43024 , F 103, S 8, H B 418286, I/A 33(11.02.13).
28 de Enero de 2013Revocaciones. APODERADO: TERRON ARIAS BASILISA. Datos registrales. T 43024 , F 102, S 8, H B 418286, I/A 32 (21.01.13).
20 de Junio de 2012Revocaciones. APODERADO: LUCERO ZAMBRANA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 43024 , F 101, S 8, H B 418286, I/A30 ( 7.06.12).
18 de Junio de 2012Nombramientos. APODERADO: TERRON ARIAS BASILISA;DEL POZUELO MARTINEZ ANA. Datos registrales. T 43024 , F 101,S 8, H B 418286, I/A 31 ( 7.06.12).
29 de Febrero de 2012Cambio de domicilio social. CL PROVENCA Num.288 P.3 PTA.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 43024 , F 101, S 8, H B418286, I/A 29 (16.02.12).
12 de Marzo de 2010Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 9106, L 6390, F 55, S 8, H V 136315, I/A 4 ( 3.03.10).
04 de Diciembre de 2009Cambio de domicilio social. G.V. GERMANIAS 36 B (VALENCIA). Datos registrales. T 9106, L 6390, F 55, S 8, H V 136315, I/A 2(25.11.09).
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: OCHAL GROUP 2005 SL. Datos registrales. T 9106, L 6390, F 55, S 8, H V136315, I/A 3 (25.11.09).