Buscador CIF Logo

Actos BORME Servicios De Depilacion Bloc Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Servicios De Depilacion Bloc Sl

Actos BORME Servicios De Depilacion Bloc Sl - B97614937

Tenemos registrados 38 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Servicios De Depilacion Bloc Sl con CIF B97614937

馃敊 Perfil de Servicios De Depilacion Bloc Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Servicios De Depilacion Bloc Sl

27 de Diciembre de 2023
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIMAR AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 45905 , F 160, S 8, H B418286, I/A 63 (19.12.23).

01 de Diciembre de 2023
Nombramientos. APODERAD.SOL: GILA LORENZO CARLOS. Datos registrales. T 45905 , F 157, S 8, H B 418286, I/A 62(22.11.23).

15 de Junio de 2023
Revocaciones. CONSEJERO: CASANOVAS GARCES FRANCESC. PRESIDENTE: CASANOVAS GARCES FRANCESC.CONSEJERO: JONAMA FERNANDEZ DE SEVILLA LUIS;CASANOVAS GARCES DANIEL;CORTINA MARUENDA JOSE JUAN.SECRETARIO: CORTINA MARUENDA JOSE JUAN. CONSEJERO: LANCE EDWARD CONTENTO;MARCELLO BOTTOLI.VICEPRESIDEN: MARCELLO BOTTOLI. CONS. DELEG.: CASANOVAS GARCES FRANCESC. Nombramientos. ADM.UNICO: SDBLOC CAPITAL SL. REPR.143 RRM: CASANOVAS GARCES FRANCESC. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOSARTICULOS 18 Y 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y DEJACION SIN CONTENIDO DEL ARTICULO 23 DE LOS MISMOS.CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Datos registrales. T 45905 , F 157, S 8, H B 418286, I/A 61 ( 7.06.23).

09 de Mayo de 2023
Revocaciones. APODERAD.SOL: DE URRUTIA RIVERA BEGO脩A MARIA. Datos registrales. T 45905 , F 157, S 8, H B 418286,I/A 60 (27.04.23).

25 de Enero de 2023
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIMAR AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 45905 , F 156, S 8, H B418286, I/A 59 (19.01.23).

28 de Enero de 2022
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIMAR AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 45905 , F 156, S 8, H B418286, I/A 58 (21.01.22).

05 de Abril de 2021
Revocaciones. APODERAD.SOL: BLANCO MARTINEZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 45905 , F 156, S 8, H B 418286, I/A 57(24.03.21).

16 de Febrero de 2021
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIMAR AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 45905 , F 156, S 8, H B418286, I/A 56 ( 8.02.21).

15 de Febrero de 2019
Revocaciones. DTOR.GENERAL: JONAMA FERNANDEZ DE SEVILLA LUIS. Datos registrales. T 45905 , F 155, S 8, H B 418286,I/A 55 ( 7.02.19).

10 de Agosto de 2018
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIMAR AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 45905 , F 155, S 8, H B418286, I/A 54 ( 2.08.18).

20 de Marzo de 2018
Revocaciones. APODERAD.SOL: PALLAROLS TAYLOR GEMMA. Datos registrales. T 45905 , F 155, S 8, H B 418286, I/A 53(12.03.18).

27 de Octubre de 2017
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: OCHAL MESETA SL. OCHAL NORTE SL. OCHAL SUR SL. OCHAL LEVANTE SL.Datos registrales. T 45470 , F 200, S 8, H B 418286, I/A 52 (19.10.17).

06 de Octubre de 2017
Nombramientos. APODERAD.SOL: DE URRUTIA RIVERA BEGO脩A MARIA. Datos registrales. T 45470 , F 199, S 8, H B 418286,I/A 51 (28.09.17).

24 de Mayo de 2017
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 22 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN RELACION A LAPERIODICIDAD EN EL PAGO DE LA RETRIBUCION A LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION. Datos registrales.T 45470 , F 198, S 8, H B 418286, I/A 50 (17.05.17).

14 de Marzo de 2017
Nombramientos. CONS. DELEG.: CASANOVAS GARCES FRANCESC. Datos registrales. T 45470 , F 196, S 8, H B 418286, I/A48 ( 3.03.17).

Revocaciones. APODERAD.SOL: JONAMA FERNANDEZ DE SEVILLA LLUIS. Nombramientos. DTOR.GENERAL: JONAMAFERNANDEZ DE SEVILLA LUIS. Datos registrales. T 45470 , F 197, S 8, H B 418286, I/A 49 ( 3.03.17).

24 de Febrero de 2017
Revocaciones. ADM.UNICO: CASANOVAS GARCES FRANCESC. Nombramientos. CONSEJERO: CASANOVAS GARCESFRANCESC. PRESIDENTE: CASANOVAS GARCES FRANCESC. CONSEJERO: JONAMA FERNANDEZ DE SEVILLALUIS;CASANOVAS GARCES DANIEL;CORTINA MARUENDA JOSE JUAN. SECRETARIO: CORTINA MARUENDA JOSE JUAN.CONSEJERO: LANCE EDWARD CONTENTO;MARCELLO BOTTOLI. VICEPRESIDEN: MARCELLO BOTTOLI. Modificacionesestatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: SD BLOC CAPITAL SL. Datos registrales. T 45470 ,F 191, S 8, H B 418286, I/A 47 (17.02.17).

05 de Agosto de 2016
Otros conceptos: RECTIFICADA LA INS.43 EN CUANTO AL DNI DE LA APODERDA DO脩A CAROLINA SANCHO GARCERA.Datos registrales. T 43024 , F 108, S 8, H B 418286, I/A 44 (27.07.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: JONAMA FERNANDEZ DE SEVILLA LLUIS. Datos registrales. T 43024 , F 108, S 8, H B418286, I/A 45 (27.07.16).

Revocaciones. APODERAD.SOL: GUELL TORENT PAU. Datos registrales. T 45470 , F 191, S 8, H B 418286, I/A 46 (27.07.16).

26 de Febrero de 2016
Revocaciones. APODERAD.SOL: SANCHO GARCERA CAROLINA. Datos registrales. T 43024 , F 106, S 8, H B 418286, I/A 40(18.02.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: PALLAROLS TAYLOR GEMMA. Datos registrales. T 43024 , F 106, S 8, H B 418286, I/A 41(18.02.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: BLANCO MARTINEZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 43024 , F 107, S 8, H B 418286, I/A42 (18.02.16).

Nombramientos. APODERAD.SOL: SANCHO GARCERA CAROLINA. Datos registrales. T 43024 , F 107, S 8, H B 418286, I/A 43(18.02.16).

12 de Febrero de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 415.135,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.615,00 Euros. Datos registrales. T 43024 , F105, S 8, H B 418286, I/A 39 ( 4.02.16).

28 de Abril de 2015
Revocaciones. APODERADO: SILLA QUILES MARIAM. Datos registrales. T 43024 , F 105, S 8, H B 418286, I/A 38 (21.04.15).

17 de Enero de 2014
Modificaciones estatutarias. ART.20.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datosregistrales. T 43024 , F 105, S 8, H B 418286, I/A 37 ( 8.01.14).

04 de Septiembre de 2013
Nombramientos. APODERAD.SOL: GUELL TORENT PAU. Datos registrales. T 43024 , F 103, S 8, H B 418286, I/A 34 (27.08.13).

Nombramientos. APODERAD.SOL: SANCHO GARCERA CAROLINA. Datos registrales. T 43024 , F 104, S 8, H B 418286, I/A 35(27.08.13).

Revocaciones. APODERADO: OCHANDIO GONZALEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 43024 , F 104, S 8, H B 418286, I/A 36(27.08.13).

18 de Febrero de 2013
Revocaciones. APODERADO: DEL POZUELO MARTINEZ ANA. Datos registrales. T 43024 , F 103, S 8, H B 418286, I/A 33(11.02.13).

28 de Enero de 2013
Revocaciones. APODERADO: TERRON ARIAS BASILISA. Datos registrales. T 43024 , F 102, S 8, H B 418286, I/A 32 (21.01.13).

20 de Junio de 2012
Revocaciones. APODERADO: LUCERO ZAMBRANA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 43024 , F 101, S 8, H B 418286, I/A30 ( 7.06.12).

18 de Junio de 2012
Nombramientos. APODERADO: TERRON ARIAS BASILISA;DEL POZUELO MARTINEZ ANA. Datos registrales. T 43024 , F 101,S 8, H B 418286, I/A 31 ( 7.06.12).

29 de Febrero de 2012
Cambio de domicilio social. CL PROVENCA Num.288 P.3 PTA.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 43024 , F 101, S 8, H B418286, I/A 29 (16.02.12).

12 de Marzo de 2010
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 9106, L 6390, F 55, S 8, H V 136315, I/A 4 ( 3.03.10).

04 de Diciembre de 2009
Cambio de domicilio social. G.V. GERMANIAS 36 B (VALENCIA). Datos registrales. T 9106, L 6390, F 55, S 8, H V 136315, I/A 2(25.11.09).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: OCHAL GROUP 2005 SL. Datos registrales. T 9106, L 6390, F 55, S 8, H V136315, I/A 3 (25.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n