Actos BORME de Servicios De Informacion Educativa Y De Noticias Siena Sa
28 de Diciembre de 2018Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 37738 , F 201, S 8, H M 43699, I/A 39 (19.12.18).
23 de Octubre de 2018Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MULTI CONTENIDOS SA. Datos registrales. T 2502 , F 225, S 8, H M 43699, I/A38 (16.10.18).
14 de Noviembre de 2016Nombramientos. Apoderado: RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN AUREO;DE MOYA ANEGON JOSE MARIA;ROVIRA DAUDI PABLO.Datos registrales. T 2502 , F 225, S 8, H M 43699, I/A 37 ( 3.11.16).
11 de Noviembre de 2016Reelecciones. Secretario: LOPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ ALFONSO. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LAINSCRIPCION 35, LA REELECCION COMO SECRETARIO NO CONSEJERO POR 5 A脩OS DE ALFONSO LOPEZ JURADOROMERO DE LA CRUZ. Datos registrales. T 2502 , F 223, S 8, H M 43699, I/A 35 (19.09.14).
24 de Noviembre de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 824.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 206.000,00 Euros. Datos registrales. T 2502 , F224, S 8, H M 43699, I/A 36 (16.11.15).
29 de Septiembre de 2014Reelecciones. Consejero: RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN AUREO. Presidente: RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN AUREO.Consejero: OLLERO GONZALEZ JUAN;DE MOYA ANEGON JOSE MARIA. Datos registrales. T 2502 , F 223, S 8, H M 43699, I/A35 (19.09.14).
07 de Octubre de 2013Ampliacion del objeto social. Organizaci贸n, promoci贸n y realizaci贸n de cursos de formaci贸n y de actividades de educaci贸n y confines educativos, resenciales, a distancia o por Internet; as铆 como la preparaci贸n y realizaci贸n de todo el material educativocorrespondiente, con la consiguiente coordinaci贸n de los medios. Datos registrales. T 2502 , F 223, S 8, H M 43699, I/A 34(30.09.13).
31 de Mayo de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 188.600,00 Euros. Desembolsado: 188.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.030.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.030.000,00 Euros. Otros conceptos: RENUMERACION Y REASIGNACION DE TODAS LASACCIONES QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL Datos registrales. T 2502 , F 221, S 8, H M 43699, I/A 33 (22.05.12).
09 de Junio de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 180.300,00 Euros. Desembolsado: 180.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 841.400,00 Euros.Resultante Desembolsado: 841.400,00 Euros. Datos registrales. T 2502 , F 220, S 8, H M 43699, I/A 32 (30.05.11).
07 de Junio de 2011Cambio de domicilio social. C/ JOSE ABASCAL 57 - 5潞 B (MADRID). Datos registrales. T 2502 , F 220, S 8, H M 43699, I/A 31(26.05.11).
29 de Diciembre de 2009Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 300.500,00 Euros. Desembolsado: 300.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 661.100,00 Euros.Resultante Desembolsado: 661.100,00 Euros. Datos registrales. T 2502 , F 218, S 8, H M 43699, I/A 30 (15.12.09).
18 de Marzo de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: OLLERO GONZALEZ JUAN. Revocaciones. Apoderado: PLANA GINER ALFREDO;DE LAPARRA GONZALEZ EDUARDO ENRIQUE;DIEZ MANTECA JOSE MARIA;VILLANUEVA DOMINGUEZ JUAN PABLO;NIETOBERMEJO RAMIRO;OLLERO GONZALEZ JUAN;VILLANUEVA DOMINGUEZ JUAN PABLO;TONEU PUIGDEMUNTSANTIAGO;OLLERO GONZALEZ JUAN;VILLANUEVA DOMINGUEZ JUAN PABLO;SOUTO FRAGA MIGUEL ANGEL;OLLEROGONZALEZ JUAN. Apo.Manc.: VILLANUEVA DOMINGUEZ JUAN PABLO;SOUTO FRAGA MIGUEL ANGEL;OLLERO GONZALEZJUAN. Nombramientos. Consejero: RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN AUREO FRANCISCO. Presidente: RUIZ DE VILLA GOMEZSETIEN AUREO FRANCISCO. Consejero: OLLERO GONZALEZ JUAN;DE MOYA ANEGON JOSE MARIA. SecreNoConsj: LOPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ ALFONSO. Apoderado: RUIZ DE VILLA GOMEZ SETIEN AUREO;OLLERO GONZALEZ JUAN;DEMOYA ANEGON JOSE MARIA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejode administraci贸n. Otros conceptos: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T2502 , F 215, S 8, H M 43699, I/A 29 ( 6.03.09).