Actos BORME de Servicios Del Automovil Sa
28 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO;IO SHEEHAN JUNKO;COLE BRIAN ROY. Disoluci贸n.Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 36516 , F 123, S 8, H M 136940, I/A 30 (20.12.18).
28 de Junio de 2018Nombramientos. Apoderado: GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO;LOPEZ FERNANDEZ JULIA;BARNUSELL CORONADOJORGE. Datos registrales. T 36516 , F 122, S 8, H M 136940, I/A 29 (21.06.18).
19 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO. Nombramientos. Adm. Solid.: PORTEROSMA脩UECO LIBORIO ALVARO;IO SHEEHAN JUNKO;COLE BRIAN ROY. Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 10Bis. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales.T 36516 , F 122, S 8, H M 136940, I/A 28 (12.12.17).
16 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apoderado: GARCIA NEBREDA VICTOR JOSE;LHEDAT SL;FAONHER SL;ONIEVA HERRERO ANTONIO;ONIEVAHERRERO CARLOS;HERRERO DE LUCAS DANIEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: AZNAR MORENO MARIA DELMAR;ARAUZO ARRANZ JESUS JULIAN;GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO;LOPEZ FERNANDEZ JULIA. Datos registrales. T8498 , F 174, S 8, H M 136940, I/A 27 ( 7.11.17).
21 de Septiembre de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ATEN OIL SETOR SL. Datos registrales. T 8498 , F 174, S 8, H M 136940, I/A 26 (7.09.17).
14 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Presidente: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Consejero: ONYHER SL;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS.Con.Delegado: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Consejero: DE LUCAS VALDOR MILAGROS. Secretario: ONYHER SL.Representan: ONIEVA LLORD CRISTINA. Nombramientos. Adm. Unico: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO.Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 10 de los Estatutos Sociales y creado el art铆culo 10 bis.. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 8498 , F 173, S 8, H M136940, I/A 25 ( 6.09.17).
13 de Marzo de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 200.040,00 Euros. Resultante Suscrito: 250.050,00 Euros. Datos registrales. T 8498 , F173, S 8, H M 136940, I/A 24 ( 3.03.17).
28 de Mayo de 2015Reelecciones. Presidente: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Consejero: ONYHER SL;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS.Con.Delegado: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Consejero: DE LUCAS VALDOR MILAGROS. Secretario: ONYHER SL.Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 27潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 8498 , F172, S 8, H M 136940, I/A 23 (20.05.15).
16 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GIL MARTIN CARLOS. Datos registrales. T 8498 , F 170, S 8, H M 136940, I/A 20 ( 7.05.13).
Ceses/Dimisiones. Representan: ONIEVA HERRERO ANTONIO JULIO. Cons.Del.Sol: ONYHER SL. Consejero: HERRERO MU脩OZANGEL. Secretario: HERRERO MU脩OZ ANGEL. Cons.Del.Sol: HERRERO MU脩OZ ANGEL. Nombramientos. Representan:ONIEVA LLORD CRISTINA. Consejero: DE LUCAS VALDOR MILAGROS. Secretario: ONYHER SL. Datos registrales. T 8498 , F170, S 8, H M 136940, I/A 21 ( 7.05.13).
Nombramientos. Apoderado: ONIEVA HERRERO ANTONIO;ONIEVA HERRERO CARLOS;HERRERO DE LUCAS DANIEL. Datosregistrales. T 8498 , F 171, S 8, H M 136940, I/A 22 ( 7.05.13).
08 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: GIL MARTIN CARLOS. Nombramientos. Presidente: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS.Reelecciones. Representan: ONIEVA HERRERO ANTONIO JULIO. Consejero: GIL MARTIN CARLOS. Cons.Del.Sol: ONYHER SL.Consejero: ONYHER SL;HERRERO MU脩OZ ANGEL. Secretario: HERRERO MU脩OZ ANGEL. Cons.Del.Sol: HERRERO MU脩OZANGEL. Consejero: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Con.Delegado: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Ampliaci贸n decapital. Suscrito: 385.077,00 Euros. Desembolsado: 385.077,00 Euros. Resultante Suscrito: 450.090,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 450.090,00 Euros. Datos registrales. T 8498 , F 170, S 8, H M 136940, I/A 19 (25.03.10).
11 de Diciembre de 2009Nombramientos. Consejero: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Con.Delegado: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Datosregistrales. T 8498 , F 169, S 8, H M 136940, I/A 18 ( 1.12.09).