Actos BORME de Servicios Gasista Sa
09 de Junio de 2022Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ SOTO NIEVES. Apo.Sol.: GONZALEZ SOTO NIEVES;GONZALEZ SOTO ANA;GONZALEZVILLA ALADINO. Apo.Manc.: GONZALEZ SOTO NIEVES;GONZALEZ SOTO ANA;GONZALEZ VILLA ALADINO;GONZALEZ SOTOBELEN. Datos registrales. T 4096 , F 204, S 8, H M 68103, I/A 56 ( 2.06.22).
28 de Marzo de 2022Cambio de domicilio social. C/ ORTEGA Y GASSET 5 - 2潞 DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 4096 , F 204, S 8, H M68103, I/A 55 (21.03.22).
11 de Agosto de 2021Reelecciones. Consejero: GONZALEZ SOTO ISABEL;GONZALEZ SOTO CELIA;GONZALEZ SOTO NIEVES;GONZALEZ SOTOBELEN;GONZALEZ SOTO ANA. Presidente: GONZALEZ SOTO BELEN. Secretario: GONZALEZ SOTO ISABEL. Datos registrales.T 4096 , F 203, S 8, H M 68103, I/A 54 ( 4.08.21).
20 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ SOTO NIEVES. Presidente: GONZALEZ SOTO NIEVES. Consejero: GONZALEZ SOTOANA. Secretario: GONZALEZ SOTO ANA. Consejero: GONZALEZ VILLA ALADINO. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ SOTOISABEL;GONZALEZ SOTO CELIA;GONZALEZ SOTO NIEVES;GONZALEZ SOTO BELEN;GONZALEZ SOTO ANA. Presidente:GONZALEZ SOTO BELEN. Secretario: GONZALEZ SOTO ISABEL. Datos registrales. T 4096 , F 202, S 8, H M 68103, I/A 52(13.09.16).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SOTO BELEN. Apo.Sol.: GONZALEZ SOTO ISABEL;GONZALEZ SOTONIEVES;GONZALEZ SOTO CELIA;GONZALEZ SOTO ANA;GONZALEZ SOTO BELEN. Apo.Manc.: GONZALEZ SOTOBELEN;GONZALEZ SOTO ISABEL;GONZALEZ SOTO NIEVES;GONZALEZ SOTO CELIA;GONZALEZ SOTO ANA. Datosregistrales. T 4096 , F 202, S 8, H M 68103, I/A 53 (13.09.16).
18 de Julio de 2016Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de los Art铆culos 5潞 y 6潞 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 4096 , F 202, S 8,H M 68103, I/A 51 ( 7.07.16).
26 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ SOTO ANA. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ SOTO NIEVES. Presidente:GONZALEZ SOTO NIEVES. Consejero: GONZALEZ SOTO ANA. Secretario: GONZALEZ SOTO ANA. Consejero: GONZALEZ VILLAALADINO. Apo.Man.Soli: GONZALEZ SOTO NIEVES;GONZALEZ VILLA ALADINO;GONZALEZ SOTO ANA. Modificacionesestatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social .-. Art铆culo de los estatutos: 16. Administraci贸n y Representacion.-. 17.Duraci贸n del 贸rgano de administraci贸n .-y 18 , 19 , 20y 21.. Cambio de objeto social. La adquisici贸n y compra venta y enajenaci贸n ,gesti贸n y administraci贸n , arrendamiento , la parcelaci贸n , tenencia y explotaci贸n de toda clase de inmubles... Datos registrales. T4096 , F 200, S 8, H M 68103, I/A 50 (13.01.12).
24 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SOTO ANA. Datos registrales. T 4096 , F 198, S 8, H M 68103, I/A 48 (12.01.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ SOTO NIEVES;GONZALEZ SOTO ANA;GONZALEZ VILLA ALADINO. Presidente:GONZALEZ SOTO NIEVES. Secretario: GONZALEZ SOTO ANA. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ SOTO ANA.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. 16.Administraci贸n y Representacion.-. 17. Administraci贸ny Representacion.-. 18. Administraci贸n y Representacion.-. 19. Administraci贸n yRepresentacion.-. 20. Administraci贸ny Representacion.-. 21. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 4096 , F 199, S8, H M 68103, I/A 49 (12.01.12).
30 de Junio de 2010Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ SOTO NIEVES;PEREZ MEDINA GUILLERMO;GONZALEZ SOTO ANA;GONZALEZ SOTO
17 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SOTO NIEVES. Apo.Sol.: GONZALEZ SOTO NIEVES;GONZALEZ SOTOANA;GONZALEZ VILLA ALADINO. Apo.Manc.: GONZALEZ SOTO NIEVES;GONZALEZ SOTO ANA;GONZALEZ VILLAALADINO;GONZALEZ SOTO BELEN. Datos registrales. T 4096 , F 196, S 8, H M 68103, I/A 46 ( 7.06.10).