Actos BORME de Servicios Para La Agricultura Del Sur Sl
04 de Mayo de 2018Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 926 , F 224, S 8, H H 18547, I/Acierr (16.03.18).
04 de Mayo de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: ZABALA FERNANDEZ GORKA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ BILBAO ANA. Datosregistrales. T 926 , F 223, S 8, H H 18547, I/A 14 (17.04.17).
05 de Mayo de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARANZAZU DOPICO RUIZ MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIAZ LARRIETAKOLDOBIKA;HERRERUELA TELLEZ MARTA ISABEL. Datos registrales. T 926 , F 223, S 8, H H 18547, I/A 13 ( 7.04.16).
09 de Diciembre de 2013Otros conceptos: Practicado el DEPOSITO DE CUENTAS CONSOLIDADO de la Sociedad de esta hoja, en el Registro Mercantil deVIZCAYA, siendo la Sociedad dominante BERGE Y COMPAÑIA, SOCIEDAD ANONIMA, perteneciente al ejercicio 2012 , con elnúmero 9664, de fecha 22 de julio de 2013. Huelva, a 29 de noviembre de 2013. Datos registrales. T 926 , F 179, S 8, H H 18547,H ,I/ NOTA .D.)29111313.
16 de Octubre de 2013Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SL. Datos registrales. T 926 , F 222, S 8, H H 18547,H , I/ 11 .( 2.10.13).
23 de Enero de 2013Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SL. Datos registrales. T 926 , F 222, S 8, H H 18547,H , I/ 10 .(27.12.12).
19 de Diciembre de 2012Otros conceptos: Se modifica la redacción de los artículos 6º y 6º bis de losEstatutos Sociales. Datos registrales. T 926 , F 222, S8, H H 18547,H , I/ 9 .(27.11.12).
10 de Febrero de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: AGUIRRE AGURREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;IGLESIASSANZ ALBERTO;MUÑOZ CUEVAS FERNANDO;RIVERA LATAS ISABEL;GARCIA TEMPRANO MAHEY;MARTIN CORPACRISTINA;ORDOÑEZ PEREZ MARIA JOSE;CEPEDA BAZA VANESSA;PEREZ DEL NOTARIO PUENTE ELENA;CERONECHEVARRIA SOLEDAD. Datos registrales. T 926 , F 221, S 8, H H 18547,H , I/ 8 .(31.01.12).
04 de Julio de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUIRRE AGUIRREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;GOMEZDE SALAZAR DE VIANA BELEN;GONZALEZ TOJO ANDRES;ARANZAZU DOPICO RUIZ MARIA;ZABALA FERNANDEZ GORKA.Datos registrales. T 926 , F 221, S 8, H H 18547,H , I/ 7 .(20.06.11).
14 de Diciembre de 2010Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUIRRE AGURREZABAL JUAN;AGUIRRE OLORIZ IGNACIO;BELLO ALVAREZ ALICIA;IGLESIASSANZ ALBERTO;MUÑOZ CUEVAS FERNANDO;RIVERA LATAS ISABEL;GARCIA TEMPRANO MAHEY;MARTIN CORPACRISTINA;ORDOÑEZ PEREZ MARIA JOSE;CEPEDA BAZA VANESSA;PEREZ DEL NOTARIO PUENTE ELENA;CERONECHEVARRIA SOLEDAD. Datos registrales. T 926 , F 220, S 8, H H 18547,H , I/ 6 .(30.11.10).
25 de Octubre de 2010Nombramientos. Auditor: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SL. Datos registrales. T 926 , F 219, S 8, H H 18547,H , I/ 5.(11.10.10).
18 de Junio de 2010Otros conceptos: Se modifica el artículo 6º de los Estatutos Sociales y se añade el artículo 6º bis a los mismos. Datos registrales. T926 , F 219, S 8, H H 18547,H , I/ 3 .( 7.06.10).
Revocaciones. Apoderado: BARRIO ALVAREZ ANGEL CARLOS DEL;BARRIO ALVAREZ ANGEL CARLOS DEL. Datosregistrales. T 926 , F 219, S 8, H H 18547,H , I/ 4 .( 7.06.10).
21 de Mayo de 2010Cambio de domicilio social. POLIG NUEVO PUERTO S/N (PALOS DE LA FRONTERA). Datos registrales. T 926 , F 179, S 8, H H18547,H , I/ 1 .(10.05.10).
Cambio de domicilio social. POLIG NUEVO PUERTO S/N (PALOS DE LA FRONTERA). Datos registrales. T 926 , F 218, S 8, H H18547,H , I/ 2 .(10.05.10).
13 de Abril de 2010Otros conceptos: Extendida Diligencia Provisional de Cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberseexpedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de HUELVA.- Datos registrales. T 3624 ,F 191, S 8, H SE 13198, I/A 42 A (22.03.10).