Buscador CIF Logo

Actos BORME Servicios Sociales De Telecomunicaciones Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Servicios Sociales De Telecomunicaciones Sl

Actos BORME Servicios Sociales De Telecomunicaciones Sl - B83936922

Tenemos registrados 47 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Servicios Sociales De Telecomunicaciones Sl con CIF B83936922

馃敊 Perfil de Servicios Sociales De Telecomunicaciones Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Servicios Sociales De Telecomunicaciones Sl

23 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: INGELMO DE LA MATA JOAQUIN;GOMEZ RODRIGUEZ REYES;PEREZ DEL PULGAR LORITZPATRICIA;PARRADO SANCHEZ ROSANA;LIMON VAZQUEZ JUAN ANTONIO;DIEGO PERI脩AN ROSA MARIA;DURO RAMOSMARIA ANGELES;RAMIREZ PUENTE SONIA;BORREGO ESPARRAGO MARIA SOLEDAD;DAVILA MORENO CARMEN;GOMEZCARRASCAL CRISTINA;CAPUCHINO CASANOVA ELISA;VIDAL SEARA ANITA;MARINAS AGUADO GEMA;GUIMAREY TOUCEDAJOSEFINA;PEREZ NIETO CARMEN;REDONDO FERNANDEZ ESTRELLA;ZAPATERO HITA BARBARA;LLAGUNO GARCIAAMAYA;GARCIA CABRERIZO MARIA ROSARIO;HERVAS MARTINEZ JOSE;ROMERO CAMINO MARIA DOLORES;ALMANSAFERNANDEZ FERNANDO;ESCUDERO REY MARIA DEL PILAR;GOMEZ CARROZA ENRIQUE;GONZALEZ COLLADOSILVIA;GARCIA BETANCOR MARTA ANDREA;GARCIA DEL POTRO SANDRA;ANDRES PE脩A PAULA;VENTAS CURIELSERGIO;ABAD SOTO JORGE;PEREZ CAYUELA ELENA;BARCELO BLANCO STEGER JOSE LUIS;ARNAEZ RUIZLAURA;BASILDO ALVAREZ JUAN CARLOS;PONCELA MORENO SUSANA;VASQUEZ GONZALEZ VIVIAN CAROLINA;TORANZOMEDIERO LAURA ISABEL;ALMANSA RAMIREZ JORGE;DEL CAMPO ALVAREZ DIEGO;BENAVIDES MARTINEZ MARIA DEL MAR.Datos registrales. T 44443 , F 94, S 8, H M 352054, I/A 54 (16.11.23).

15 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARRO HERNANDEZ IGNACIO. Datos registrales. T 44443 , F 94, S 8, H M 352054, I/A 53 (8.02.23).

25 de Enero de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: PEDROTE GARCIA FERNANDO-CARLOS. Apo.Sol.: PEDROTE GARCIA FERNANDO-CARLOS;CAMARENA GONZALEZ JOSE LUIS. Apo.Manc.: CAMARENA GONZALEZ JOSE LUIS;REDONDO UTRILLA JESUS.Apo.Sol.: REDONDO UTRILLA JESUS;BIDAURRAZAGA MARIJUAN NEREA. Apo.Manc.: BIDAURRAZAGA MARIJUANNEREA;DAVILA MORENO CARMEN. Apo.Sol.: DAVILA MORENO CARMEN;DE LOS RIOS VARELA DAVID CRISTIAN. Apo.Manc.:DE LOS RIOS VARELA DAVID CRISTIAN. Datos registrales. T 34866 , F 174, S 8, H M 352054, I/A 45 (18.01.23).

Nombramientos. Apo.Manc.: PISTON RODRIGUEZ CARMEN. Apo.Sol.: PISTON RODRIGUEZ CARMEN. Datos registrales. T34866 , F 175, S 8, H M 352054, I/A 46 (18.01.23).

Revocaciones. Apoderado: DELGADO FERNANDEZ SUSANA;PEREZ PLANO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 34866 , F 175,S 8, H M 352054, I/A 47 (18.01.23).

Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ FIDALGO CESAR ALEJANDRO. Apo.Sol.: FERNANDEZ FIDALGO CESARALEJANDRO. Datos registrales. T 34866 , F 175, S 8, H M 352054, I/A 48 (18.01.23).

Nombramientos. Apo.Manc.: SANCHEZ HERRAN SUSANA. Apo.Sol.: SANCHEZ HERRAN SUSANA. Datos registrales. T 34866 ,F 177, S 8, H M 352054, I/A 49 (18.01.23).

Nombramientos. Apo.Manc.: DIAZ GARRIDO NURIA. Apo.Sol.: DIAZ GARRIDO NURIA. Datos registrales. T 34866 , F 178, S 8, HM 352054, I/A 50 (18.01.23).

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CHICO IVAN. Datos registrales. T 34866 , F 179, S 8, H M 352054, I/A 51 (18.01.23).

Nombramientos. Apoderado: MOLINUEVO CANO MARIA BEGO脩A. Datos registrales. T 34866 , F 179, S 8, H M 352054, I/A 52(18.01.23).

23 de Enero de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAVARRO HIGUERA MERCEDES;PALMERO MANGADO VIRGINIA;INGELMO DE LA MATAJOAQUIN. Datos registrales. T 34866 , F 173, S 8, H M 352054, I/A 42 (16.01.23).

Nombramientos. Apoderado: VILLA OTERMIN CARLOS. Datos registrales. T 34866 , F 174, S 8, H M 352054, I/A 43 (16.01.23).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GRUPO ILUNION SL. Datos registrales. T 34866 , F 174, S 8, H M352054, I/A 44 (16.01.23).

19 de Enero de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE AZCOITIA BORGHI LUIS. Nombramientos. Adm. Mancom.: GRUPO ILUNION SL;ILUNIONCEE CONTACT CENTER SA. Representan: FERNANDEZ FIDALGO CESAR ALEJANDRO;SANCHEZ HERRAN SUSANA.Modificaciones estatutarias. Se otorga un nuevo texto de estatutos sociales. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores mancomunados. Cambio de objeto social. Servicios de atenci贸n einformaci贸n telef贸nica, campa帽as de promociones, asesoramiento a empresas e Instituciones, coordinaci贸n de sistemas operativos,marketing telef贸nico y venta por tel茅fono... electr贸nico, servicios de marketing y estudios de mercado, realizaci贸n de encuestas y, engenera. Datos registrales. T 34866 , F 168, S 8, H M 352054, I/A 41 (12.01.23).

01 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 34866 , F 168, S 8, H M 352054, I/A 40 (24.11.22).

15 de Diciembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE AZCOITIA BORGHI LUIS. Adm. Solid.: DE AZCOITIA BORGHI LUIS;PEREZ PLANO JOSEJAVIER. Nombramientos. Adm. Solid.: DE AZCOITIA BORGHI LUIS;PEREZ PLANO JOSE JAVIER. Adm. Unico: DE AZCOITIABORGHI LUIS. Datos registrales. T 34866 , F 167, S 8, H M 352054, I/A 39 ( 7.12.21).

19 de Noviembre de 2021
Reelecciones. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 34866 , F 167, S 8, H M 352054, I/A 38 (12.11.21).

19 de Febrero de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARRO HERNANDEZ IGNACIO. Datos registrales. T 34866 , F 166, S 8, H M 352054, I/A 37(12.02.21).

16 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 34866 , F 166, S 8, H M 352054, I/A 36 ( 6.11.20).

26 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 34866 , F 166, S 8, H M 352054, I/A 35 (19.11.19).

21 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: GORDO MATEOS SERGIO. Datos registrales. T 34866 , F 165, S 8, H M 352054, I/A 32 (14.10.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: GOMEZ JIMENEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 34866 , F 165, S 8, H M 352054, I/A 33(14.10.19).

Nombramientos. Apo.Manc.: ECHAVARRI MACON FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 34866 , F 165, S 8, H M 352054, I/A34 (14.10.19).

24 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 34866 , F 164, S 8, H M 352054, I/A 31 (16.10.18).

30 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 34866 , F 164, S 8, H M 352054, I/A 30 (22.11.17).

29 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DE LA TORRE VAZQUEZ CARLOS FELIPE. Datos registrales. T 34866 , F 163, S 8, H M352054, I/A 28 (21.11.17).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ PLANO JOSE JAVIER. Datos registrales. T 34866 , F 163, S 8, H M 352054, I/A 29(21.11.17).

11 de Mayo de 2017
Reelecciones. Auditor: ETL SPAIN AUDIT SERVICES SL. Datos registrales. T 34866 , F 163, S 8, H M 352054, I/A 27 ( 3.05.17).

14 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ DE LA TORRE VAZQUEZ CARLOS FELIPE. Nombramientos. Adm. Unico: DE AZCOITIABORGHI LUIS. Datos registrales. T 34866 , F 162, S 8, H M 352054, I/A 25 ( 6.02.17).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE LA TORRE VAZQUEZ CARLOS FELIPE. Datos registrales. T 34866 , F 162, S 8, H M352054, I/A 26 ( 6.02.17).

03 de Enero de 2017
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ MOLINA PASCUAL;GONZALEZ MOLINA PASCUAL. Apo.Manc.: GONZALEZ MOLINAPASUCAL. Datos registrales. T 34866 , F 161, S 8, H M 352054, I/A 24 (23.12.16).

11 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: GOMEZ JIMENEZ JOSE LUIS;ECHAVARRI MACON FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T34866 , F 161, S 8, H M 352054, I/A 23 ( 3.11.16).

30 de Agosto de 2016
Modificaciones estatutarias. Refundici贸n de los Estatutos Sociales.. Ampliacion del objeto social. La sociedad tiene porobjeto lossiguientes actividades: - Servicios de atenci贸n e informaci贸n telef贸nico, campa帽as de promociones, asesoramiento a empresas einstituciones, coordinaci贸n de sistemas operativos, marketing telef贸nico y venta por tel茅fono, comercio electr贸nico, servicios demarketing. Datos registrales. T 31018 , F 109, S 8, H M 352054, I/A 22 (22.08.16).

03 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: ECHAVARRI MACON FRANCISCO JAVIER;GOMEZ JIMENEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T31018 , F 109, S 8, H M 352054, I/A 21 (27.07.16).

17 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: CORRAL SOUSA MARIA ROCIO. Datos registrales. T 31018 , F 109, S 8, H M 352054, I/A 20(10.11.15).

26 de Octubre de 2015
Nombramientos. Apoderado: CARMONA CARRION VIRGINIA. Datos registrales. T 31018 , F 108, S 8, H M 352054, I/A 19(19.10.15).

08 de Septiembre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 50.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.050.000,00 Euros. Datos registrales. T 31018 , F 108, S 8,H M 352054, I/A 18 (28.08.15).

27 de Enero de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 50.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 31018 , F 107, S 8,H M 352054, I/A 17 (19.01.15).

17 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MENDOZA DE LA ROSA VICTOR RAUL. Nombramientos. Adm. Unico: LOPEZ DE LA TORREVAZQUEZ CARLOS FELIPE. Datos registrales. T 31018 , F 107, S 8, H M 352054, I/A 15 ( 6.10.14).

Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ MOLINA PASUCAL;ECHAVARRI MACON FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T31018 , F 107, S 8, H M 352054, I/A 16 ( 8.10.14).

24 de Febrero de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 950.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.950.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culode los estatutos: 5. Capital.-. REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 31018 , F 105, S 8, H M352054, I/A 14 (17.02.14).

11 de Septiembre de 2013
Modificaciones estatutarias. 1. Quedan refundidos los Estatutos sociales.. Cambio de objeto social. - Servicios de atenci贸n einformaci贸n telef贸nica, campa帽as de promociones, asesoramiento a empresas e Instituciones, coordinaci贸n de sistemas operativos,marketing telef贸nico y venta por tel茅fono, comercio electr贸nico, servicios de marketing y estudios de mercado, realizaci贸n de encuestasy, .. Datos registrales. T 31018 , F 103, S 8, H M 352054, I/A 13 ( 2.09.13).

21 de Agosto de 2013
Reelecciones. Auditor: AUDITORES CINCO SLP. Datos registrales. T 31018 , F 103, S 8, H M 352054, I/A 12 (12.08.13).

11 de Julio de 2013
Reelecciones. Adm. Unico: MENDOZA DE LA ROSA VICTOR RAUL. Datos registrales. T 19964 , F 17, S 8, H M 352054, I/A 11 (4.07.13).

13 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Auditor: AUDITORES CINCO SLP. Datos registrales. T 19964 , F 17, S 8, H M 352054, I/A 9 (31.08.11).

20 de Enero de 2011
Modificaciones estatutarias. MODIFICADOS LOS ARTS. 1潞, 2潞, 8潞 Y 14潞 DE LOS ESTATUTOS Y REFUNDIDO EL TEXTO DEESTOS.. Cambio de objeto social. Servicios de atenci贸n al cliente tanto presenciales como por tele operaci贸n. Servicios deconserjer铆a, recpci贸n, ordenanzas, atenci贸 de centralitas telef贸nicas. Servicios de informeci贸n, campa帽as de promoci贸n, venta portel茅fono, estudios de mercado y sondeos realizados telef贸nicamente. Datos registrales. T 19964 , F 15, S 8, H M 352054, I/A 8(10.01.11).

02 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ MOLINA PASCUAL. Datos registrales. T 19964 , F 14, S 8, H M 352054, I/A 6 (22.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n