Buscador CIF Logo

Actos BORME Servicios Tecnologicos Singulares Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Servicios Tecnologicos Singulares Sa

Actos BORME Servicios Tecnologicos Singulares Sa - A28653681

Tenemos registrados 28 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Servicios Tecnologicos Singulares Sa con CIF A28653681

馃敊 Perfil de Servicios Tecnologicos Singulares Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Servicios Tecnologicos Singulares Sa

04 de Marzo de 2019
Extinci贸n. Datos registrales. T 30838 , F 71, S 8, H M 66553, I/A 62 (25.02.19).

08 de Mayo de 2017
Cambio de domicilio social. C/ AZUL 4 - CIUDAD BBVA (MADRID). Datos registrales. T 30838 , F 71, S 8, H M 66553, I/A 60(26.04.17).

17 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: PIZARRO BU脩UEL ADELA MARIA. Consejero: TOME MUGURUZA FRANCISCO JAVIER;DIEZCASTA脩O JOSE-JAVIER. Presidente: TOME MUGURUZA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Vicesecret.: GARCIA LOPEZELIA. Consejero: CASAS MORENO CARLOS;CONCEJO DIEZ MARIA DEL PILAR. Presidente: CASAS MORENO CARLOS. Datosregistrales. T 30838 , F 70, S 8, H M 66553, I/A 59 ( 6.10.16).

14 de Octubre de 2016
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 57陋 EL NOMBRAMIENTO COMO VICESECRETARIO NOCONSEJERO DE ABAD SAIZ DANIEL, SIENDO EL CARGO CORRECTO EL DE SECRETARIO NO CONSEJERO. Datosregistrales. T 30838 , F 69, S 8, H M 66553, I/A 57 (22.05.15).

18 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: CENICEROS CENICEROS ANTONIO JAVIER. Datos registrales. T 30838 , F 70, S 8, H M 66553,I/A 58 ( 8.01.16).

29 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ NAVARRETE LUIS. SecreNoConsj: GARCIA LOPEZ ELIA. VsecrNoConsj: COROMINASNOGAL OSCAR. Presidente: SANCHEZ NAVARRETE LUIS. Revocaciones. Apoderado: REPISO GARCIA DIANA.Nombramientos. Presidente: TOME MUGURUZA FRANCISCO JAVIER. VsecrNoConsj: ABAD SAIZ DANIEL;PIZARRO BU脩UELADELA MARIA. Consejero: TOME MUGURUZA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 30838 , F 69, S 8, H M 66553, I/A 57(22.05.15).

25 de Noviembre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30838 , F 69, S 8, H M 66553, I/A 56 (17.11.14).

02 de Junio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: JURADO JIMENEZ RICARDO;DE LA VEGA GARCIA PASTOR IGNACIO;BUENO OLALLAPATRICIA. Presidente: DE LA VEGA GARCIA PASTOR IGNACIO. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ NAVARRETE LUIS;DIEZCASTA脩O JOSE-JAVIER. Presidente: SANCHEZ NAVARRETE LUIS. Datos registrales. T 30838 , F 67, S 8, H M 66553, I/A 53(23.05.14).

Cambio de domicilio social. C/ CLARA DEL REY 26 (MADRID). Datos registrales. T 30838 , F 67, S 8, H M 66553, I/A 54(23.05.14).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LA VEGA GARCIA PASTOR IGNACIO. Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ PRETELJIMENEZ OLIVER. Datos registrales. T 30838 , F 67, S 8, H M 66553, I/A 55 (23.05.14).

22 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: CHAVARRI PADILLA ELENA. VsecrNoConsj: DE NICOLAS Y DE BENITO JACOBO.Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA LOPEZ ELIA. VsecrNoConsj: COROMINAS NOGAL OSCAR. Datos registrales. T 30838, F 65, S 8, H M 66553, I/A 52 (15.04.13).

20 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ NAVARRETE LUIS;DIEZ CASTA脩O JOSE-JAVIER. Presidente: JURADO JIMENEZRICARDO. Nombramientos. Consejero: CENICEROS CENICEROS ANTONIO JAVIER;FERNANDEZ PRETEL JIMENEZ OLIVER.Presidente: DE LA VEGA GARCIA PASTOR IGNACIO. Datos registrales. T 26304 , F 59, S 8, H M 66553, I/A 50 (11.03.13).

Revocaciones. Apoderado: VILLARIN OPDYKE PENELOPE-ALEJANDRA. Apo.Man.Soli: JURADO JIMENEZ RICARDO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA VEGA GARCIA PASTOR IGNACIO. Datos registrales. T 26304 , F 59, S 8, H M 66553, I/A51 (11.03.13).

17 de Agosto de 2012
Modificaciones estatutarias. 16. Funcionamiento Junta Gral.- convocatoria. Otros conceptos: Alta sede electr贸nica:www.bbvaservitecsa.com. Datos registrales. T 26304 , F 58, S 8, H M 66553, I/A 49 ( 7.08.12).

01 de Marzo de 2012
Revocaciones. Apoderado: DIEZ BAEZ MARIA CARMEN. Apo.Man.Soli: QUILEZ BOVER ARANZAZU. Nombramientos.Apo.Man.Soli: GONZALEZ SANCHEZ-BRUNETE DAVID ANTONIO. Datos registrales. T 26304 , F 56, S 8, H M 66553, I/A 48(20.02.12).

14 de Febrero de 2012
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 26304 , F 56, S 8, H M 66553, I/A 47 ( 2.02.12).

18 de Agosto de 2011
Nombramientos. Apo.Sol.: BEADE LOPEZ ALFONSO. Datos registrales. T 26304 , F 55, S 8, H M 66553, I/A 46 ( 4.08.11).

09 de Mayo de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE PARIAS HALCON CRISTINA. Presidente: DE PARIAS HALCON CRISTINA. Consejero: AGUILARSOLER ALVARO;HERNANDEZ RILOVA ANGEL. Nombramientos. Consejero: JURADO JIMENEZ RICARDO;DE LA VEGA GARCIAPASTOR IGNACIO;DIEZ CASTA脩O JOSE-JAVIER;BUENO OLALLA PATRICIA. Presidente: JURADO JIMENEZ RICARDO. Datosregistrales. T 26304 , F 51, S 8, H M 66553, I/A 44 (26.04.11).

Revocaciones. Apoderado: DE PARIAS HALCON CRISTINA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: JURADO JIMENEZ RICARDO.Datos registrales. T 26304 , F 53, S 8, H M 66553, I/A 45 (26.04.11).

21 de Febrero de 2011
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 90.300,00 Euros. Desembolsado: 90.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 150.500,00 Euros.Resultante Desembolsado: 150.500,00 Euros. Datos registrales. T 26304 , F 51, S 8, H M 66553, I/A 43 ( 8.02.11).

06 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: MALDONADO GOMEZ APARICI IGNACIO. Nombramientos. Consejero: SANCHEZ NAVARRETELUIS;HERNANDEZ RILOVA ANGEL. Datos registrales. T 26304 , F 51, S 8, H M 66553, I/A 42 (27.07.10).

22 de Junio de 2010
Revocaciones. Apoderado: IGLESIAS DEL CAMPO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 26304 , F 50, S 8, H M 66553, I/A 41(11.06.10).

19 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: IGLESIAS DEL CAMPO FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 26304 , F 50, S 8, H M 66553, I/A40 ( 9.02.10).

11 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: EAVES FERNANDEZ MARK ANDREW;QUILEZ BOVER ARANZAZU. Datos registrales. T 26304 ,F 49, S 8, H M 66553, I/A 39 (30.11.09).

21 de Agosto de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ PELLICO EUGENIO. Datos registrales. T 26304 , F 48, S 8, H M 66553, I/A 38 (12.08.09).

16 de Julio de 2009
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: PALACIO BERMUDEZ DE CASTRO ELIAS. Nombramientos. SecreNoConsj: CHAVARRIPADILLA ELENA. VsecrNoConsj: DE NICOLAS Y DE BENITO JACOBO. Datos registrales. T 26304 , F 48, S 8, H M 66553, I/A 37 (3.07.09).

13 de Abril de 2009
Nombramientos. Apoderado: GUERRICABEITIA IGARTUA JOSE FELIX;BA脩ALES PASCUAL JOSE RAMON. Datos registrales. T26304 , F 47, S 8, H M 66553, I/A 36 (30.03.09).

10 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN ESQUIVEL MIGUEL ANGEL;BARCA CASADO MARIA ISABEL;DE MATOS FILIPE SIMOESLUIS MIGUEL;SICILIA CAVANILLAS EDUARDO. Presidente: SICILIA CAVANILLAS EDUARDO. Revocaciones. Apo.Sol.: DIEZBAEZ MARIA CARMEN. Apo.Man.Soli: SICILIA CAVANILLAS EDUARDO. Apo.Manc.: IGLESIAS DEL CAMPO FRANCISCO JOSE.Apo.Sol.: GARCIA MONTES IRENE;REPISO GARCIA DIANA. Apoderado: IGLESIAS DEL CAMPO FRANCISCO JOSE;RUEDAGARGOLES MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: DE PARIAS HALCON CRISTINA. Presidente: DE PARIAS HALCONCRISTINA. Consejero: MALDONADO GOMEZ APARICI IGNACIO;RUIZ PELLICO EUGENIO;AGUILAR SOLER ALVARO. Apoderado:DE PARIAS HALCON CRISTINA;IGLESIAS DEL CAMPO FRANCISCO JOSE;DIEZ BAEZ MARIA CARMEN;VILLARIN OPDYKEPENELOPE-ALEJANDRA;RUEDA GARGOLES MIGUEL ANGEL;REPISO GARCIA DIANA. Datos registrales. T 19074 , F 225, S 8,H M 66553, I/A 35 (30.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n