Actos BORME de Servicios Y Reparaciones Sa
27 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: BARRIONUEVO POLO CARMEN;DE LA CIERVA GALNARES JUAN;DIAZ LORENTE ANTONIO.Apo.Sol.: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID LUIS. Apo.Man.Soli: CANELO GOMEZ JORGE. Nombramientos. Apo.Man.Soli:BARRIONUEVO POLO CARMEN;DE LA CIERVA GALNARES JUAN;CANELO GOMEZ JORGE;DIAZ LORENTE ANTONIO. Datosregistrales. T 6965 , F 6, S 8, H SE 2510, I/A 111 (20.10.23).
28 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ CONDE JOSE. Datos registrales. T 6965 , F 5, S 8, H SE 2510, I/A 110 (21.09.23).
28 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: LIÑAN MACIAS DANIEL. Apo.Man.Soli: LIÑAN MACIAS DANIEL. Datos registrales. T 6965 , F 5, S 8, HSE 2510, I/A 109 (20.12.22).
Reelecciones. Con.Delegado: G MAS C HISPALENSE SL. Datos registrales. T 6965 , F 5, S 8, H SE 2510, I/A 108 (20.12.22).
09 de Agosto de 2022Reelecciones. Presidente: G MAS C HISPALENSE SL. Consejero: G MAS C HISPALENSE SL. Datos registrales. T 6965 , F 4, S 8,H SE 2510, I/A 107 ( 2.08.22).
07 de Abril de 2022Modificaciones estatutarias. 12 BIS. Relativo a la convocatoria de la junta.. 13 BIS. Relativo al consejo de administración. . Artículode los estatutos: 2. Objeto social.-. Cambio de objeto social. La Sociedad tendrá como objeto social la actividad inmobiliaria engeneral entendida en su más amplia acepción, incluyendo la adquisición, tenencia, administración, cesión, enajenación, yarrendamiento de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, así como la realización de actividades de promoción inmob. Datosregistrales. T 6965 , F 3, S 8, H SE 2510, I/A 106 (30.03.22).
20 de Enero de 2022Reducción de capital. Importe reducción: 143.801,98 Euros. Resultante Suscrito: 898.240,39 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- . Datos registrales. T 6965 , F 2, S 8,H SE 2510, I/A 105 (12.01.22).
16 de Noviembre de 2021Reelecciones. Consejero: MAS GALNARES ANTONIO FEDERICO;DE LA CIERVA GALNARES JUAN;GALNARES GONZALEZ DELA MADRID LUIS. Datos registrales. T 6965 , F 1, S 8, H SE 2510, I/A 103 ( 9.11.21).
Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 6965 , F 2, S 8, H SE 2510, I/A 104 (9.11.21).
09 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANELO GOMEZ JORGE. Otros conceptos: MODIFICADO el poder conferido por la escrituraotorgada ante el Notario don José María Florit de Carranza el día 11 de abril de 2019, número 946 de su protocolo, que motivó la ins98ª, incorporando como apoderado del Grupo 1 a DON JORGE CANELO GOMEZ con las facultades y límites de dicho Grupo 1.Datos registrales. T 6965 , F 1, S 8, H SE 2510, I/A 102 (19.08.21).
01 de Septiembre de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: CANELO GOMEZ JORGE. Otros conceptos: MODIFICADO el poder conferido por la escrituraotorgada ante el Notario don José María Florit de Carranza el día 4 de diciembre de 2020, número 2.689 de protocolo, que motivó lains 100ª incorporando a la misma como apoderado a DON JORGE CANELO GOMEZ con las facultades y límites que de ella resultan.Datos registrales. T 6965 , F 1, S 8, H SE 2510, I/A 101 (19.08.21).
30 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: PLA MARTINEZ LUIS;FERNANDEZ CONDE JOSE;GUERRERO RIVAS CARLA BEATRIZ;LOBATOVEGA LOURDES;LIÑAN MACIAS DANIEL. Nombramientos. Apo.Manc.: PLA MARTINEZ LUIS;FERNANDEZ CONDEJOSE;GUERRERO RIVAS CARLA BEATRIZ;LOBATO VEGA LOURDES;LIÑAN MACIAS DANIEL. Datos registrales. T 6067 , F 225,S 8, H SE 2510, I/A 100 (21.12.20).
12 de Junio de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: DE LA CIERVA GALNARES JUAN. Otros conceptos: La Sociedad REVOCA el PODER NO INSCRITO,conferido a favor de DON FRANCISCO GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID, en virtud de escritura autorizada en Sevilla, el día 24de septiembre de 2013, por el Notario Don José María Florit de Carranza, bajo el número 1678 de su protocolo.- Datos registrales. T6067 , F 225, S 8, H SE 2510, I/A 99 ( 5.06.19).
08 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: LIÑAN MACIAS DANIEL;BARRIONUEVO POLO CARMEN;DE LA CIERVA GALNARES JUAN;DIAZLORENTE ANTONIO. Apo.Sol.: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID LUIS. Datos registrales. T 6067 , F 222, S 8, H SE 2510,I/A 98 (29.04.19).
25 de Abril de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUBSOFF BUENO SERGIO. Datos registrales. T 6067 , F 222, S 8, H SE 2510, I/A 97 (12.04.19).
20 de Febrero de 2019Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 6067 , F 222, S 8, H SE 2510, I/A96 (13.02.19).
30 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Presidente: GALNARES GONZALEZ DE LAMADRID FRANCISCO. Con.Delegado: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: G MASC HISPALENSE SL. Presidente: G MAS C HISPALENSE SL. Con.Delegado: G MAS C HISPALENSE SL. Datos registrales. T 6067 ,
30 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: PLA MARTINEZ LUIS;FERNANDEZ CONDE JOSE;GUERRERO RIVAS CARLA BEATRIZ;LOBATOVEGA LOURDES;RUBSOFF BUENO SERGIO;LIÑAN MACIAS DANIEL. Datos registrales. T 6067 , F 221, S 8, H SE 2510, I/A 94(23.05.17).
25 de Abril de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: MAS GALNARES MIGUEL;GONZALEZ GONZALEZ MARIA CARMEN. Apoderado: GALNARESGONZALEZ DE LA MADRID LUIS. Datos registrales. T 6067 , F 220, S 8, H SE 2510, I/A 93 (18.04.17).
12 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GALNARES FERNANDEZ MANUEL;RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL;CIERVA GALNARESCARLOS DE LA;MAS GALNARES MIGUEL. Nombramientos. Consejero: MAS GALNARES ANTONIO FEDERICO;DE LA CIERVAGALNARES JUAN;GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID LUIS. Datos registrales. T 6067 , F 220, S 8, H SE 2510, I/A 92(30.08.16).
23 de Marzo de 2016Nombramientos. Con.Delegado: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Datos registrales. T 6067 , F 219, S 8, HSE 2510, I/A 91 (14.03.16).
29 de Febrero de 2016Reelecciones. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 6067 , F 219, S 8, H SE 2510, I/A 90(15.02.16).
11 de Febrero de 2016Reducción de capital. Importe reducción: 559.664,70 Euros. Resultante Suscrito: 1.042.042,37 Euros. Modificaciones estatutarias.Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- . Escisión parcial. Sociedadesbeneficiarias de la escisión: GRUPO SYRSA AUTOMOVILES S.L. Datos registrales. T 6067 , F 215, S 8, H SE 2510, I/A 89 (1.02.16).
19 de Octubre de 2015Modificaciones estatutarias. 9. Retribución. Datos registrales. T 6067 , F 215, S 8, H SE 2510, I/A 88 ( 5.10.15).
08 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: CARMEN GONZALEZ GONZALEZ;GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID MANUEL;DE LACIERVA GALNARES JAVIER;MAS GALNARES ESPERANZA MACARENA;PEREZ DE AYALA MORENO SANTAMAROA MAROATERESA ANTO;VAZQUEZ ESPINOSA MARGARITA;DE LA CIERVA GALNARES JAVIER. SecreNoConsj: DE LA CIERVAGALNARES JUAN. Nombramientos. Consejero: GALNARES FERNANDEZ MANUEL;RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL.SecreNoConsj: SILVA MEJIAS ALVARO. VsecrNoConsj: COLLADO MORENO LUIS. Reelecciones. Consejero: CIERVAGALNARES CARLOS DE LA;GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO;MAS GALNARES MIGUEL. Presidente:GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Otros conceptos: Se fija en 5 el numero de miembros del Consejo. Datosregistrales. T 3826 , F 36, S 8, H SE 2510, I/A 87 (23.09.15).
28 de Mayo de 2015Nombramientos. Auditor: AUDITORES Y CONSULTORES DEL SUR SLP. Datos registrales. T 3826 , F 35, S 8, H SE 2510, I/A 86(19.05.15).
02 de Octubre de 2013Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 12º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.SE CREA UN NUEVOARTICULO 12BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3826 , F 35, S 8, H SE 2510, I/A 85 (24.09.13).
22 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL;GALNARES FERNANDEZ MANUEL. Vicepresid.:RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL. Consejero: BORDAS MARRODAN GONZALO. Nombramientos. Consejero: PEREZ DEAYALA MORENO SANTAMARIA MARIA TERESA ANTO;VAZQUEZ ESPINOSA MARGARITA;GALNARES GONZALEZ DE LAMADRID MANUEL. Datos registrales. T 3826 , F 34, S 8, H SE 2510, I/A 84 (12.08.13).
17 de Abril de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: DE LA CIERVA GALNARES JUAN. Datos registrales. T 3826 , F 33, S 8, H SE 2510, I/A 83 (10.04.13).
05 de Octubre de 2011Fe de erratas: En el envio 77, consta que fue cesado en el cargo de consejero el señor don Manuel Fernandez Galnares, cuandodicho señor Fernandez Galnares solo fue cesado en su cargo de presidente. Datos registrales. T 3826 , F 33, S 8, H SE 2510, I/A 82(25.08.11).
08 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GALNARES FERNANDEZ MANUEL. Presidente: GALNARES FERNANDEZ MANUEL.Nombramientos. Presidente: GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO. Datos registrales. T 3826 , F 33, S 8, H SE2510, I/A 82 (25.08.11).
03 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: GALNARES FERNANDEZ MANUEL. Presidente: GALNARES FERNANDEZ MANUEL. Consejero:RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL. Vicepresid.: RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL. Consejero: MAS GALNARESESPERANZA MACARENA;CARMEN GONZALEZ GONZALEZ;BORDAS MARRODAN GONZALO;CIERVA GALNARES CARLOS DELA;GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO;MAS GALNARES MIGUEL. Nombramientos. Consejero: GALNARESFERNANDEZ MANUEL;RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL;BORDAS MARRODAN GONZALO;CIERVA GALNARES CARLOSDE LA;GALNARES GONZALEZ DE LA MADRID FRANCISCO;MAS GALNARES MIGUEL;CARMEN GONZALEZ GONZALEZ;MASGALNARES ESPERANZA MACARENA;DE LA CIERVA GALNARES JAVIER. Presidente: GALNARES FERNANDEZ MANUEL.Vicepresid.: RODRIGUEZ ARGUESO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3826 , F 32, S 8, H SE 2510, I/A 81 (24.08.10).