Actos BORME de Serviger Xxi Albacete Sl
10 de Octubre de 2023Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4461, L 4461, F 40, S 8, H PO64689, I/A 34 ( 2.10.23).
29 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4461, L 4461, F 40, S 8, H PO 64689, I/A33 (21.09.23).
18 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CA脩ERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4379, L 4379,F 198, S 8, H PO 64689, I/A 32 ( 8.08.23).
07 de Agosto de 2023Fe de erratas: Se rectifica el n煤mero de inscripci贸n del nombramiento como apoderada de Do帽a Elena Mart铆n Garc铆a, que se public贸por error, siendo el n煤mero de inscripci贸n correcta la n煤mero 31陋. Datos registrales. T 4379, L 4379, F 198, S 8, H PO 64689, I/A 31(20.07.23).
28 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA ELENA. Datos registrales. T 4379, L 4379, F 198, S 8, H PO 64689, I/A 30 (20.07.23).
27 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4379, L 4379, F 194, S 8, H PO 64689,I/A 30 (18.07.23).
24 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO QUINTELA SANDRA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNA VALENZUELA MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 4379, L 4379, F 194, S 8, H PO 64689, I/A 29 (13.07.23).
16 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIA脩EZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 4379, L 4379, F 193, S 8, H PO 64689, I/A 26 (8.06.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4379, L 4379, F 193, S 8, H PO 64689, I/A 27 (8.06.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4379, L 4379, F 192, S 8, H PO 64689, I/A 25(14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4379, L 4379, F 192, S 8, HPO 64689, I/A 24 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4379, L 4379, F 192, S 8, HPO 64689, I/A 23 (26.07.22).
20 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: SERVIGER 21 SL.Datos registrales. T 4379, L 4379, F 192, S 8, H PO 64689, I/A 22 (11.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4379, L 4379, F 192, S 8, H PO 64689, I/A 21(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4379, L 4379, F 190, S 8, H PO 64689, I/A 20(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 154, S 8, H PO 64689, I/A 19(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 154, S 8, H PO 64689, I/A 18(13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 154, S 8, H PO 64689, I/A 17 ( 7.10.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 153, S 8, H PO 64689, I/A 16 ( 8.06.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 153, S 8, H PO 64689, I/A 15(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 153, S 8, H PO64689, I/A 14 (26.04.21).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 153, S 8, H PO64689, I/A 13 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 153, S 8, H PO 64689, I/A 12(18.06.20).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 152, S 8, H PO 64689, I/A 11(16.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 152, S 8, H PO 64689, I/A 10 ( 7.05.19).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 152, S 8, H PO 64689, I/A 9 ( 2.05.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MELON CASTRO MARIA JOSE. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 151, S 8, H PO 64689, I/A 7(28.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 152, S 8, H PO 64689, I/A 8 (28.03.19).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 151, S 8, H PO 64689,I/A 6 (22.03.19).
22 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 147, S 8, H PO 64689, I/A 3(13.03.19).
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 150, S 8, H PO 64689, I/A 4(14.03.19).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4267, L 4267, F 150, S 8, H PO 64689, I/A 5(14.03.19).
05 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 BAJOS (VIGO). Datos registrales. T 4267, L 4267, F 145, S 8, H PO64689, I/A 1 (28.01.19).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 3 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T4267, L 4267, F 147, S 8, H PO 64689, I/A 2 (28.01.19).
16 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL. Datos registrales. T 1419 , F 201, S 8, H VA 24906, I/A 2 ( 9.01.19).
15 de Junio de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 15.05.12. Objeto social: La promoci贸n, construcci贸n, explotaci贸n y gesti贸n, as铆 como elasesoramiento a terceros y el equipamiento de residencias para personas de la tercera edad y/o con minusval铆as o incapacidades,asistidas, no asistidas y mixtas,etc. Domicilio: C/ MONASTERIO SAN PEDRO DE ALCANTARA 117 (VALLADOLID). Capital: 3.000,00Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SERVIGER 21 SL. Nombramientos. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO.Datos registrales. T 1419 , F 200, S 8, H VA 24906, I/A 1 ( 6.06.12).