Actos BORME de Serviger Xxi Mallorca Sl
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 219, S 8, H PO 64722, I/A 43(14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 219, S 8, HPO 64722, I/A 42 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 219, S 8, HPO 64722, I/A 41 (26.07.22).
18 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: INSTITUTO SOCIOSANITARIO SL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 218, S 8, H PO 64722, I/A 40 ( 7.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 218, S 8, H PO 64722, I/A 39(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 216, S 8, H PO 64722, I/A 38(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 216, S 8, H PO 64722, I/A 37(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 215, S 8, H PO 64722, I/A 36(13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 215, S 8, H PO 64722, I/A 35 ( 7.10.21).
14 de Octubre de 2021Otros conceptos: El socio único decida la modificación de los artículos 7º y 9º de los estatutos sociales. Datos registrales. T 4276,L 4276, F 215, S 8, H PO 64722, I/A 34 ( 4.10.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 215, S 8, H PO 64722, I/A 33 ( 8.06.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 214, S 8, H PO 64722, I/A 32
25 de Mayo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: AMER FORTEZA LOURDES. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 214, S 8, H PO 64722, I/A 30(18.05.21).
Nombramientos. Apo.Sol.: INAREJOS GIL DOMINGO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 214, S 8, H PO 64722, I/A 31(18.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 214, S 8, H PO64722, I/A 29 (26.04.21).
29 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: LEIS CARRIL ROSA MARIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 213, S 8, H PO 64722, I/A 28(21.10.20).
28 de Octubre de 2020Nombramientos. Apo.Sol.: MAS VIDAL JAUME. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 213, S 8, H PO 64722, I/A 26 (20.10.20).
28 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: CAMINO ORTEGA MARIA TERESA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 213, S 8, H PO 64722, I/A 25(18.09.20).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 212, S 8, H PO64722, I/A 24 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 212, S 8, H PO 64722, I/A 23(18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 212, S 8, H PO 64722, I/A 22 (3.04.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 212, S 8, H PO 64722, I/A 21 (15.10.19).
29 de Julio de 2019Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: INSTITUTO SOCIO SANITARIO SL. Datos registrales. T 4276, L4276, F 212, S 8, H PO 64722, I/A 20 (19.07.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 211, S 8, H PO 64722, I/A 19(16.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 211, S 8, H PO 64722, I/A 18 ( 7.05.19).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 211, S 8, H PO 64722, I/A 17 (2.05.19).
07 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CAMINO ORTEGA MARIA TERESA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 211, S 8, H PO 64722, I/A 16(29.04.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MELON CASTRO MARIA JOSE. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 170, S 8, H PO 64722, I/A 14(28.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 170, S 8, H PO 64722, I/A 15 (28.03.19).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 169, S 8, H PO 64722,I/A 13 (22.03.19).
29 de Marzo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: AMER FORTEZA LOURDES. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 169, S 8, H PO 64722, I/A 12(21.03.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 193, S 8, H PO 64722, I/A 10(18.03.19).
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 166, S 8, H PO 64722, I/A 11(20.03.19).
26 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 192, S 8, H PO 64722, I/A 7(15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 193, S 8, H PO 64722,I/A 8 (15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;PRIETO DEL RIOSANDRA;ORTS SAN JOSE ALFREDO;GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 193, S 8, H PO64722, I/A 9 (18.03.19).
22 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 188, S 8, H PO 64722, I/A 4(13.03.19).
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 192, S 8, H PO 64722, I/A 5(14.03.19).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 192, S 8, H PO 64722, I/A 6(14.03.19).
20 de Marzo de 2019Revocaciones. Apoderado: HERNAIZ DEL CAMPO FELIX. Datos registrales. T 4268, L 4268, F 188, S 8, H PO 64722, I/A 3(12.03.19).
08 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 BAJOS (VIGO). Datos registrales. T 4268, L 4268, F 185, S 8, H PO64722, I/A 1 (31.01.19).
Otros conceptos: MODIFICADO el artículo 3 de los estatutos sociales correspondientes al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales.T 4268, L 4268, F 188, S 8, H PO 64722, I/A 2 (31.01.19).
15 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL. Datos registrales. T 1424 , F 75, S 8, H VA 24981, I/A 7 ( 8.01.19).
24 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Auditor: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1424 , F 75, S 8, H VA 24981, I/A 6 (17.12.15).
16 de Abril de 2015Cambio de domicilio social. C/ ALFONSO X 2 BAJO B (ARROYO DE LA ENCOMIENDA). Datos registrales. T 1424 , F 75, S 8, HVA 24981, I/A 5 ( 9.04.15).
01 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: ROMERO RODRIGUEZ ADELA. Datos registrales. T 1424 , F 74, S 8, H VA 24981, I/A 4 (25.03.14).
22 de Agosto de 2013Nombramientos. Auditor: ASTURECO AUDITORES SL. Datos registrales. T 1424 , F 74, S 8, H VA 24981, I/A 3 (14.08.13).
30 de Julio de 2013Nombramientos. Apoderado: HERNAIZ DEL CAMPO FELIX. Datos registrales. T 1424 , F 73, S 8, H VA 24981, I/A 2 (23.07.13).
17 de Julio de 2012Constitución. Comienzo de operaciones: 15.06.12. Objeto social: La promoción, construcción, explotación y gestión, así como elasesoramiento a terceros y el equipamiento de residencias para personas de la tercera edad y/o con minusvalías o incapacidades,asistidas, no asistidas y mixtas,tanto para estancias permanentes como temporales, así como de residencias. Domicilio: C/MONASTERIO SAN PEDRO DE ALCANTARA 117 (VALLADOLID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersonalidad. Socioúnico: SERVIGER 21 SL. Nombramientos. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO. Datos registrales. T 1424 , F 72, S 8, H VA24981, I/A 1 ( 6.07.12).