Actos BORME de Serviger Xxi Toledo Sl
10 de Octubre de 2023Modificaci贸n de poderes. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 168, S 8, HPO 64727, I/A 48 ( 2.10.23).
29 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 167, S 8, H PO 64727,I/A 47 (21.09.23).
04 de Agosto de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ LORENZO DIEGO;ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA;SARMINI SAINZALBERTO;FERNANDEZ MIGUELEZ PEDRO;VILLAVERDE MARTINEZ ANA ISABEL;VICENTE ARCOS MARIA CARMEN;SOLLATORRES JOSE MANUEL;BRAVO ARAGON PEDRO;RECUENCO COTILLAS PILAR;ALZAMORA CA脩ERO ELENA;SARRATOMARTINEZ FRANCISCO JAVIER;REYES PONCE MONICA;RODRIGUEZ IGLESIAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276,F 167, S 8, H PO 64727, I/A 46 (26.07.23).
28 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MARTIN GARCIA ELENA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 166, S 8, H PO 64727, I/A 45 (20.07.23).
27 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SCHULLER DE SANTOS DAVID CARLOS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 165, S 8, H PO 64727,I/A 43 (18.07.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: VAZQUEZ FERNANDEZ LORENA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 166, S 8, H PO 64727, I/A 44(19.07.23).
24 de Julio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: MONTERO QUINTELA SANDRA;TAUSTE BAUTISTA HUGO;LAGUNA VALENZUELA MARIA CRISTINA.Datos registrales. T 4276, L 4276, F 164, S 8, H PO 64727, I/A 42 (13.07.23).
16 de Junio de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: RUBIO PERIA脩EZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 163, S 8, H PO 64727, I/A 38 (8.06.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: TARDIN SANCHEZ CAROLINA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 163, S 8, H PO 64727, I/A 39 (8.06.23).
21 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 163, S 8, H PO 64727, I/A 37(14.11.22).
07 de Noviembre de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS;CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 163, S 8, HPO 64727, I/A 36 (27.10.22).
03 de Agosto de 2022Revocaciones. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI;SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 163, S 8, HPO 64727, I/A 35 (26.07.22).
28 de Enero de 2022Revocaciones. Apo.Sol.: MOYA GONZALO ALFREDO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 162, S 8, H PO 64727, I/A 34(20.01.22).
18 de Enero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFA ISABEL. Nombramientos. Adm. Unico: INSTITUTO SOCIOSANITARIO SL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 162, S 8, H PO 64727, I/A 33 ( 7.01.22).
04 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 162, S 8, H PO 64727, I/A 32(26.10.21).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRA FAGALDE LORENZO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 160, S 8, H PO 64727, I/A 31(22.10.21).
26 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CALVO DIEGUEZ MONICA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 159, S 8, H PO 64727, I/A 30(15.10.21).
21 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 159, S 8, H PO 64727, I/A 29(13.10.21).
19 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: CUETO FAUS JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 159, S 8, H PO 64727, I/A 28 ( 7.10.21).
17 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 159, S 8, H PO 64727, I/A 27 ( 8.06.21).
07 de Junio de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: EIXERES RAMBLA RAQUEL. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 158, S 8, H PO 64727, I/A 26(27.05.21).
06 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 158, S 8, H PO64727, I/A 25 (26.04.21).
19 de Enero de 2021Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ GUTIERREZ MARIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 158, S 8, H PO 64727, I/A 24 (7.01.21).
26 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MORENO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 158, S 8, H PO64727, I/A 23 (22.06.20).
24 de Junio de 2020Nombramientos. Apoderado: MARIN SORRIBES ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 157, S 8, H PO 64727, I/A 22(18.06.20).
13 de Abril de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: ORTS SAN JOSE ALFREDO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 157, S 8, H PO 64727, I/A 21 (3.04.20).
23 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO DEL RIO SANDRA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 157, S 8, H PO 64727, I/A 20 (15.10.19).
27 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: TABOADA FERNANDEZ MARIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 157, S 8, H PO 64727, I/A 19(16.05.19).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 157, S 8, H PO 64727, I/A 18 ( 7.05.19).
09 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: CRESPO GRANJA PABLO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 156, S 8, H PO 64727, I/A 17 (2.05.19).
07 de Mayo de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MOYA GONZALO ALFREDO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 156, S 8, H PO 64727, I/A 15(29.04.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: MORETON REYES ROBERTO. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 156, S 8, H PO 64727, I/A 16(29.04.19).
04 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: MELON CASTRO MARIA JOSE. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 155, S 8, H PO 64727, I/A 13(28.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ESPIN FORJAN ANA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 155, S 8, H PO 64727, I/A 14 (28.03.19).
03 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: ROJAS RODRIGUEZ VICTORIA. Datos registrales. T 4276, L 4276, F 155, S 8, H PO 64727, I/A 12(28.03.19).
01 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: LOPESINO SOUSA AGUSTIN MODESTO. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 144, S 8, H PO 64727,I/A 11 (22.03.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: HUGUET LLULL ANDREU. Datos registrales. T 4269, L 4269, F 8, S 8, H PO 64727, I/A 9 (18.03.19).
Nombramientos. Apoderado: ROSELLO RIERA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 4275, L 4275, F 141, S 8, H PO 64727, I/A 10(20.03.19).
26 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 4269, L 4269, F 7, S 8, H PO 64727, I/A 6(15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO VAN DER SCHOOT MANUEL. Datos registrales. T 4269, L 4269, F 8, S 8, H PO 64727, I/A 7(15.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: PALENZUELA FERNANDEZ JAVIER;PITEL MENDEZ MARIA EUGENIA;PRIETO DEL RIOSANDRA;ORTS SAN JOSE ALFREDO;GUTIERREZ HERREROS ARANTZAZU. Datos registrales. T 4269, L 4269, F 9, S 8, H PO64727, I/A 8 (18.03.19).
22 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4269, L 4269, F 3, S 8, H PO 64727, I/A 3 (13.03.19).
Nombramientos. Apoderado: SOLER VICENS ANTONI. Datos registrales. T 4269, L 4269, F 6, S 8, H PO 64727, I/A 4 (14.03.19).
Nombramientos. Apoderado: FERRA GUILLEN MARIO-JOSE. Datos registrales. T 4269, L 4269, F 7, S 8, H PO 64727, I/A 5(14.03.19).
08 de Febrero de 2019Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 60 BAJOS (VIGO). Datos registrales. T 4269, L 4269, F 1, S 8, H PO 64727,I/A 1 (31.01.19).
Otros conceptos: MODIFICADO el art铆culo 4 de los estatutos sociales correspondiente al DOMICILIO SOCIAL. Datos registrales. T4269, L 4269, F 3, S 8, H PO 64727, I/A 2 (31.01.19).
14 de Enero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO. Nombramientos. Adm. Unico: FERNANDEZ MIGUELEZ JOSEFAISABEL. Datos registrales. T 1493 , F 47, S 8, H VA 27936, I/A 2 ( 4.01.19).
04 de Febrero de 2016Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 25.01.16. Objeto social: La promoci贸n, construcci贸n, explotaci贸n y gesti贸n, as铆 como elasesoramiento a terceros y el equipamiento de residencias para personas de la tercera edad y/o con minusval铆as o incapacidades,asistidas, no asistidas y mixtas, tanto para estancias permanentes como temporales, etc. Domicilio: C/ ALFONSO X 2 BAJO B(ARROYO DE LA ENCOMIENDA). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: INSTITUTO SOCIOSANITARIO SL. Nombramientos. Adm. Unico: ORTEGA MESA DIEGO. Datos registrales. T 1493 , F 45, S 8, H VA 27936, I/A 1(28.01.16).