Actos BORME de Servishop Manlogist Sa
19 de Septiembre de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: MIRO CUELLO ALBERTO;GOMEZ SANCHEZ PABLO DE JESUS. Datos registrales. T 43946 , F 30,S 8, H M 775323, I/A 7 (12.09.22).
Nombramientos. Apoderado: PEREZ GONZALEZ CRISTINA. Datos registrales. T 43946 , F 30, S 8, H M 775323, I/A 8 (12.09.22).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ MAYOR MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 43946 , F 30, S 8, H M 775323, I/A 9(12.09.22).
15 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: URIARTE ALBAINA MIKEL;PRADERA LANZA GERMAN. Apoderado: BARROETA ZULUAGA JAVIER.Datos registrales. T 43946 , F 28, S 8, H M 775323, I/A 6 ( 8.09.22).
09 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ BENITEZ IGNACIO-JAVIER. Datos registrales. T 43946 , F 26, S 8, H M 775323, I/A 3 (2.09.22).
Nombramientos. Apoderado: PRAT BALASCH JORGE. Datos registrales. T 43946 , F 26, S 8, H M 775323, I/A 4 ( 2.09.22).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN GARCIA DAVID. Datos registrales. T 43946 , F 27, S 8, H M 775323, I/A 5 ( 2.09.22).
19 de Agosto de 2022Cambio de domicilio social. AVDA DEL PARTENON 16-18 2ª (MADRID). Datos registrales. T 43946 , F 26, S 8, H M 775323, I/A 2(11.08.22).
06 de Julio de 2022Declaración de unipersonalidad. Socio único: GLOBAL DOMINION ACCESS SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: CUETOGARCIA RAFAEL MANUEL;AUGUSTO GONZALEZ FERNANDO;VERGARA FALCON JUAN JOSE;MIRO CUELLO ALBERTO.Presidente: AUGUSTO GONZALEZ FERNANDO. SecreNoConsj: VALDECANTOS LORA TAMAYO JAVIER. VsecrNoConsj:MARTINEZ CARPIO JUAN MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: FACILITY MANAGEMENT EXCHANGE SL. Modificacionesestatutarias. Se refunden los estatutos sociales cuya nueva redacción comprende los artículos 1º al 25º.-. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Don Roberto Tobillas Angulo, con D.N.I.44.670.695-A, es el representante persona física del administrador único, que es la sociedad "FACILITY MANAGEMENT EXCHANGE,S.L.".- Se refunden los estatutos para adaptarlos a la exigencia de la Ley de Sociedades de Capital.- Datos registrales. T 6573 , F116, S 8, H SE 36604, I/A 19 (29.06.22).
Otros conceptos: Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberseexpedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a MADRID.- Datos registrales. T 6573 , F 119, S 8, HSE 36604, I/A 19 D (30.06.22).
19 de Julio de 2021Reelecciones. Consejero: AUGUSTO GONZALEZ FERNANDO. Presidente: AUGUSTO GONZALEZ FERNANDO. Consejero:VERGARA FALCON JUAN JOSE;CUETO GARCIA RAFAEL MANUEL;MIRO CUELLO ALBERTO. Datos registrales. T 6573 , F 116,S 8, H SE 36604, I/A 18 ( 6.07.21).
22 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: ESPINO PORTILLO MARIA JOSE. Datos registrales. T 6573 , F 115, S 8, H SE 36604, I/A 17(15.04.21).
26 de Julio de 2019Nombramientos. Consejero: MIRO CUELLO ALBERTO. Datos registrales. T 6573 , F 115, S 8, H SE 36604, I/A 16 (18.07.19).
27 de Julio de 2018Revocaciones. Apoderado: VERGARA FALCON JUAN JOSE;AUGUSTO GONZALEZ FERNANDO;CUETO GARCIA RAFAELMANUEL;ORTEGA ALONSO EMILIO. Apo.Manc.: CUETO GARCIA RAFAEL MANUEL;AUGUSTO GONZALEZFERNANDO;VERGARA FALCON JUAN JOSE;ORTEGA ALONSO EMILIO. Apo.Man.Soli: CUETO GARCIA RAFAELMANUEL;AUGUSTO GONZALEZ FERNANDO;VERGARA FALCON JUAN JOSE. Apoderado: CASTILLO HUMANES PEDRO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIRO CUELLO ALBERTO;ESPINO PORTILLO MARIA JOSE;GOMEZ SANCHEZ PABLO DEJESUS. Datos registrales. T 4982 , F 117, S 8, H SE 36604, I/A 15 (19.07.18).
19 de Junio de 2018Ceses/Dimisiones. Secretario: VERGARA FALCON JUAN JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: VALDECANTOS LORATAMAYO JAVIER. VsecrNoConsj: MARTINEZ CARPIO JUAN MANUEL. Datos registrales. T 4982 , F 117, S 8, H SE 36604, I/A 14 (6.06.18).
19 de Octubre de 2016Reelecciones. Consejero: AUGUSTO GONZALEZ FERNANDO. Presidente: AUGUSTO GONZALEZ FERNANDO. Consejero:VERGARA FALCON JUAN JOSE. Secretario: VERGARA FALCON JUAN JOSE. Consejero: CUETO GARCIA RAFAEL MANUEL.Datos registrales. T 4982 , F 116, S 8, H SE 36604, I/A 13 (11.10.16).
05 de Junio de 2015Nombramientos. Apoderado: CASTILLO HUMANES PEDRO. Datos registrales. T 4982 , F 116, S 8, H SE 36604, I/A 12 (26.05.15).
02 de Agosto de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: CUETO GARCIA RAFAEL MANUEL;AUGUSTO GONZALEZ FERNANDO;VERGARA FALCONJUAN JOSE. Datos registrales. T 4982 , F 114, S 8, H SE 36604, I/A 11 (22.07.13).
29 de Mayo de 2012Nombramientos. Apoderado: ORTEGA ALONSO EMILIO. Apo.Manc.: CUETO GARCIA RAFAEL MANUEL;AUGUSTO GONZALEZFERNANDO;VERGARA FALCON JUAN JOSE;ORTEGA ALONSO EMILIO. Modificaciones estatutarias. Modifica el Artículo 19º delos Estatutos Sociales. Datos registrales. T 4982 , F 113, S 8, H SE 36604, I/A 10 (15.05.12).
22 de Agosto de 2011Reelecciones. Consejero: AUGUSTO GONZALEZ FERNANDO. Presidente: AUGUSTO GONZALEZ FERNANDO. Consejero:VERGARA FALCON JUAN JOSE. Secretario: VERGARA FALCON JUAN JOSE. Consejero: CUETO GARCIA RAFAEL MANUEL.Datos registrales. T 3307 , F 64, S 8, H SE 36604, I/A 9 ( 1.08.11).