Buscador CIF Logo

Actos BORME Setor Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Setor Sa

Actos BORME Setor Sa - A28144160

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Setor Sa con CIF A28144160

馃敊 Perfil de Setor Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Setor Sa

28 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO;SHEEHAN JUNKO IO;COLE BRIAN ROY. Representan:ONIEVA LLORD CRISTINA;ONIEVA HERRERO CARLOS;HERRERO DE LUCAS DANIEL. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datosregistrales. T 36330 , F 144, S 8, H M 124751, I/A 62 (20.12.18).

27 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: AZNAR MORENO MARIA DEL MAR;BARNUSELL CORONADO JORGE;JIMENEZ DIEZMA ROSAMARIA. Datos registrales. T 36330 , F 143, S 8, H M 124751, I/A 61 (20.11.18).

28 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO;LOPEZ FERNANDEZ JULIA;BARNUSELL CORONADOJORGE. Datos registrales. T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 60 (21.06.18).

08 de Enero de 2018
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 59 (29.12.17).

21 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO. Nombramientos. Adm. Solid.: PORTEROSMA脩UECO LIBORIO ALVARO;SHEEHAN JUNKO IO;COLE BRIAN ROY. Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 10bis.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 58 (14.12.17).

20 de Diciembre de 2017
Ampliacion del objeto social. EL EJERCICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA OPERACION Y GESTION ALPOR MAYOR DE PRODUCTOS PETROLIFEROS. Datos registrales. T 36330 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 57 (11.12.17).

27 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: GARCIA NEBREDA VICTOR JOSE;ONIEVA HERRERO ANTONIO;JIMENEZ GONZALO GONZALO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: AZNAR MORENO MARIA DEL MAR;ARAUZO ARRANZ JESUS JULIAN;GALLEGO CARDABAJOSE ROBERTO;LOPEZ FERNANDEZ JULIA. Datos registrales. T 28444 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 56 (14.11.17).

21 de Septiembre de 2017
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ATEN OIL SETOR SL. Datos registrales. T 28444 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 54( 7.09.17).

Ampliacion del objeto social. Articulo 4 .- Constituye el objeto de la sociedad la instalaci贸n y explotaci贸n de estaciones de serviciopara el suministro de gasolina, carburantes y lubrificantes en general, tanto por concesi贸n directa, como por arrendamiento o cualquierotro titulo. La instalaci贸n y explotaci贸n de comercios y t. Datos registrales. T 28444 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 55 ( 7.09.17).

14 de Septiembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: PARTICIPASA SL;ONYHER SL;LHEDAT SL;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Presidente:ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Secretario: ONYHER SL. Cons.Del.Sol: ALBARRAN ISABEL JESUS;ONYHER SL;LHEDAT SL.Nombramientos. Adm. Unico: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO. Modificaciones estatutarias. Creacion del articulo 10bis en los estatutos sociales y modificacion del articulo 10 de los estatutos sociales. . Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 28444 , F 140, S 8, H M 124751, I/A 53 (6.09.17).

30 de Diciembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: ROT FERNANDEZ ANTONIO;ROT FERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 28444 , F 140, S 8, HM 124751, I/A 52 (22.12.16).

19 de Diciembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ GONZALO GONZALO. Datos registrales. T 28444 , F 140, S 8, H M 124751, I/A 51 (2.12.16).

28 de Mayo de 2015
Nombramientos. Cons.Del.Sol: ALBARRAN ISABEL JESUS;ONYHER SL;LHEDAT SL. Reelecciones. Presidente: ALBARRANISABEL ANGEL JESUS. Secretario: ONYHER SL. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 27潞.MODIFICADO. Datos registrales.T 28444 , F 139, S 8, H M 124751, I/A 50 (20.05.15).

14 de Abril de 2015
Nombramientos. Aud.Supl.: STANDARS AUDITORES SLP. Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Datos registrales. T28444 , F 139, S 8, H M 124751, I/A 49 ( 7.04.15).

13 de Abril de 2015
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: ONYHER SL;LHEDAT SL. Con.Delegado: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Cons.Del.Sol:PARTICIPASA SL;ONYHER SL;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS;LHEDAT SL. Reelecciones. Consejero: PARTICIPASASL;ONYHER SL;LHEDAT SL;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Presidente: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Secretario:ONYHER SL. Datos registrales. T 28444 , F 138, S 8, H M 124751, I/A 48 ( 1.04.15).

27 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: ONIEVA HERRERO ANTONIO. Datos registrales. T 28444 , F 137, S 8, H M 124751, I/A 47(17.05.13).

23 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: ONIEVA HERRERO ANTONIO;HERRERO MU脩OZ ANGEL. Secretario: HERRERO MU脩OZANGEL. Cons.Del.Sol: PARTICIPASA SL. Nombramientos. Representan: ONIEVA HERRERO CARLOS;HERRERO DE LUCASDANIEL. Secretario: ONYHER SL. Datos registrales. T 28444 , F 136, S 8, H M 124751, I/A 46 (14.05.13).

25 de Agosto de 2011
Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Aud.Supl.: SPP AUDITORES Y CONSULTORES DE GESTION SL. Datos registrales.T 28444 , F 136, S 8, H M 124751, I/A 45 (16.08.11).

17 de Marzo de 2011
Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Aud.Supl.: SPP AUDITORES Y CONSULTORES DE GESTION SL. Datos registrales.T 28444 , F 136, S 8, H M 124751, I/A 44 ( 7.03.11).

14 de Febrero de 2011
Ceses/Dimisiones. Representan: LLORD MARTINEZ DOLORES. Consejero: GIL MARTIN CARLOS. Presidente: GIL MARTINCARLOS. Nombramientos. Representan: ONIEVA LLORD CRISTINA. Presidente: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS.Cons.Del.Sol: PARTICIPASA SL;ONYHER SL;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS;LHEDAT SL. Datos registrales. T 7717 , F 35, S8, H M 124751, I/A 43 ( 1.02.11).

30 de Julio de 2010
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.104.000,00 Euros. Desembolsado: 1.104.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.520.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.520.000,00 Euros. Datos registrales. T 7717 , F 35, S 8, H M 124751, I/A 42 (20.07.10).

03 de Febrero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.208.000,00 Euros. Desembolsado: 2.208.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.416.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.416.000,00 Euros. Datos registrales. T 7717 , F 35, S 8, H M 124751, I/A 41 (22.01.10).

15 de Septiembre de 2009
Nombramientos. Aud.Supl.: SPP AUDITORES Y CONSULTORES DE GESTION SL. Consejero: ALBARRAN ISABEL ANGELJESUS. Con.Delegado: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 1.490.400,00 Euros. Desembolsado: 1.490.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.208.000,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 2.208.000,00 Euros. Datos registrales. T 7717 , F 34, S 8, H M 124751, I/A 40 ( 3.09.09).

02 de Junio de 2009
Nombramientos. Consejero: LHEDAT SL. Representan: HERRERO MU脩OZ ANGEL. Cons.Del.Sol: LHEDAT SL. Reelecciones.Consejero: GIL MARTIN CARLOS;PARTICIPASA SL;ONYHER SL. Presidente: GIL MARTIN CARLOS. Representan: LLORDMARTINEZ DOLORES;ONIEVA HERRERO ANTONIO. SecreNoConsj: HERRERO MU脩OZ ANGEL. Cons.Del.Sol: PARTICIPASASL;ONYHER SL. Datos registrales. T 7717 , F 32, S 8, H M 124751, I/A 39 (21.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n