Actos BORME de Setor Sa
28 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO;SHEEHAN JUNKO IO;COLE BRIAN ROY. Representan:ONIEVA LLORD CRISTINA;ONIEVA HERRERO CARLOS;HERRERO DE LUCAS DANIEL. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datosregistrales. T 36330 , F 144, S 8, H M 124751, I/A 62 (20.12.18).
27 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: AZNAR MORENO MARIA DEL MAR;BARNUSELL CORONADO JORGE;JIMENEZ DIEZMA ROSAMARIA. Datos registrales. T 36330 , F 143, S 8, H M 124751, I/A 61 (20.11.18).
28 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO;LOPEZ FERNANDEZ JULIA;BARNUSELL CORONADOJORGE. Datos registrales. T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 60 (21.06.18).
08 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 59 (29.12.17).
21 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO. Nombramientos. Adm. Solid.: PORTEROSMA脩UECO LIBORIO ALVARO;SHEEHAN JUNKO IO;COLE BRIAN ROY. Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 10bis.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios. Datos registrales. T36330 , F 142, S 8, H M 124751, I/A 58 (14.12.17).
20 de Diciembre de 2017Ampliacion del objeto social. EL EJERCICIO DE CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON LA OPERACION Y GESTION ALPOR MAYOR DE PRODUCTOS PETROLIFEROS. Datos registrales. T 36330 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 57 (11.12.17).
27 de Noviembre de 2017Revocaciones. Apoderado: GARCIA NEBREDA VICTOR JOSE;ONIEVA HERRERO ANTONIO;JIMENEZ GONZALO GONZALO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: AZNAR MORENO MARIA DEL MAR;ARAUZO ARRANZ JESUS JULIAN;GALLEGO CARDABAJOSE ROBERTO;LOPEZ FERNANDEZ JULIA. Datos registrales. T 28444 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 56 (14.11.17).
21 de Septiembre de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ATEN OIL SETOR SL. Datos registrales. T 28444 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 54( 7.09.17).
Ampliacion del objeto social. Articulo 4 .- Constituye el objeto de la sociedad la instalaci贸n y explotaci贸n de estaciones de serviciopara el suministro de gasolina, carburantes y lubrificantes en general, tanto por concesi贸n directa, como por arrendamiento o cualquierotro titulo. La instalaci贸n y explotaci贸n de comercios y t. Datos registrales. T 28444 , F 141, S 8, H M 124751, I/A 55 ( 7.09.17).
14 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: PARTICIPASA SL;ONYHER SL;LHEDAT SL;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Presidente:ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Secretario: ONYHER SL. Cons.Del.Sol: ALBARRAN ISABEL JESUS;ONYHER SL;LHEDAT SL.Nombramientos. Adm. Unico: PORTEROS MA脩UECO LIBORIO ALVARO. Modificaciones estatutarias. Creacion del articulo 10bis en los estatutos sociales y modificacion del articulo 10 de los estatutos sociales. . Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 28444 , F 140, S 8, H M 124751, I/A 53 (6.09.17).
30 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apoderado: ROT FERNANDEZ ANTONIO;ROT FERNANDEZ ANTONIO. Datos registrales. T 28444 , F 140, S 8, HM 124751, I/A 52 (22.12.16).
19 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ GONZALO GONZALO. Datos registrales. T 28444 , F 140, S 8, H M 124751, I/A 51 (2.12.16).
28 de Mayo de 2015Nombramientos. Cons.Del.Sol: ALBARRAN ISABEL JESUS;ONYHER SL;LHEDAT SL. Reelecciones. Presidente: ALBARRANISABEL ANGEL JESUS. Secretario: ONYHER SL. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 27潞.MODIFICADO. Datos registrales.T 28444 , F 139, S 8, H M 124751, I/A 50 (20.05.15).
14 de Abril de 2015Nombramientos. Aud.Supl.: STANDARS AUDITORES SLP. Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Datos registrales. T28444 , F 139, S 8, H M 124751, I/A 49 ( 7.04.15).
13 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: ONYHER SL;LHEDAT SL. Con.Delegado: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Cons.Del.Sol:PARTICIPASA SL;ONYHER SL;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS;LHEDAT SL. Reelecciones. Consejero: PARTICIPASASL;ONYHER SL;LHEDAT SL;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Presidente: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Secretario:ONYHER SL. Datos registrales. T 28444 , F 138, S 8, H M 124751, I/A 48 ( 1.04.15).
27 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: ONIEVA HERRERO ANTONIO. Datos registrales. T 28444 , F 137, S 8, H M 124751, I/A 47(17.05.13).
23 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Representan: ONIEVA HERRERO ANTONIO;HERRERO MU脩OZ ANGEL. Secretario: HERRERO MU脩OZANGEL. Cons.Del.Sol: PARTICIPASA SL. Nombramientos. Representan: ONIEVA HERRERO CARLOS;HERRERO DE LUCASDANIEL. Secretario: ONYHER SL. Datos registrales. T 28444 , F 136, S 8, H M 124751, I/A 46 (14.05.13).
25 de Agosto de 2011Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Aud.Supl.: SPP AUDITORES Y CONSULTORES DE GESTION SL. Datos registrales.T 28444 , F 136, S 8, H M 124751, I/A 45 (16.08.11).
17 de Marzo de 2011Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Aud.Supl.: SPP AUDITORES Y CONSULTORES DE GESTION SL. Datos registrales.T 28444 , F 136, S 8, H M 124751, I/A 44 ( 7.03.11).
14 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Representan: LLORD MARTINEZ DOLORES. Consejero: GIL MARTIN CARLOS. Presidente: GIL MARTINCARLOS. Nombramientos. Representan: ONIEVA LLORD CRISTINA. Presidente: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS.Cons.Del.Sol: PARTICIPASA SL;ONYHER SL;ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS;LHEDAT SL. Datos registrales. T 7717 , F 35, S8, H M 124751, I/A 43 ( 1.02.11).
30 de Julio de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.104.000,00 Euros. Desembolsado: 1.104.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.520.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 5.520.000,00 Euros. Datos registrales. T 7717 , F 35, S 8, H M 124751, I/A 42 (20.07.10).
03 de Febrero de 2010Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.208.000,00 Euros. Desembolsado: 2.208.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.416.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 4.416.000,00 Euros. Datos registrales. T 7717 , F 35, S 8, H M 124751, I/A 41 (22.01.10).
15 de Septiembre de 2009Nombramientos. Aud.Supl.: SPP AUDITORES Y CONSULTORES DE GESTION SL. Consejero: ALBARRAN ISABEL ANGELJESUS. Con.Delegado: ALBARRAN ISABEL ANGEL JESUS. Reelecciones. Auditor: VI脩AS PEYA JUAN. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 1.490.400,00 Euros. Desembolsado: 1.490.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.208.000,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 2.208.000,00 Euros. Datos registrales. T 7717 , F 34, S 8, H M 124751, I/A 40 ( 3.09.09).
02 de Junio de 2009Nombramientos. Consejero: LHEDAT SL. Representan: HERRERO MU脩OZ ANGEL. Cons.Del.Sol: LHEDAT SL. Reelecciones.Consejero: GIL MARTIN CARLOS;PARTICIPASA SL;ONYHER SL. Presidente: GIL MARTIN CARLOS. Representan: LLORDMARTINEZ DOLORES;ONIEVA HERRERO ANTONIO. SecreNoConsj: HERRERO MU脩OZ ANGEL. Cons.Del.Sol: PARTICIPASASL;ONYHER SL. Datos registrales. T 7717 , F 32, S 8, H M 124751, I/A 39 (21.05.09).