Buscador CIF Logo

Actos BORME Seur Logistica Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Seur Logistica Sa

Actos BORME Seur Logistica Sa - A82301474

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Seur Logistica Sa con CIF A82301474

馃敊 Perfil de Seur Logistica Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Seur Logistica Sa

28 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23588 , F 42, S 8, H M 238649, I/A 58 (20.12.23).

02 de Marzo de 2023
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23588 , F 41, S 8, H M 238649, I/A 57 (23.02.23).

01 de Octubre de 2015
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 32690 , F 64, S 8, H M 847, I/A 75 (23.09.15).

06 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apoderado: SOTO MANCEBO JAIME;CAVERO MESTRE CARLOS;CAVERO MESTRE CARLOS;LEBEAU ERICGUY MAURICE. Apo.Manc.: LEBEAU ERIC GUY MAURICE;SALVADOR OLMO ROBERTO;FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEIGNACIO. Datos registrales. T 32690 , F 63, S 8, H M 847, I/A 74 (25.02.15).

26 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: LIBEAU ERIC GUY MAURICE;MARTINEZ GARCIA ANTONIO;ROLDAN JIMENEZ RAFAEL;CAVEROMESTRE CARLOS;SANZA DE LA RICA CARLOS. Datos registrales. T 32690 , F 61, S 8, H M 847, I/A 72 (17.12.14).

Nombramientos. Apoderado: ZAFRA GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 32690 , F 63, S 8, H M 847, I/A 73 (17.12.14).

15 de Diciembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 32690 , F 60, S 8, H M 847, I/A 70 (4.12.14).

Nombramientos. Apoderado: ENRIQUEZ LAGE SUSANA. Datos registrales. T 32690 , F 60, S 8, H M 847, I/A 71 ( 4.12.14).

30 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RECUENCO BERNAL JULIAN. Nombramientos. Adm. Unico: NAVARRO PEROMINGOALBERTO. Datos registrales. T 30665 , F 127, S 8, H M 847, I/A 68 (21.10.14).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO;REY MANSILLA ANA BELEN. Datos registrales. T 30665 , F 128, S8, H M 847, I/A 69 (21.10.14).

23 de Abril de 2014
Revocaciones. Apoderado: CUETO GILARDI JUAN MANUEL. Nombramientos. Apoderado: DIAZ SEVILLA MARIA. Datosregistrales. T 30665 , F 127, S 8, H M 847, I/A 67 (11.04.14).

19 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Auditor: KMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30665 , F 127, S 8, H M 847, I/A 66 (11.11.13).

14 de Junio de 2013
Nombramientos. Apoderado: ZAFRA GARCIA ANTONIO AURELIO. Datos registrales. T 14755 , F 214, S 8, H M 847, I/A 65 (6.06.13).

04 de Marzo de 2013
Nombramientos. Apoderado: ZAFRA GARCIA ANTONIO AURELIO. Datos registrales. T 14755 , F 214, S 8, H M 847, I/A 64(19.02.13).

08 de Febrero de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Apo.Manc.: IRIBERRI MORENO MIKEL;SALVADOROLMO ROBERTO. Apoderado: IRIBERRI MORENO MIKEL. Datos registrales. T 14755 , F 214, S 8, H M 847, I/A 63 (31.01.13).

05 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: LEBEAU ERIC GUY MAURICE. Apo.Manc.: LEBEAU ERIC GUY MAURICE;SALVADOR OLMOROBERTO;FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 14755 , F 213, S 8, H M 847, I/A 62 (27.11.12).

07 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Secretario: SANZA DE LA RICA CARLOS. Consejero: VALLE LOPERA MANUEL;NAVARRO PEROMINGOALBERTO;RECUENCO BERNAL JULIAN;DELMAS YVESPresidente: VALLE LOPERA MANUEL. Con.Delegado: RECUENCOBERNAL JULIAN. Revocaciones. Apoderado: VALLE LOPERA MANUEL. Nombramientos. Apoderado: DELMAS YVES PIERRELOUIS. Adm. Unico: RECUENCO BERNAL JULIAN. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Modificaciones estatutarias.Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.se modifican los art铆culos 11, 21 y22 de losEstatutos sociales.. Datos registrales. T 14755 , F 211, S 8, H M 847, I/A 61 (23.10.12).

01 de Junio de 2012
Nombramientos. Apoderado: CAVERO MESTRE CARLOS. Datos registrales. T 14755 , F 211, S 8, H M 847, I/A 60 (22.05.12).

23 de Marzo de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: IRIBERRI MORENO MIKEL. Apo.Manc.: MERLO DE LA CRUZ JOSE;SALVADOR OLMO ROBERTO.Datos registrales. T 14755 , F 211, S 8, H M 847, I/A 59 ( 9.03.12).

02 de Febrero de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Apo.Manc.: IRIBERRI MORENO MIKEL;SALVADOROLMO ROBERTO. Apo.Sol.: SANZA DE LA RICA CARLOS. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T14755 , F 210, S 8, H M 847, I/A 58 (23.01.12).

23 de Diciembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: PUENTE CAGIGAS ALBERTO. Revocaciones. Apo.Manc.: MERLO DE LA CRUZJOSE;SALVADOR OLMO ROBERTO. Apoderado: SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO. Apo.Manc.: SANCHEZ GONZALEZFERNANDO. Datos registrales. T 14755 , F 210, S 8, H M 847, I/A 57 (13.12.11).

19 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: IRIBERRI MORENO MIKEL. Apo.Manc.: MERLO DE LA CRUZ JOSE;SALVADOR OLMOROBERTO. Datos registrales. T 14755 , F 209, S 8, H M 847, I/A 56 (31.08.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n