Actos BORME de Seur Sa
05 de Diciembre de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 39880 , F 168, S 8, H M 45637, I/A 132 (28.11.23).
02 de Noviembre de 2023Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: GEOPOST ESPA脩A SL. Datos registrales. T 39880 , F 168, S 8, H M 45637, I/A131 (25.10.23).
20 de Julio de 2023Otros conceptos: CON FECHA 10 DE JULIO DE 2023 HA QUEDADO INSERTO EN LA PAGINA WEB CORPORATIVA"www.seur.com" EL PROYECTO DE FUSION POR ABSORCION DE 27 DE JUNIO DE 2023 DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA "SEURS.A." POR LA SOCIEDAD ABSORBENTE "GEOPOST ESPA脩A S.L.", EXTENDIENDOSE LA NOTA A QUE SE REFIERE EL
17 de Mayo de 2023Nombramientos. Con.Delegado: NAVARRO PEROMINGO ALBERTO. Datos registrales. T 39880 , F 168, S 8, H M 45637, I/A 130( 9.05.23).
22 de Febrero de 2023Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39880 , F 167, S 8, H M 45637, I/A 129 (15.02.23).
10 de Marzo de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39880 , F 167, S 8, H M 45637, I/A 128 ( 3.03.22).
22 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 39880 , F 167, S 8, H M 45637, I/A 127 (12.03.21).
18 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: DELMAS YVES;NAVARRO PEROMINGO ALBERTO;PUENTE CAGIGAS ALBERTO. Consejero:DELMAS YVES PIERRE LOUIS;MAYO GONZALEZ RAMON;NAVARRO PEROMINGO ALBERTO;ESTABLET OLIVIER RENEJACQUES;LEBEAU ERIC GUY MAURICE;TARRAGONA FORADADA CARLOS. Presidente: DELMAS YVES PIERRE LOUIS.Con.Delegado: NAVARRO PEROMINGO ALBERTO. Consejero: TRANSALINETAS LOGISTIC SL. Representan: VALLE LOPERAMANUEL. SecreNoConsj: LUJAN ESPI ALBERTO. Nombramientos. Consejero: DELMAS YVES PIERRE LOUIS;MAYO GONZALEZRAMON;NAVARRO PEROMINGO ALBERTO;ESTABLET OLIVIER RENE JACQUES;VALLE LOPERA MANUEL. Presidente:DELMAS YVES PIERRE LOUIS. SecreNoConsj: LUJAN ESPI ALBERTO. Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n del art铆culo 17de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 39880 , F 166, S 8, H M 45637, I/A 126 (11.03.21).
19 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: UBEDA RODRIGUEZ PEDRO. Apo.Manc.: LARRA脩AGA LARRA脩AGA ITSASO;LUJAN ESPIALBERTO;ROLDAN JIMENEZ RAFAEL;SASTRE SEGOVIA DAVID. Datos registrales. T 23911 , F 179, S 8, H M 45637, I/A 124 (9.10.20).
Revocaciones. Apoderado: DIAZ SEVILLA ANA MARIA;LEBEAU ERIC GUY MAURICE. Datos registrales. T 39880 , F 166, S 8, HM 45637, I/A 125 ( 9.10.20).
23 de Marzo de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23911 , F 179, S 8, H M 45637, I/A 123 (16.03.20).
10 de Junio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: VELAYOS GUTIERREZ JAVIER. Nombramientos. Representan: VALLE LOPERA MANUEL.Consejero: TRANSALINETAS LOGISTIC SL. Datos registrales. T 23911 , F 179, S 8, H M 45637, I/A 122 ( 3.06.19).
10 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: ATASSI MORALES FIRAS THOMAS. Datos registrales. T 23911 , F 178, S 8, H M 45637, I/A 121(30.04.19).
11 de Marzo de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23911 , F 178, S 8, H M 45637, I/A 120 ( 4.03.19).
31 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: DELMAS IVES PIERRE LOUIS. Datos registrales. T 23911 , F 176, S 8, H M 45637, I/A 119(24.07.18).
07 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23911 , F 176, S 8, H M 45637, I/A 118 (28.11.17).
21 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 23911 , F 176, S 8, H M 45637, I/A117 (13.11.17).
29 de Mayo de 2017Revocaciones. Apoderado: VIECO ALONSO EVA. Datos registrales. T 23911 , F 175, S 8, H M 45637, I/A 116 (19.05.17).
09 de Febrero de 2017Revocaciones. Apoderado: GALLEGO SAMPER PEDRO. Datos registrales. T 23911 , F 175, S 8, H M 45637, I/A 115 ( 1.02.17).
07 de Febrero de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 23911 , F 175, S 8, H M 45637, I/A 114 (30.01.17).
20 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: SANZA DE LA RICA CARLOS. Apoderado: SANZA DE LA RICA CARLOS. Apo.Sol.: SANZA DE LA RICACARLOS. Apoderado: SANZA DE LA RICA CARLOS. Datos registrales. T 23911 , F 173, S 8, H M 45637, I/A 111 ( 7.12.16).
Nombramientos. Apoderado: LARRA脩AGA LARRA脩AGA ITXASO;LUJAN ESPI ALBERTO. Datos registrales. T 23911 , F 173, S8, H M 45637, I/A 112 ( 7.12.16).
Nombramientos. Apoderado: BURUCHAGA OROSA ISAAC. Datos registrales. T 23911 , F 175, S 8, H M 45637, I/A 113 ( 7.12.16).
19 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DELMAS YVES;MAYO GONZALEZ RAMON;NAVARRO PEROMINGO ALBERTO;PUENTECAGIGAS ALBERTO;VELAYOS GUTIERREZ JAVIER;KINSEY TERESA DEBELIUS;LOZANO GUADALAJARA PEDRO.Con.Delegado: NAVARRO PEROMINGO ALBERTO. Presidente: DELMAS YVES. Consejero: LEBEAU ERIC GUYMAURICE;ESTABLET OLIVIER RENE JACQUES. Secretario: SANZA DE LA RICA CARLOS. Nombramientos. Consejero: DELMASYVES PIERRE LOUIS;MAYO GONZALEZ RAMON;NAVARRO PEROMINGO ALBERTO;VELAYOS GUTIERREZ JAVIER;ESTABLETOLIVIER RENE JACQUES;LEBEAU ERIC GUY MAURICE;TARRAGONA FORADADA CARLOS. Presidente: DELMAS YVES PIERRELOUIS. Con.Delegado: NAVARRO PEROMINGO ALBERTO. SecreNoConsj: LUJAN ESPI ALBERTO. Modificaciones estatutarias.
04 de Julio de 2016Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO;MARTINEZ GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T 23911 , F 172, S8, H M 45637, I/A 109 (27.06.16).
10 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Representan: ESTABLET OLIVIER-RENE-JACQUES. Consejero: SEUR GEOPOST SL. Nombramientos.Consejero: ESTABLET OLIVIER RENE JACQUES. Otros conceptos: Ratificado el nombramiento por coptaci贸n del Consejero de laSociedad SEUR GEOPOST, S.L. Datos registrales. T 23911 , F 172, S 8, H M 45637, I/A 108 ( 3.02.16).
30 de Octubre de 2015Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 8,9,10,11,13,14,15, 16, 19,21 Y 22 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES.-. REFUNDIDO LOS ESTATUTOS SOCIALES.-. Datos registrales. T 23911 , F 166, S 8, H M 45637, I/A 107 (21.10.15).
06 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RECUENCO BERNAL JULIAN. Vicepr.1: RECUENCO BERNAL JULIAN. Miem.Com.Ej.: RECUENCOBERNAL JULIAN. Revocaciones. Apoderado: SOTO MANCEBO JAIME;PE脩AS BLAZQUEZ HILARIO;LEBEAU ERIC GUYMAURICE. Apo.Manc.: LEBEAU ERIC GUY MAURICE;SALVADOR OLMO ROBERTO;FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO.Nombramientos. Consejero: SEUR GEOPOST SL. Representan: ESTABLET OLIVIER-RENE-JACQUES. Datos registrales. T23911 , F 165, S 8, H M 45637, I/A 106 (24.02.15).
12 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: LEBEAU ERIC GUY MAURICE;MARTINEZ GARCIA ANTONIO;ROLDAN JIMENEZ RAFAEL;SASTRESEGOVIA DAVID;GALLEGO SAMPER PEDRO;SANZA DE LA RICA CARLOS;ORTEGA ADELAIDA ADELA. Datos registrales. T23911 , F 163, S 8, H M 45637, I/A 103 ( 2.12.14).
Nombramientos. Apoderado: VIECO ALONSO EVA. Datos registrales. T 23911 , F 164, S 8, H M 45637, I/A 104 ( 2.12.14).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 23911 , F 165, S 8, H M 45637, I/A105 ( 2.12.14).
28 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ANTONIO;REY MANSILLA ANA BELEN. Datos registrales. T 23911 , F 161, S
29 de Mayo de 2014Revocaciones. Apoderado: CUETO GILARDI JUAN. Nombramientos. Apoderado: DIAZ SEVILLA ANA MARIA. Datos registrales.T 23911 , F 161, S 8, H M 45637, I/A 101 (21.05.14).
19 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: SEUR GEOPOST SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Consejero: LEBEAU ERICGUY MAURICE. Otros conceptos: Ratificado el nombramiento como consejero a la sociedad Seur Geopost SL. Datos registrales.T 23911 , F 160, S 8, H M 45637, I/A 100 (10.12.13).
24 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: SORIANO MARTINEZ JAIME. Miem.Com.Ej.: SORIANO MARTINEZ JAIME. Nombramientos.Consejero: SEUR GEOPOST SL. Representan: LEBEAU ERIC GUY MAURICE. Datos registrales. T 23911 , F 160, S 8, H M 45637,I/A 99 (16.04.13).
12 de Febrero de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO;IRIBERRI MORENO MIKEL;SALVADOR OLMO ROBERTO.Apoderado: IRIBERRI MORENO MIKEL. Datos registrales. T 23911 , F 159, S 8, H M 45637, I/A 98 ( 4.02.13).
07 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apoderado: LEBEAU ERIC GUY MAURICE. Apo.Manc.: LEBEAU ERIC GUY MAURICE;SALVADOR OLMOROBERTO;FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 23911 , F 158, S 8, H M 45637, I/A 97 (27.11.12).
04 de Diciembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: CORTES GARCIA PEDRO;PUENTE CAGIGAS ALBERTO;VALLE LOPERA MANUEL;RECUENCOBERNAL JULIAN;DELMAS YVES;RODRIGUEZ SOUSA FERNANDO. Presidente: VALLE LOPERA MANUEL. Consejero:WINKELMANN BORIS;VELAYOS GUTIERREZ JAVIER;MAYO GONZALEZ RAMON;LOZANO GUADALAJARA PEDRO;KINSEYTERESA DEBELIUS. Revocaciones. Apoderado: VALLE LOPERA MANUEL. Nombramientos. Consejero: DELMASYVES;RECUENCO BERNAL JULIAN;MAYO GONZALEZ RAMON;SORIANO MARTINEZ JAIME;NAVARRO PEROMINGOALBERTO;PUENTE CAGIGAS ALBERTO;VELAYOS GUTIERREZ JAVIER;KINSEY TERESA DEBELIUS;LOZANO GUADALAJARAPEDRO. Con.Delegado: NAVARRO PEROMINGO ALBERTO. Vicepr.1: RECUENCO BERNAL JULIAN. Presidente: DELMAS YVES.Apoderado: DELMAS YVES PIERRE LOUIS. Miem.Com.Ej.: DELMAS YVES;NAVARRO PEROMINGO ALBERTO;PUENTE CAGIGASALBERTO;RECUENCO BERNAL JULIAN;SORIANO MARTINEZ JAIME. Vsecr1.NC: LUJAN ESPI ALBERTO. Reelecciones.Auditor: BDO AUDITORES SL. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL. Secretario: SANZA DE LA RICA CARLOS. Modificacionesestatutarias. modificaci贸n del art铆culo 17潞 de los estatutos.. Datos registrales. T 23911 , F 156, S 8, H M 45637, I/A 96 (23.11.12).
23 de Marzo de 2012Revocaciones. Apo.Manc.: IRIBERRI MORENO MIKEL;MERLO DE LA CRUZ JOSE;SALVADOR OLMO ROBERTO. Datosregistrales. T 23911 , F 156, S 8, H M 45637, I/A 95 ( 9.03.12).
29 de Febrero de 2012Reelecciones. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 23911 , F 156, S 8, H M 45637, I/A 94 (17.02.12).
01 de Febrero de 2012Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Modificaciones estatutarias. 11. Funcionamiento Junta Gral.-. Datos registrales.T 23911 , F 155, S 8, H M 45637, I/A 92 (20.01.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO. Apo.Manc.: IRIBERRI MORENO MIKEL;SALVADOROLMO ROBERTO. Apo.Sol.: SANZA DE LA RICA CARLOS. Datos registrales. T 23911 , F 155, S 8, H M 45637, I/A 93 (20.01.12).
23 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO;MERLO DE LA CRUZ JOSE;SALVADOR OLMO ROBERTO.Apoderado: SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO. Apo.Man.Soli: SANCHEZ GONZALEZ FERNANDO;ZAPATA MORENO CESARMARTIN. Datos registrales. T 23911 , F 154, S 8, H M 45637, I/A 91 (13.12.11).
01 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apo.Manc.: IRIBERRI MORENO MIKEL;MERLO DE LA CRUZ JOSE;SALVADOR OLMO ROBERTO. Datosregistrales. T 23911 , F 154, S 8, H M 45637, I/A 90 (22.08.11).
15 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apoderado: CUETO GILARDI JUAN MANUEL;MARCOS BELTRAN DE SALAZAR MARIANO JESUS.Nombramientos. Apoderado: PE脩AS BLAZQUEZ HILARIO. Datos registrales. T 23911 , F 154, S 8, H M 45637, I/A 89 ( 1.12.10).
26 de Octubre de 2010Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SEUR INSTALACIONES SA. Datos registrales. T 23911 , F 151, S 8, H M 45637,I/A 88 (15.10.10).
27 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ VAZQUEZ CAMILO. Datos registrales. T 23911 , F 151, S 8, H M 45637, I/A 87 (18.05.10).
02 de Marzo de 2010Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ SOUSA FERNANDO. Datos registrales. T 23911 , F 151, S 8, H M 45637, I/A 86(18.02.10).
29 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apoderado: NAVARRO PEROMINGO ALBERTO. Datos registrales. T 23911 , F 150, S 8, H M 45637, I/A 85(16.12.09).
06 de Noviembre de 2009Otros conceptos: POR ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 17 DE MARZO DE 2009, SE PROCEDIO ALA EMISION DE 91 TITULOS MULTIPLES NOMINATIVOS QUE DOCUMENTAN LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DELCAPITAL SOCIAL, NUMEROS 1 AL 3.932.851 INCLUSIVE. Datos registrales. T 14222 , F 188, S 8, H M 45637, I/A 48-M (23.10.09).
11 de Septiembre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: SALVADOR MILLAN RICARDO;CUENCA PACK SA. Representan: KINSEY TERESA DEBELIUS.Consejero: LOALMA RIAS BAJAS SL. Representan: LOZANO GUADALAJARA PEDRO. Nombramientos. Consejero: LOALMARIAS BAJAS SL. Representan: KINSEY TERESA DEBELIUS. Consejero: LOZANO GUADALAJARA PEDRO;KINSEY TERESADEBELIUS. Reelecciones. SecreNoConsj: SANZA DE LA RICA CARLOS. Datos registrales. T 23911 , F 149, S 8, H M 45637, I/A84 ( 2.09.09).
05 de Agosto de 2009Nombramientos. Apoderado: CUETO GILARDI JUAN. Datos registrales. T 23911 , F 148, S 8, H M 45637, I/A 83 (23.07.09).
29 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: RECUENCO MAROTO DESIREE. Nombramientos. Consejero: CUENCA PACK SA. Representan:
20 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: RODRIGUEZ SOUSA FERNANDO. Nombramientos. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORESSL. Reelecciones. Consejero: CORTES GARCIA PEDRO;RECUENCO MAROTO DESIREE;LOPEZ VAZQUEZCAMILO;SALVADOR MILLAN RICARDO;PUENTE CAGIGAS ALBERTO;VALLE LOPERA MANUEL;RECUENCO BERNALJULIAN;DELMAS YVES;RODRIGUEZ SOUSA FERNANDO. Presidente: VALLE LOPERA MANUEL. Consejero: WINKELMANNBORIS;VELAYOS GUTIERREZ JAVIER;MAYO GONZALEZ RAMON. Datos registrales. T 23911 , F 147, S 8, H M 45637, I/A 81(10.02.09).