Buscador CIF Logo

Actos BORME Sg Equipment Finance Iberia Efc Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sg Equipment Finance Iberia Efc Sa

Actos BORME Sg Equipment Finance Iberia Efc Sa - A86106838

Tenemos registrados 41 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Sg Equipment Finance Iberia Efc Sa con CIF A86106838

馃敊 Perfil de Sg Equipment Finance Iberia Efc Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Sg Equipment Finance Iberia Efc Sa

11 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ MINGO ALVARO;LOPEZ MINGO ALVARO;LOPEZ MINGO ALVARO;LOPEZ MINGOALVARO;RODRIGUEZ VENTURA ELENA;CANTALEJO MARTIN DE SAN PABLO ALVARO;LOPEZ MINGO ALVARO. Datosregistrales. T 44299 , F 204, S 8, H M 512951, I/A 43 (30.11.23).

13 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: FRENEAU OLIVIER;ARISPE NU脩EZ JUAN JOSE;SATORRES RUIPEREZ CRISTINA;DELIBES DE LAGUARDIA VICTORIA CONCEPCION. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARISPE NU脩EZ JUAN JOSE;AVILA GONZALEZLAURA;GALLEGO MARTIN LAURA;RUBIO VI脩ARAS SERGIO. Apo.Sol.: CARBALLO PADILLA BRENDA;PEREIRA CALVETZULAIKA. Datos registrales. T 30040 , F 225, S 8, H M 512951, I/A 42 ( 6.02.23).

07 de Septiembre de 2022
Reelecciones. Consejero: FRENEAU OLIVIER;SPUROVA JARMILA. Con.Delegado: SPUROVA JARMILA. Consejero: DE SAIVREODILE. Presidente: DE SAIVRE ODILE. Datos registrales. T 30040 , F 224, S 8, H M 512951, I/A 41 (31.08.22).

24 de Agosto de 2021
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30040 , F 223, S 8, H M 512951, I/A 40 (17.08.21).

19 de Julio de 2021
Nombramientos. Consejero: ABOIN GONZALEZ MARIA. Datos registrales. T 30040 , F 223, S 8, H M 512951, I/A 39 (12.07.21).

27 de Enero de 2021
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.578.389,82 Euros. Desembolsado: 1.578.389,82 Euros. Resultante Suscrito: 10.748.447,70 Euros.Resultante Desembolsado: 10.748.447,70 Euros. Datos registrales. T 30040 , F 222, S 8, H M 512951, I/A 38 (20.01.21).

19 de Agosto de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30040 , F 222, S 8, H M 512951, I/A 37 (12.08.20).

25 de Mayo de 2020
Cambio de domicilio social. C/ SERRANO GALVACHE NUMERO 56, PARQUE NORTE, EDIFI (MADRID). Datos registrales. T30040 , F 222, S 8, H M 512951, I/A 36 (18.05.20).

03 de Febrero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: LARRAYA MENDIA RAMON GREGORIO. Datos registrales. T 30040 , F 222, S 8, H M 512951, I/A35 (27.01.20).

28 de Agosto de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30040 , F 221, S 8, H M 512951, I/A 33 (21.08.19).

Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 17潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 30040 , F221, S 8, H M 512951, I/A 34 (21.08.19).

14 de Junio de 2019
Nombramientos. Apoderado: ARANDA GARCIA MARIA ESTELA;MATOS MONFORT MARIO;JODRA CASTILLO JUANJOSE;MERINO ESGUEVA AURELIO;RIOLA HERNAN-GOMEZ BLANCA;JERONIMO ALONSO ANA;BARAJAS DEL ROSALIGNACIO;PALENCIA JORGE MARIA CRISTINA;FERNANDEZ DIAZ PALOMA;OLIVA TEJERA OSCAR;MARTINEZ FERNANDEZJUAN IGNACIO;GARCIA DEL CURA FRANCISCO DE BORJA;MURO DUARTE IGNACIO MARIA;ARISPE NU脩EZ JUANJOSE;GALAN EIZAGUIRRE VIRGINIA;ZOUGAM ACHAB SAMIRA;TORRES GARCIA ROBERTO;LAMANA ALFARO MARIACARMEN;SATORRES RUIPEREZ CRISTINA;MOSQUERA TELLO ESTEFANIA;DELIBES DE LA GUARDIA VICTORIACONCEPCION;TABOADA ZAZO TRINIDAD;PIGINI AGUSTINA. Datos registrales. T 30040 , F 53, S 8, H M 512951, I/A 32 (7.06.19).

07 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE CARRERE MARIA CRISTINA;GARICANO LANDA MIGUEL. Datosregistrales. T 30040 , F 53, S 8, H M 512951, I/A 31 (31.01.19).

27 de Noviembre de 2018
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SGEF SA. Datos registrales. T 30040 , F 53, S 8, H M 512951, I/A 30 (20.11.18).

24 de Agosto de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ SANCHEZ DONATO;DUCHOLET REBELLEDO BRAVO MARIE-CHRISTINE MARTINEJ. Presidente: DUCHOLET REBELLEDO BRAVO MARIE-CHRISTINE MARTINE J. Nombramientos. Consejero: LARRAYA MENDIARAMON GREGORIO;DE SAIVRE ODILE. Presidente: DE SAIVRE ODILE. Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL.Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 17潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 30040 , F52, S 8, H M 512951, I/A 29 (16.08.18).

24 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: ARANDA GARCIA MARIA ESTELA;PALENCIA JORGE MARIA CRISTINA. Datos registrales. T30040 , F 51, S 8, H M 512951, I/A 28 (16.05.18).

28 de Marzo de 2018
Nombramientos. Consejero: SPUROVA JARMILA. Con.Delegado: SPUROVA JARMILA. Datos registrales. T 30040 , F 50, S 8, HM 512951, I/A 28 (20.03.18).

26 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: LAFARGUE FERNANDO CARLOS NARCISO. D. Gerente: MARTINEZ-CARANDE RODRIGUEZJOSE LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: PALENCIA JORGE MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 30040 , F 50, S 8, H M512951, I/A 27 (15.02.18).

10 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: SPUROVA JARMILA. Datos registrales. T 30040 , F 48, S 8, H M 512951, I/A 26 ( 2.11.17).

08 de Septiembre de 2017
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30040 , F 48, S 8, H M 512951, I/A 25 ( 1.09.17).

07 de Julio de 2017
Nombramientos. Consejero: FRENEAU OLIVIER. Datos registrales. T 30040 , F 47, S 8, H M 512951, I/A 24 (29.06.17).

26 de Mayo de 2017
Reelecciones. Consejero: DUCHOLET REBELLEDO BRAVO MARIE-CHRISTINE MARTINE J. Presidente: DUCHOLETREBELLEDO BRAVO MARIE-CHRISTINE MARTINE J. Datos registrales. T 30040 , F 47, S 8, H M 512951, I/A 23 (18.05.17).

17 de Abril de 2017
Nombramientos. D. Gerente: MARTINEZ-CARANDE RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 30040 , F 46, S 8, H M

06 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: GARRALDA CABANAS CRISTINA. Consejero: MARTINEZ-CARANDE RODRIGUEZ JOSE LUIS.Con.Delegado: MARTINEZ-CARANDE RODRIGUEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Apoderado: FRENEAU OLIVIER. Datosregistrales. T 30040 , F 44, S 8, H M 512951, I/A 21 (29.03.17).

09 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30040 , F 44, S 8, H M 512951, I/A 20 ( 1.08.16).

02 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: MIGNEREY JEAN MARC CHRISTIAN. Datos registrales. T 30040 , F 43, S 8, H M 512951, I/A 19(23.02.16).

27 de Enero de 2016
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: NAVARRO CODERQUE JOSE FERNANDO. Nombramientos. SecreNoConsj: LAFARGUEFERNANDO CARLOS NARCISO. Reelecciones. Consejero: MARTINEZ-CARANDE RODRIGUEZ JOSE LUIS;GONZALEZSANCHEZ DONATO. Con.Delegado: MARTINEZ-CARANDE RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 30040 , F 43, S 8, H M512951, I/A 18 (18.01.16).

31 de Agosto de 2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30040 , F 43, S 8, H M 512951, I/A 17 (24.08.15).

11 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRACHON ERIC JEAN PIERRE MARIE. Datos registrales. T 30040 , F 43, S 8, H M 512951, I/A 16( 1.06.15).

24 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA GARATE JOSE MIGUEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARICANO LANDA MIGUEL.Datos registrales. T 30040 , F 42, S 8, H M 512951, I/A 15 (15.04.15).

08 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: NORIEGA GARCIA MIGUEL. Nombramientos. VsecrNoConsj: GARRALDA CABANASCRISTINA. Datos registrales. T 30040 , F 41, S 8, H M 512951, I/A 14 (29.08.14).

04 de Septiembre de 2014
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 30040 , F 41, S 8, H M 512951, I/A 13 (28.08.14).

12 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: URIA FERNANDEZ FRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: NAVARRO CODERQUE JOSEFERNANDO. VsecrNoConsj: NORIEGA GARCIA MIGUEL. Datos registrales. T 30040 , F 41, S 8, H M 512951, I/A 12 ( 4.11.13).

27 de Mayo de 2013
Modificaciones estatutarias. 17. Administraci贸n y Representacion.-. Datos registrales. T 30040 , F 40, S 8, H M 512951, I/A 11(17.05.13).

22 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE BOUSQUET CHRISTIAN DE PASTRE. Nombramientos. Consejero: MIGNEREY JEAN MARCCHRISTIAN;FRACHON ERIC JEAN PIERRE MARIE. Datos registrales. T 30040 , F 40, S 8, H M 512951, I/A 10 (13.03.13).

03 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MIGNEREY JEAN MARC. Presidente: MIGNEREY JEAN MARC. Nombramientos. Consejero:DUCHOLET REBELLEDO BRAVO MARIE-CHRISTINE MARTINE J. Presidente: DUCHOLET REBELLEDO BRAVO MARIE-CHRISTINE MARTINE J. Datos registrales. T 28492 , F 111, S 8, H M 512951, I/A 9 (21.06.12).

20 de Febrero de 2012
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 28492 , F 111, S 8, H M 512951, I/A 8 ( 8.02.12).

16 de Enero de 2012
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 28492 , F 110, S 8, H M 512951, I/A 6 ( 3.01.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: RIOLA HERNAN-GOMEZ BLANCA;BARAJAS DEL ROSAL IGNACIO;GARCIA GARATE JOSEMIGUEL;RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE CARRERE MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 28492 , F 110, S 8, H M 512951, I/A 7 (3.01.12).

27 de Diciembre de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 52.659,40 Euros. Resultante Suscrito: 8.340,60 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:1.384.000,00 Euros. Desembolsado: 1.384.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.392.340,60 Euros. Resultante Desembolsado:1.392.340,60 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 82,80 Euros. Desembolsado: 82,80 Euros. Resultante Suscrito: 1.392.423,40Euros. Resultante Desembolsado: 1.392.423,40 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.048.030,60 Euros. Desembolsado:5.048.030,60 Euros. Resultante Suscrito: 6.440.454,00 Euros. Resultante Desembolsado: 6.440.454,00 Euros. Otros conceptos:SOCIEDAD BENEFICIARIA DE LA SEGREGACION DE LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD FRANCESA DENOMINADA "FRANFINANCE SA" , ASI COMO SU TRANSFORMACION EN ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITOY MODIFICACIONDE SUS ESTATUTOS SOCIALES.- Datos registrales. T 28492 , F 106, S 8, H M 512951, I/A 4 (15.12.11).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 2.729.603,88 Euros. Desembolsado: 2.729.603,88 Euros. Resultante Suscrito: 9.170.057,88 Euros.Resultante Desembolsado: 9.170.057,88 Euros. Datos registrales. T 28492 , F 109, S 8, H M 512951, I/A 5 (16.12.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n