Actos BORME de Sg Holding De Valores Y Participaciones Sl
28 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: FRENEAU OLIVIER;COMA BRUN JUAN PABLO;ROZAS CANO I脩IGO. Datos registrales. T 18314 ,F 191, S 8, H M 317565, I/A 13 (21.01.19).
09 de Enero de 2019Nombramientos. Apoderado: INTERTRUST (SPAIN) SL;ROZPIDE ORBEGOZO CARMEN;FREIRE VILLANOVA ANA;DIEZ ARRANZBEATRIZ;GONZALEZ YA脩EZ DANIEL;GIL MESINO MIGUEL;MORATO ESCRIVA DE BALAGUER MIGUEL MARIA;MARTINEZ-AVIAL BERGAMIN JAVIER;LOPEZ-TEIJON LOPEZ JULIO;CASTA脩ON MARTINEZ ESPERANZA;UTRILLA FERNANDEZ- BERMEJOCRISTINA. Datos registrales. T 18314 , F 190, S 8, H M 317565, I/A 12 (31.12.18).
31 de Diciembre de 2018Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GONZALEZ SANCHEZ DONATO;FRENEAU OLIVIER. Nombramientos. SecreNoConsj:INTERTRUST (SPAIN) SL. VsecrNoConsj: FREIRE VILLANOVA ANA. Representan: DIEZ ARRANZ BEATRIZ. Consejero: FRENEAUOLIVIER;COMA BRUN JUAN PABLO;ROZAS CANO I脩IGO. Presidente: COMA BRUN JUAN PABLO. Otros conceptos: Cambio delOrgano de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 41 4(MADRID). Datos registrales. T 18314 , F 190, S 8, H M 317565, I/A 11 (21.12.18).
08 de Febrero de 2017Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.997.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000,00 Euros. Datos registrales. T 18314 , F189, S 8, H M 317565, I/A 10 ( 1.02.17).
04 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: CALMAESTRA LEYVA JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: SANJOSE MERINO MARIA DE LASMERCEDES. Datos registrales. T 18314 , F 188, S 8, H M 317565, I/A 9 (23.11.12).
10 de Octubre de 2011Revocaciones. Apoderado: BUTTAY SERGE. Datos registrales. T 18314 , F 188, S 8, H M 317565, I/A 8 (28.09.11).
03 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PLA GILBERT. Revocaciones. Apoderado: FRENEAU OLIVIER. Nombramientos. Adm. Solid.:FRENEAU OLIVIER. Datos registrales. T 18314 , F 188, S 8, H M 317565, I/A 7 (25.01.10).