Buscador CIF Logo

Actos BORME Sharp & Dohme Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sharp & Dohme Sa

Actos BORME Sharp & Dohme Sa - A82144973

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Sharp & Dohme Sa con CIF A82144973

馃敊 Perfil de Sharp & Dohme Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Sharp & Dohme Sa

17 de Febrero de 2011
Otros conceptos: LA PRESENTE SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD "MERCK SHARP & DOHME DE ESPA脩A SA" .- Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 26045 , F 157, S 8, H M219589, I/A 71 ( 7.02.11).

28 de Septiembre de 2010
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26045 , F 157, S 8, H M 219589,I/A 70 (16.09.10).

01 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apoderado: SERRANO SACRISTAN PABLO. Datos registrales. T 26045 , F 156, S 8, H M 219589, I/A 69(17.02.10).

08 de Enero de 2010
Revocaciones. Apoderado: HILL DONALD M. Datos registrales. T 26045 , F 156, S 8, H M 219589, I/A 68 (28.12.09).

14 de Diciembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: SERRANO SACRISTAN PABLO. Nombramientos. Consejero: CHARDONNENS MICHEL JEAN.Datos registrales. T 26045 , F 154, S 8, H M 219589, I/A 65 ( 2.12.09).

Nombramientos. Apoderado: CHARDONNENS MICHEL JEAN. Datos registrales. T 26045 , F 154, S 8, H M 219589, I/A 66 (2.12.09).

Revocaciones. Apoderado: PEREZ MOSQUERA ANTONIO;MCDONOUGH MARK E;DIAZ SIMAL JESUS;SERRANO SACRISTANPABLO;ASPIROZ CAMARA IDOIA LUCIA;PONS IZQUIERDO FERNANDO FRANCISCO;MENDEZ RODRIGUEZ MARTA;TERCEROVALENTIN PALOMA. Nombramientos. Apoderado: PEREZ MOSQUERA ANTONIO;MCDONOUGH MARK E;DIAZ SIMALJESUS;SERRANO SACRISTAN PABLO;ASPIROZ CAMARA IDOIA LUCIA;PONS IZQUIERDO FERNANDO FRANCISCO;MENDEZRODRIGUEZ MARTA;CHARDONNENS MICHEL JEAN;TERCERO VALENTIN PALOMA. Datos registrales. T 26045 , F 155, S 8, HM 219589, I/A 67 ( 2.12.09).

11 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: MCDONOUGH MARK E;HILL DONALD M.;PROPPER STEPHEN C;CAREY SHEILA A;SAUTNERMICHAEL G;JOHNSON IAN E;WADE RICHARD J;VAN DEN NOULAND HANS MAARTEN. Datos registrales. T 26045 , F 153, S 8,H M 219589, I/A 64 ( 1.12.09).

19 de Octubre de 2009
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26045 , F 153, S 8, H M 219589,I/A 63 ( 7.10.09).

22 de Septiembre de 2009
Reelecciones. Presidente: PEREZ MOSQUERA ANTONIO. Consejero: PEREZ MOSQUERA ANTONIO;SERRANO SACRISTANPABLO;FLEMING MICHAEL W. Modificaciones estatutarias. 9. Administraci贸n y Representacion.- Los miembros del Consejoejercer谩n el cargo por plazo de tres a帽os.. Datos registrales. T 26045 , F 152, S 8, H M 219589, I/A 62 (10.09.09).

21 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DE LA FUENTE MARIA DE LA PALOMA;MENDEZ RODRIGUEZ MARTA. Datosregistrales. T 26045 , F 152, S 8, H M 219589, I/A 61 (11.05.09).

03 de Abril de 2009
Revocaciones. Apo.Sol.: DE CORDOBA FONOLLA MANUEL. Datos registrales. T 26045 , F 151, S 8, H M 219589, I/A 58(21.03.09).

Nombramientos. Apoderado: GALLEGO MONTOYA ALFONSO. Datos registrales. T 26045 , F 151, S 8, H M 219589, I/A 59(21.03.09).

Nombramientos. Apoderado: GALLEGO MONTOYA ALFONSO. Datos registrales. T 26045 , F 152, S 8, H M 219589, I/A 60(21.03.09).

28 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: QUINLAN MICHAEL D. Nombramientos. Consejero: FLEMING MICHAEL W. Datos registrales. T21027 , F 225, S 8, H M 219589, I/A 57 (16.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n