Actos BORME de Sherpa Desarrollo Sl
20 de Octubre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: PELAYO DE SANCHO CARLOS. Apoderado: PELAYO DE SANCHO CARLOS. Apo.Man.Soli:NAVARRO ZAMORA EDUARDO;BRU TABERNERO ALFREDO. Apo.Manc.: AGUADO GARCIA FERNANDO. Nombramientos.Apo.Man.Soli: BRU TABERNERO ALFREDO;FERNANDEZ MIRET JORGE;PELAYO DE SANCHO CARLOS. Datos registrales. T38484 , F 213, S 8, H M 607626, I/A 17 (13.10.21).
01 de Abril de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BAIKAL MANAGEMENT SL. Representan: NAVARRO ZAMORA EDUARDO. Nombramientos.SecreNoConsj: ARTEAGA NIETO LUIS. Consejero: NAMGYAL INVESTMENTS SL;AGAWAM MANAGEMENT SL;FERSOMANAGEMENT SL. Presidente: NAMGYAL INVESTMENTS SL. Con.Delegado: NAMGYAL INVESTMENTS SL. Representan:NAVARRO ZAMORA EDUARDO;BRU TABERNERO ALFREDO;FERNANDEZ MIRET JORGE. Modificaciones estatutarias. 11.Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Datos registrales. T 38484 , F 211, S 8, H M 607626, I/A 16 (25.03.20).
11 de Febrero de 2020Revocaciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERGRUP SAP. Datos registrales. T 38484 , F 211, S 8, H M 607626, I/A 15 (4.02.20).
10 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: PELAYO DE SANCHO CARLOS ENRIQUE;FERNANDEZ MIRET JORGE. Datos registrales. T 38484 ,F 211, S 8, H M 607626, I/A 14 ( 3.10.19).
07 de Agosto de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: NAVARRO ZAMORA EDUARDO;BRU TABERNERO ALFREDO. Apo.Manc.: AGUADO GARCIAFERNANDO. Datos registrales. T 33760 , F 218, S 8, H M 607626, I/A 13 (31.07.19).
09 de Julio de 2019Nombramientos. Apoderado: PELAYO DE SANCHO CARLOS. Datos registrales. T 33760 , F 218, S 8, H M 607626, I/A 12 (2.07.19).
04 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: PELAYO DE SANCHO CARLOS. Datos registrales. T 33760 , F 216, S 8, H M 607626, I/A 11(28.05.19).
28 de Febrero de 2019Nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS IBERGRUP SAP. Datos registrales. T 33760 , F 216, S 8, H M 607626, I/A 10(21.02.19).
03 de Julio de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: BRU TABERNERO ALFREDO. Datos registrales. T 33760 , F 216, S 8, H M 607626, I/A 9 (23.06.17).
02 de Marzo de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: ESPERT DALMAU VICENTE JOSE. Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ MIRET JORGE.Datos registrales. T 33760 , F 215, S 8, H M 607626, I/A 8 (22.02.17).
20 de Enero de 2017Nombramientos. Apoderado: BRU TABERNERO ALFREDO;PELAYO DE SANCHO CARLOS;FERNANDEZ MIRET JORGE. Datosregistrales. T 33760 , F 215, S 8, H M 607626, I/A 7 (13.01.17).
05 de Diciembre de 2016Revocaciones. Apoderado: BESCHINSKY CORTAZAR JORGE. Datos registrales. T 33760 , F 214, S 8, H M 607626, I/A 5(24.11.16).
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MIRET JORGE. Datos registrales. T 33760 , F 214, S 8, H M 607626, I/A 6 (24.11.16).
22 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: QUARTEX INVESTMENTS SL. Representan: NAVARRO ZAMORA EDUARDO. Nombramientos.Representan: NAVARRO ZAMORA EDUARDO. Adm. Unico: SARAGUELA INVERSIONES SL. Datos registrales. T 33760 , F 214, S8, H M 607626, I/A 4 (12.08.16).
09 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: BESCHINSKY CORTAZAR JORGE. Datos registrales. T 33760 , F 213, S 8, H M 607626, I/A 3 (1.12.15).
13 de Octubre de 2015Modificaciones estatutarias. SE INCORPORA A LOS ESTATUTOS EL ARTIOCULO 11潞 BIS.- RETRIBUCION.- . Cambio dedomicilio social. C/ SERRANO 21 - 3潞 IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 33760 , F 213, S 8, H M 607626, I/A 2 (2.10.15).
05 de Febrero de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: ALEGRE VILLANUEVA MIGUEL;ESPERT DALMAU VICENTE JOSE. Datos registrales. T 9397, L6679, F 157, S 8, H V 146049, I/A 6 (29.01.14).
05 de Julio de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: ESPERT DALMAU VICENTE JOSE;PELAYO DE SANCHO CARLOS ENRIQUE. Datos registrales. T9397, L 6679, F 156, S 8, H V 146049, I/A 5 (28.06.13).
25 de Julio de 2012Nombramientos. Apoderado: NAVARRO ZAMORA EDUARDO. Datos registrales. T 9397, L 6679, F 156, S 8, H V 146049, I/A 4(16.07.12).
31 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: BRU TABERNERO ALFREDO. Datos registrales. T 9397, L 6679, F 156, S 8, H V 146049, I/A 3(20.01.12).
02 de Diciembre de 2011Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.10.11. Objeto social: SOCIAL La Sociedad tiene como objeto: (i) La prestaci贸n deservicios de asesor铆a y consultor铆a empresarial en el 谩mbito gerencial, organizativo, contable, financiero, laboral y de inversi贸n,reorganizaci贸n de la producci贸n, reestructuraci贸n del sistema de costes, as铆 como la estructura de personal d. Domicilio: PASEO DELA ALAMEDA 35 BIS, CUARTA PLANTA DERECHA (VALENCIA). Capital: 3.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico:QUARTEX INVESTMENTS SL. Otros conceptos: designacion de persona fisica representante para la Adminsitradora Unica, a donEDUARDO NAVARRO ZAMORA. Datos registrales. T 9397, L 6679, F 154, S 8, H V 146049, I/A 1 (23.11.11).
Nombramientos. Apo.Manc.: ESPERT DALMAU VICENTE JOSE;ALEGRE VILLANUEVA MIGUEL. Datos registrales. T 9397, L6679, F 155, S 8, H V 146049, I/A 2 (23.11.11).