Actos BORME de Shiro Helmets Sa
27 de Noviembre de 2023Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: VEGA SG PTE.LTD. Datos registrales. T 3611 , F 36, S 8, H MU 11228, I/A 25 .(20.11.23).
06 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: LUCIA TOMAS GONZALEZ;ANTONIO TOMAS GONZALEZ. Nombramientos. Adm. Unico:ANTONIO TOMAS GONZALEZ. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores mancomunados aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 3611 , F 36, S 8, H MU 11228, I/A 25 (30.08.23).
05 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Auditor: BNFIX MEDITERRANEO AUDITORES S.A.P. Datos registrales. T 3611 , F 36, S 8, H MU 11228, I/A 24(30.12.22).
21 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO TOMAS GONZALEZ;LUCIA TOMAS GONZALEZ;VICTORIA TOMAS GONZALEZ;JOSEANTONIO RODERO RODERO. Presidente: ANTONIO TOMAS GONZALEZ. Vicepresid.: LUCIA TOMAS GONZALEZ. Secretario:JOSE ANTONIO RODERO RODERO. Vicesecret.: VICTORIA TOMAS GONZALEZ. Con.Delegado: JOSE ANTONIO RODERORODERO. Nombramientos. Adm. Mancom.: LUCIA TOMAS GONZALEZ;ANTONIO TOMAS GONZALEZ. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 608 , F 67,S 8, H MU 11228, I/A 23 (14.12.22).
21 de Enero de 2021Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 243.409,05 Euros. Desembolsado: 243.409,05 Euros. Resultante Suscrito: 2.216.524,88 Euros.Resultante Desembolsado: 2.216.524,88 Euros. Datos registrales. T 608 , F 67, S 8, H MU 11228, I/A 22 (14.01.21).
08 de Octubre de 2020Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 291.489,85 Euros. Desembolsado: 291.489,85 Euros. Resultante Suscrito: 1.973.115,83 Euros.Resultante Desembolsado: 1.973.115,83 Euros. Datos registrales. T 608 , F 67, S 8, H MU 11228, I/A 21 ( 2.10.20).
13 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO TOMAS GONZALEZ. Presidente: ANTONIO TOMAS GONZALEZ. Consejero: LUCIATOMAS GONZALEZ. Secretario: LUCIA TOMAS GONZALEZ. Consejero: VICTORIA TOMAS GONZALEZ. Vicesecret.: VICTORIATOMAS GONZALEZ. Cons.Del.Sol: VICTORIA TOMAS GONZALEZ;ANTONIO TOMAS GONZALEZ;LUCIA TOMAS GONZALEZ.Nombramientos. Consejero: ANTONIO TOMAS GONZALEZ;LUCIA TOMAS GONZALEZ;VICTORIA TOMAS GONZALEZ;JOSEANTONIO RODERO RODERO. Presidente: ANTONIO TOMAS GONZALEZ. Vicepresid.: LUCIA TOMAS GONZALEZ. Secretario:JOSE ANTONIO RODERO RODERO. Vicesecret.: VICTORIA TOMAS GONZALEZ. Con.Delegado: JOSE ANTONIO RODERORODERO. Datos registrales. T 608 , F 67, S 8, H MU 11228, I/A 20 ( 6.08.20).
21 de Noviembre de 2019Nombramientos. Auditor: AUDIEST AUDITORES SAP. Datos registrales. T 608 , F 66, S 8, H MU 11228, I/A 17 (14.11.19).
Revocaciones. Auditor: AUDIEST AUDITORES SAP. Datos registrales. T 608 , F 66, S 8, H MU 11228, I/A 18 (14.11.19).
Nombramientos. Auditor: BNFIX MEDITERRANEO AUDITORES S.A.P. Datos registrales. T 608 , F 66, S 8, H MU 11228, I/A 19(14.11.19).
02 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: PEDRO CELESTINO VIVES RIPOLL. Datos registrales. T 608 , F 66, S 8, H MU 11228, I/A 16(25.09.19).
08 de Junio de 2017Reelecciones. Consejero: ANTONIO TOMAS GONZALEZ. Presidente: ANTONIO TOMAS GONZALEZ. Consejero: LUCIA TOMASGONZALEZ. Secretario: LUCIA TOMAS GONZALEZ. Consejero: VICTORIA TOMAS GONZALEZ. Vicesecret.: VICTORIA TOMASGONZALEZ. Cons.Del.Sol: VICTORIA TOMAS GONZALEZ;ANTONIO TOMAS GONZALEZ;LUCIA TOMAS GONZALEZ. Datosregistrales. T 608 , F 66, S 8, H MU 11228, I/A 15 ( 1.06.17).
12 de Agosto de 2015Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 268.651,47 Euros. Desembolsado: 268.651,47 Euros. Resultante Suscrito: 1.681.625,98 Euros.Resultante Desembolsado: 1.681.625,98 Euros. Datos registrales. T 608 , F 66, S 8, H MU 11228, I/A 14 ( 5.08.15).
08 de Septiembre de 2014Fe de erratas: RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 12& EN EL SENTIDO DE QUE SE OMITIO LA PRIMA QUE LLEVANAPAREJADAS LAS PARTICIPACIONES REPRESENTANTIVAS DEL AUMENTO DE CAPITAL.- Datos registrales. T 608 , F 66, S 8,H MU 11228, I/A 13 ( 1.09.14).
27 de Febrero de 2014Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 324.545,40 Euros. Desembolsado: 324.545,40 Euros. Resultante Suscrito: 1.412.974,51 Euros.Resultante Desembolsado: 1.412.974,51 Euros. Datos registrales. T 608 , F 65, S 8, H MU 11228, I/A 12 (20.02.14).
29 de Julio de 2013Nombramientos. Auditor: SALVADOR VALERO MORENO;JUAN PEREZ CONESA. Datos registrales. T 608 , F 65, S 8, H MU11228, I/A 11 (23.07.13).
17 de Mayo de 2013Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.028.327,90 Euros. Desembolsado: 1.028.327,90 Euros. Resultante Suscrito: 1.088.429,11 Euros.Resultante Desembolsado: 1.088.429,11 Euros. Datos registrales. T 608 , F 65, S 8, H MU 11228, I/A 10 ( 9.05.13).
09 de Abril de 2012Nombramientos. Apoderado: PEDRO CELESTINO VIVES RIPOLL. Datos registrales. T 608 , F 64, S 8, H MU 11228, I/A 8(27.03.12).
13 de Octubre de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: JUAN MADRID CERVANTES. Datos registrales. T 608 , F 64, S 8, H MU 11228, I/A 7 ( 4.10.11).