Buscador CIF Logo

Actos BORME Shows On Demand Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Shows On Demand Sl

Actos BORME Shows On Demand Sl - B86990694

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Shows On Demand Sl con CIF B86990694

馃敊 Perfil de Shows On Demand Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Shows On Demand Sl

27 de Enero de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ BARREAL LORENA. Apo.Man.Soli: CASTELLANOS BERAZA EUGENIA;MARTINEZ VILAPALOMA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ BARREAL LORENA;CASTELLANOS BERAZA EUGENIA;ARIAS ANTOLINBEGO脩A;MARTINEZ VILA PALOMA;JIMENEZ MORCILLO JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 35913 , F 115, S 8, H M 578405,I/A 20 (20.01.23).

15 de Junio de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BRAOJOS SANCHEZ DANIEL. Datos registrales. T 35913 , F 115, S 8, H M 578405, I/A 19 (8.06.22).

12 de Enero de 2022
Ceses/Dimisiones. Representan: ARECHABALETA TORRONTEGUI I脩AKI. Nombramientos. Representan: IRIBARNEGARAYOLASO I脩IGO. Datos registrales. T 35913 , F 114, S 8, H M 578405, I/A 18 ( 4.01.22).

26 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ BARREAL LORENA. Apo.Man.Soli: CASTELLANOS BERAZA EUGENIA;MARTINEZ VILAPALOMA;BRAOJOS SANCHEZ DANIEL. Datos registrales. T 35913 , F 113, S 8, H M 578405, I/A 16 (19.10.20).

Cambio de domicilio social. C/ JOSEFA VALCARCEL NUMERO 40 BIS (MADRID). Datos registrales. T 35913 , F 114, S 8, H M578405, I/A 17 (19.10.20).

14 de Enero de 2020
Revocaciones. Apoderado: DE AZCARATE RODRIGUEZ ALVARO;DE AZCARATE RODRIGUEZ ALVARO;DE AZCARATERODRIGUEZ ALVARO. Nombramientos. Apoderado: GIDRON SANCHEZ DANIEL;DE AZCARATE RODRIGUEZALVARO;SANTALICES GARCIA-TU脩ON JOSE MARIA. Datos registrales. T 35913 , F 112, S 8, H M 578405, I/A 15 ( 7.01.20).

12 de Septiembre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ENRIQUEZ NISTAL LUIS;ARECHABALETA TORRONTEGUI I脩AKI;VALENCIA VON KORFFJOAQUIN;ARGAYA AMIGO I脩IGO;GIDRON SANCHEZ DANIEL;SANTALICES GARCIA-TU脩ON JOSE MARIA;ELGUEA URANGAMARIA JOSE;MORAN PASCUAL JENNIFER;MU脩OZ ARGUIARRO NURIA;ORCAJADA MURIEL IRENE;RODRIGUEZ SORIANOPATRICIA;SAN JOSE ESCRIBANO SARA. Datos registrales. T 35913 , F 111, S 8, H M 578405, I/A 14 ( 5.09.19).

14 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: MENDEZ MONTA脩O ANTONIO. Presidente: MENDEZ MONTA脩O ANTONIO. Consejero: ORTIZSANZ GONZALO;COMERESA PRENSA SL;CORPORACION DE NUEVOS MEDIOS DIGITALES SL.SecreNoConsj: PONCE DELEON CU脩AT ALMUDENA. Representan: DE CELIS RUIZ ROBERTO;GIDRON SANCHEZ DANIEL. Nombramientos. Representan:ARECHABALETA TORRONTEGUI I脩AKI;GIDRON SANCHEZ DANIEL. Adm. Mancom.: COMERESA PRENSA SL;CORPORACIONDE NUEVOS MEDIOS DIGITALES SL. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 7, 10, 11, 14 Y 20 DE LOSESTATUTOS SOCIALES. . Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradoresmancomunados. Cambio de domicilio social. C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 7. (MADRID). Datos registrales. T 35913 , F109, S 8, H M 578405, I/A 12 ( 7.08.19).

Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CORPORACION DE NUEVOS MEDIOS DIGITALES SL. Datos registrales. T35913 , F 110, S 8, H M 578405, I/A 13 ( 7.08.19).

16 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: DE AZCARATE RODRIGUEZ ALVARO. Datos registrales. T 35913 , F 109, S 8, H M 578405, I/A 11 (8.10.18).

17 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: DE AZCARATE RODRIGUEZ ALVARO. Datos registrales. T 35913 , F 108, S 8, H M 578405, I/A 10 (8.05.18).

25 de Octubre de 2017
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MENDEZ MONTA脩O ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: DE AZCARATE RODRIGUEZALVARO. Datos registrales. T 35913 , F 106, S 8, H M 578405, I/A 9 (17.10.17).

18 de Octubre de 2017
Modificaciones estatutarias. 11. LA ADMINISTRACION SOCIAL. MODOS DE ORGANIZACION.-. 15.CONVOCATORIA,CONSTITUCION Y FORMA DE DELIBERAR DEL CONSEJO.-. 21. FORMA Y CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA.-. Datosregistrales. T 35913 , F 106, S 8, H M 578405, I/A 8 ( 9.10.17).

10 de Julio de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ-PALLETE IZA ALEJANDRO;BASILAN INVESTMENTS SL. Representan: DEL POZOSANCHEZ GONZALO. Nombramientos. Representan: GIDRON SANCHEZ DANIEL;DE CELIS RUIZ ROBERTO. Consejero: ORTIZSANZ GONZALO;COMERESA PRENSA SL;CORPORACION DE NUEVOS MEDIOS DIGITALES SL. Datos registrales. T 35913 , F105, S 8, H M 578405, I/A 7 (29.06.17).

06 de Julio de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 17.895,00 Euros. Resultante Suscrito: 62.340,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Capital: 26.550,00Euros. Resultante Suscrito: 88.890,00 Euros. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7 , 10潞 11 , 12 ,13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 27 y 28潞 . Otros conceptos: REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datosregistrales. T 32141 , F 77, S 8, H M 578405, I/A 6 (29.06.17).

03 de Mayo de 2017
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 177.780,00 Euros. Resultante Suscrito: 44.445,00 Euros. Datos registrales. T 32141 , F

26 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Secretario: GOMEZ-PALLETE IZA ALEJANDRO. Nombramientos. SecreNoConsj: PONCE DE LEON CU脩ATALMUDENA. Datos registrales. T 32141 , F 76, S 8, H M 578405, I/A 4 (18.04.17).

23 de Enero de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 22.225,00 Euros. Resultante Suscrito: 222.225,00 Euros. Datos registrales. T 32141 , F 76, S 8, HM 578405, I/A 3 (13.01.17).

12 de Marzo de 2015
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ BALBINA VALVERDE 15(MADRID). Datos registrales. T 32141 , F 76, S 8, H M 578405, I/A 2 ( 4.03.15).

14 de Mayo de 2014
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 1.04.14. Objeto social: - La realizaci贸n de actividades a trav茅s de intemet o de cualquier otraplataforma de transmisi贸n de datos, as铆 como el suministro de servicios online y el desarrollo de plataformas relacionadas con lam煤sica. CNAE 4791. - La organizaci贸n y realizaci贸n de conciertos,... Domicilio: C/ SALUSTIANO OLOZAGA 5 1潞 - IZQUIERDA(MADRID). Capital: 200.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: GOMEZ-PALLETE IZA ALEJANDRO;MENDEZ MONTA脩OANTONIO;DEL POZO SANCHEZ GONZALO 000208649Q SLNE. Presidente: MENDEZ MONTA脩O ANTONIO. Secretario: GOMEZ-PALLETE IZA ALEJANDRO. Con.Delegado: MENDEZ MONTA脩O ANTONIO. Representan: DEL POZO SANCHEZ GONZALO. Datosregistrales. T 32141 , F 71, S 8, H M 578405, I/A 1 ( 6.05.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n