Buscador CIF Logo

Actos BORME Siconet Ingenieros Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Siconet Ingenieros Sa

Actos BORME Siconet Ingenieros Sa - A80437627

Tenemos registrados 34 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Siconet Ingenieros Sa con CIF A80437627

馃敊 Perfil de Siconet Ingenieros Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Siconet Ingenieros Sa

27 de Enero de 2017
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 31683 , F 198, S 8, H M 78136, I/A 54 (18.01.17).

07 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 31683 , F 198, S 8, H M 78136, I/A 53 (29.09.16).

15 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: VON PRABUCKI HURTADO CARLOS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOZANO RODRIGUEZ IVANFEDERICO;ARIAS CRUZ FEDERICO-CARLOS;MARTIN TERESO DIAZ ANTONIO FRANCISCO;CANTON POLINIOGREGORIO;HITOS DE CARDENAS EDUARDO;LLANOS CID MONTSERRAT. Datos registrales. T 31683 , F 196, S 8, H M 78136,I/A 51 ( 7.03.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO ARRABE MARTA MARIA;FERNANDEZ GONZALEZ EVA. Apoderado: CARABIAS FUENTESJUAN CARLOS;VILLALIBRE LOBATO JOSEFINA. Datos registrales. T 31683 , F 197, S 8, H M 78136, I/A 52 ( 7.03.16).

11 de Enero de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 31683 , F 196, S 8, H M 78136, I/A 50 (30.12.15).

26 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: CANTON POLINIO GREGORIO;HITOS DE CARDENAS EDUARDO. Datos registrales. T 31683 , F195, S 8, H M 78136, I/A 49 (19.11.15).

16 de Septiembre de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: HORNOS PRADOS GUSTAVO. Datos registrales. T 31683 , F 195, S 8, H M 78136, I/A 48 ( 9.09.15).

17 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Secretario: PEREZ DE LA SOTA FERNANDO JOSE. Consejero: SIOUFFI THIERRY ETIENNE PIERRE;DAVIDPERIS LATORRE;GARCIA PELLEJERO FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: GARCIA PELLEJERO FRANCISCO JAVIER. Presidente:SIOUFFI THIERRY ETIENNE PIERRE. Nombramientos. Adm. Unico: ATOS SPAIN SA. Representan: LOZANO RODRIGUEZ IVANFEDERICO. Modificaciones estatutarias. Derogar el texto 铆ntegro de los Estatutos Sociales, aprobando un nuevo Texto.. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambio de domicilio social.C/ ALBARRACIN NUMERO 25 (MADRID). Datos registrales. T 31683 , F 191, S 8, H M 78136, I/A 47 ( 9.06.15).

20 de Febrero de 2015
Nombramientos. Apoderado: LOZANO RODRIGUEZ IVAN FEDERICO;VON PRABUCKI HURTADO CARLOS;MARTIN TERESODIAZ ANTONIO FRANCISCO;CANTON POLINIO GREGORIO;HITOS DE CARDENAS EDUARDO;LLANOS CID MONTSERRAT.Datos registrales. T 31683 , F 189, S 8, H M 78136, I/A 46 (13.02.15).

31 de Julio de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 31683 , F 189, S 8, H M 78136, I/A 45 (23.07.14).

15 de Julio de 2014
Nombramientos. Apoderado: MONTERO REDONDO IVAN. Datos registrales. T 31683 , F 188, S 8, H M 78136, I/A 44 ( 8.07.14).

10 de Abril de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: COMA GONZALEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 31683 , F 188, S 8, H M 78136, I/A 43 (3.04.14).

10 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apoderado: GARCIA CUEVAS VICTOR ENRIQUE. Datos registrales. T 25163 , F 222, S 8, H M 78136, I/A 42(31.01.14).

27 de Septiembre de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25163 , F 222, S 8, H M 78136, I/A 41 (19.09.13).

24 de Septiembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: GALINDEZ ZUBIRIA PABLO. Datos registrales. T 25163 , F 222, S 8, H M 78136, I/A 40 (16.09.13).

11 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL VALLE SEPULVEDA JULIO. Presidente: DEL VALLE SEPULVEDA JULIO. Revocaciones.Apoderado: DESTISON PHILIPPE MARCEL. Nombramientos. Consejero: GARCIA PELLEJERO FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.:GARCIA PELLEJERO FRANCISCO JAVIER. Presidente: SIOUFFI THIERRY ETIENNE PIERRE. Apo.Sol.: GARCIA PELLEJEROFRANCISCO JAVIER;PERIS LATORRE DAVID;GARCIA CUEVAS VICTOR ENRIQUE. Apo.Man.Soli: GARCIA PELLEJEROFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 25163 , F 220, S 8, H M 78136, I/A 39 ( 4.06.13).

25 de Enero de 2013
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ GUIO ISABEL. Datos registrales. T 25163 , F 220, S 8, H M 78136, I/A 38 (17.01.13).

18 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VERGARA GUERRERO ANGEL. Datos registrales. T 25163 , F 219, S 8, H M 78136, I/A 36(10.12.12).

Revocaciones. Apoderado: DEL VALLE SEPULVEDA JULIO. Datos registrales. T 25163 , F 220, S 8, H M 78136, I/A 37 (10.12.12).

17 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: PERIS LATORRE DAVID. Datos registrales. T 25163 , F 219, S 8, H M 78136, I/A 35 ( 5.12.12).

30 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 25163 , F 218, S 8, H M 78136, I/A 34(21.11.12).

14 de Noviembre de 2012
Otros conceptos: Mediatne diligencia de de cotejo se subsana la inscripcion 32, en cuanto se consigno por error en el apartadoprimero, que la Sociedad otorgante se decia Bull Espa帽a, SA, siendo locorrecto "Siconet Ingenieros, SA潞". Datos registrales. T 25163, F 216, S 8, H M 78136, I/A 33 (31.10.12).

06 de Noviembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: DESTISON PHILIPPE MARCEL. Datos registrales. T 25163 , F 216, S 8, H M 78136, I/A 32(24.10.12).

17 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25163 , F 216, S 8, H M 78136, I/A 31 ( 5.10.12).

01 de Octubre de 2012
Reelecciones. Consejero: DEL VALLE SEPULVEDA JULIO;DAVID PERIS LATORRE. Presidente: DEL VALLE SEPULVEDA JULIO.Datos registrales. T 25163 , F 216, S 8, H M 78136, I/A 30 (19.09.12).

18 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GALINDEZ ZUBIRIA PABLO. Nombramientos. Consejero: SIOUFFI THIERRY ETIENNE PIERRE.Datos registrales. T 25163 , F 216, S 8, H M 78136, I/A 29 ( 7.07.12).

20 de Abril de 2012
Nombramientos. Apoderado: COMPANY PEJOAN MARTA. Datos registrales. T 25163 , F 214, S 8, H M 78136, I/A 27 (11.04.12).

Nombramientos. Apoderado: VERDEGAY ORTU脩O JOSE CARLOS. Datos registrales. T 25163 , F 215, S 8, H M 78136, I/A 28(11.04.12).

19 de Abril de 2012
Revocaciones. Apoderado: TOPHAM REGUERA OSWALDO;GRAU I PLADEVALL JOSE. Datos registrales. T 25163 , F 214, S 8,H M 78136, I/A 26 ( 2.04.12).

23 de Septiembre de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25163 , F 214, S 8, H M 78136, I/A 25 (13.09.11).

31 de Mayo de 2011
Nombramientos. Apoderado: MOLPECERES SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 25163 , F 213, S 8, H M 78136, I/A 24(19.05.11).

03 de Enero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ VALMAYOR RUIZ DE ALEGRIA ADOLFO JESUS. Nombramientos. Consejero:GALINDEZ ZUBIRIA PABLO. Datos registrales. T 25163 , F 213, S 8, H M 78136, I/A 22 (22.12.10).

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ VALMAYOR RUIZ DE ALEGRIA ADOLFO JESUS. Datos registrales. T 25163 , F 213, S8, H M 78136, I/A 23 (22.12.10).

23 de Enero de 2009
Revocaciones. Apoderado: DE LA ROSA VALVERDE GONZALO. Nombramientos. Apoderado: MERINO MORENA JAVIER.Datos registrales. T 25163 , F 212, S 8, H M 78136, I/A 21 (14.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n