Buscador CIF Logo

Actos BORME Sicpa Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sicpa Spain Sl

Actos BORME Sicpa Spain Sl - B84397462

Tenemos registrados 36 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Sicpa Spain Sl con CIF B84397462

馃敊 Perfil de Sicpa Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Sicpa Spain Sl

22 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33269 , F 204, S 8, H M 383844, I/A 41 (15.11.23).

28 de Agosto de 2023
Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ-ESCRIBANO CALSINA JOAQUIN. Secretario: FERNANDEZ-ESCRIBANO CALSINAJOAQUIN. Datos registrales. T 33269 , F 204, S 8, H M 383844, I/A 40 (21.08.23).

07 de Octubre de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33269 , F 204, S 8, H M 383844, I/A 39 (30.09.22).

21 de Febrero de 2022
Nombramientos. Apoderado: DE YEREGUI GUILLEN FRANCISCO JAVIER. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 38陋el poder otorgado a DE YEREGUI GUILLEN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 33269 , F 203, S 8, H M 383844, I/A 38 (1.12.21).

10 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: PEREZ RODRIGUEZ ALMUDENA. Datos registrales. T 33269 , F 203, S 8, H M 383844, I/A 38 (1.12.21).

18 de Octubre de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33269 , F 203, S 8, H M 383844, I/A 37 ( 8.10.21).

28 de Agosto de 2020
Reelecciones. Consejero: ROMERO MORENO JOSE MANUEL;SAROBE GONZALEZ MARTIN. Con.Delegado: SAROBEGONZALEZ MARTIN. Presidente: ROMERO MORENO JOSE MANUEL. Vicepresid.: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Datosregistrales. T 33269 , F 202, S 8, H M 383844, I/A 36 (21.08.20).

28 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33269 , F 202, S 8,H M 383844, I/A 35 (21.11.18).

10 de Octubre de 2018
Nombramientos. Vicepresid.: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 34陋 l apublicaci贸ndel nombramiento de vicepreseidente SABORE GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 33269 , F 202, S 8, H M 383844, I/A 34 (

09 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALEXANDER FREY RICHARD;MARTIAL GARD STEPHAN;AMON PHILIPPE. Vicepr.1: AMONPHILIPPE. Vicepr.2: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Secretario: FERNANDEZ ESCRIBANO CALSINA JOAQUIN. Nombramientos.Consejero: FERNANDEZ-ESCRIBANO CALSINA JOAQUIN. Secretario: FERNANDEZ-ESCRIBANO CALSINA JOAQUIN. Datosregistrales. T 33269 , F 202, S 8, H M 383844, I/A 34 ( 2.10.18).

13 de Noviembre de 2017
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SICPA FINANCE SA. Datos registrales. T 33269 , F 201, S 8, H M383844, I/A 33 ( 2.11.17).

20 de Enero de 2017
Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ RODRIGUEZ ALMUDENA. Datos registrales. T 33269 , F 201, S 8, H M 383844, I/A 32(10.01.17).

17 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33269 , F 201, S 8, H M 383844, I/A 31 ( 9.01.17).

25 de Noviembre de 2015
Cambio de objeto social. LA FABRICACION Y VENTA DE TINTAS PARA IMPRENTA Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS LACREACION, DESARROLLO,PROMOCION Y VENTA DE SOFTWARE PARA LA PROTECCION DE BIENES INDUSTRIALES Y DECONSUMO, ASI COMO DE MARCAS REGISTRADAS, INCLUYENDOSE DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD LAS SIGUIENTES: -SERVICIOS DE CAPTURA DE INFOR. Datos registrales. T 33269 , F 200, S 8, H M 383844, I/A 30 (17.11.15).

18 de Junio de 2015
Modificaciones estatutarias. Creacion del articulo 29 Bis en los estatutos sociales. . Datos registrales. T 21572 , F 225, S 8, H M383844, I/A 28 (10.06.15).

Ceses/Dimisiones. Presidente: AMON PHILIPPE. Vicepresid.: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Nombramientos. Consejero:ROMERO MORENO JOSE MANUEL. Presidente: ROMERO MORENO JOSE MANUEL. Vicepr.1: AMON PHILIPPE. Vicepr.2:SAROBE GONZALEZ MARTIN. Reelecciones. Consejero: AMON PHILIPPE;SAROBE GONZALEZ MARTIN. Con.Delegado:SAROBE GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 21572 , F 225, S 8, H M 383844, I/A 29 (10.06.15).

29 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: AMON MAURICE A. Nombramientos. Consejero: ALEXANDER FREY RICHARD;MARTIAL GARDSTEPHAN. Datos registrales. T 21572 , F 224, S 8, H M 383844, I/A 27 (21.05.15).

05 de Marzo de 2014
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES . Datos registrales. T 21572 ,F 224, S 8, H M 383844, I/A 26 (24.02.14).

11 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE YEREGUI GUILLEN FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Datosregistrales. T 21572 , F 223, S 8, H M 383844, I/A 25 ( 3.12.13).

28 de Noviembre de 2013
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MORENO MARIA DEL ROCIO. Datos registrales. T 21572 , F 222, S 8, H M 383844, I/A 24(21.11.13).

27 de Noviembre de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ RODRIGUEZ ALMUDENA;SAROBE GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 21572 , F222, S 8, H M 383844, I/A 23 (18.11.13).

11 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 21572 , F 222, S 8, H M 383844, I/A 22 ( 4.11.13).

20 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIO DONATE MARIANO. Vicepresid.: RUBIO DONATE MARIANO. Datos registrales. T 21572 ,F 222, S 8, H M 383844, I/A 21 ( 7.02.12).

07 de Febrero de 2011
Nombramientos. Consejero: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Con.Delegado: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Vicepresid.: SAROBEGONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 21572 , F 220, S 8, H M 383844, I/A 18 (27.01.11).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: RUBIO DONATE MARIANO. Revocaciones. Apoderado: GARCIA MORENO MARIA DELROCIO;SAROBE GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 21572 , F 220, S 8, H M 383844, I/A 19 (27.01.11).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MORENO MARIA DEL ROCIO. Datos registrales. T 21572 , F 220, S 8, H M 383844, I/A 20(27.01.11).

24 de Diciembre de 2010
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 21572 , F 219, S 8, H M 383844, I/A 17 (13.12.10).

25 de Octubre de 2010
Revocaciones. Apoderado: GOYA OLARTE JAVIER. Datos registrales. T 21572 , F 219, S 8, H M 383844, I/A 16 (14.10.10).

01 de Octubre de 2010
Reelecciones. Consejero: AMON PHILIPPE;RUBIO DONATE MARIANO;AMON MAURICE A. Presidente: AMON PHILIPPE.Vicepresid.: RUBIO DONATE MARIANO. Con.Delegado: RUBIO DONATE MARIANO. Datos registrales. T 21572 , F 218, S 8, H M383844, I/A 14 (20.09.10).

Ampliacion del objeto social. LA CREACION, DESARROLLO,PROMOCION Y VENTA DE SOFTWARE PARA LA PROTECCIONDE BIENES INDUSTRIALES Y DE CONSUMO, ASI COMO DE MARCAS REGISTRADAS. Datos registrales. T 21572 , F 219, S 8, HM 383844, I/A 15 (20.09.10).

08 de Abril de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 21572 , F 218, S8, H M 383844, I/A 13 (25.03.10).

29 de Marzo de 2010
Revocaciones. Apoderado: GARCIA MORENO MARIA DEL ROCIO. Apo.Man.Soli: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Otrosconceptos: SE REVOCAN LOS PODERES OTORGADOS EN LA INSCRIPCION 2& A DONJAVIER GOYA OLARTE SOLORESPECTO A LAS FACULTADES NUMEROS QUINTA Y SEXTA. Datos registrales. T 21572 , F 216, S 8, H M 383844, I/A 11(15.03.10).

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MORENO MARIA DEL ROCIO;SAROBE GONZALEZ MARTIN. Apo.Manc.: RUBIO DONATEMARIANO. Datos registrales. T 21572 , F 216, S 8, H M 383844, I/A 12 (17.03.10).

23 de Septiembre de 2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Apo.Manc.: GARCIA MORENO MARIA DEL ROCIO;GOYA OLARTEJAVIER. Datos registrales. T 21572 , F 118, S 8, H M 383844, I/A 10 (14.09.09).

15 de Junio de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 21572 , F 117, S8, H M 383844, I/A 9 ( 2.06.09).

16 de Abril de 2009
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SICPA SA. Datos registrales. T 21572 , F 117, S 8, H M 383844, I/A 8 ( 3.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n