Actos BORME de Sicpa Spain Sl
22 de Noviembre de 2023Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33269 , F 204, S 8, H M 383844, I/A 41 (15.11.23).
28 de Agosto de 2023Reelecciones. Consejero: FERNANDEZ-ESCRIBANO CALSINA JOAQUIN. Secretario: FERNANDEZ-ESCRIBANO CALSINAJOAQUIN. Datos registrales. T 33269 , F 204, S 8, H M 383844, I/A 40 (21.08.23).
07 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33269 , F 204, S 8, H M 383844, I/A 39 (30.09.22).
21 de Febrero de 2022Nombramientos. Apoderado: DE YEREGUI GUILLEN FRANCISCO JAVIER. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 38陋el poder otorgado a DE YEREGUI GUILLEN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 33269 , F 203, S 8, H M 383844, I/A 38 (1.12.21).
10 de Diciembre de 2021Nombramientos. Apoderado: PEREZ RODRIGUEZ ALMUDENA. Datos registrales. T 33269 , F 203, S 8, H M 383844, I/A 38 (1.12.21).
18 de Octubre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33269 , F 203, S 8, H M 383844, I/A 37 ( 8.10.21).
28 de Agosto de 2020Reelecciones. Consejero: ROMERO MORENO JOSE MANUEL;SAROBE GONZALEZ MARTIN. Con.Delegado: SAROBEGONZALEZ MARTIN. Presidente: ROMERO MORENO JOSE MANUEL. Vicepresid.: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Datosregistrales. T 33269 , F 202, S 8, H M 383844, I/A 36 (21.08.20).
28 de Noviembre de 2018Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33269 , F 202, S 8,H M 383844, I/A 35 (21.11.18).
10 de Octubre de 2018Nombramientos. Vicepresid.: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la Inscripci贸n 34陋 l apublicaci贸ndel nombramiento de vicepreseidente SABORE GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 33269 , F 202, S 8, H M 383844, I/A 34 (
09 de Octubre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ALEXANDER FREY RICHARD;MARTIAL GARD STEPHAN;AMON PHILIPPE. Vicepr.1: AMONPHILIPPE. Vicepr.2: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Secretario: FERNANDEZ ESCRIBANO CALSINA JOAQUIN. Nombramientos.Consejero: FERNANDEZ-ESCRIBANO CALSINA JOAQUIN. Secretario: FERNANDEZ-ESCRIBANO CALSINA JOAQUIN. Datosregistrales. T 33269 , F 202, S 8, H M 383844, I/A 34 ( 2.10.18).
13 de Noviembre de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SICPA FINANCE SA. Datos registrales. T 33269 , F 201, S 8, H M383844, I/A 33 ( 2.11.17).
20 de Enero de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ RODRIGUEZ ALMUDENA. Datos registrales. T 33269 , F 201, S 8, H M 383844, I/A 32(10.01.17).
17 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33269 , F 201, S 8, H M 383844, I/A 31 ( 9.01.17).
25 de Noviembre de 2015Cambio de objeto social. LA FABRICACION Y VENTA DE TINTAS PARA IMPRENTA Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS LACREACION, DESARROLLO,PROMOCION Y VENTA DE SOFTWARE PARA LA PROTECCION DE BIENES INDUSTRIALES Y DECONSUMO, ASI COMO DE MARCAS REGISTRADAS, INCLUYENDOSE DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD LAS SIGUIENTES: -SERVICIOS DE CAPTURA DE INFOR. Datos registrales. T 33269 , F 200, S 8, H M 383844, I/A 30 (17.11.15).
18 de Junio de 2015Modificaciones estatutarias. Creacion del articulo 29 Bis en los estatutos sociales. . Datos registrales. T 21572 , F 225, S 8, H M383844, I/A 28 (10.06.15).
Ceses/Dimisiones. Presidente: AMON PHILIPPE. Vicepresid.: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Nombramientos. Consejero:ROMERO MORENO JOSE MANUEL. Presidente: ROMERO MORENO JOSE MANUEL. Vicepr.1: AMON PHILIPPE. Vicepr.2:SAROBE GONZALEZ MARTIN. Reelecciones. Consejero: AMON PHILIPPE;SAROBE GONZALEZ MARTIN. Con.Delegado:SAROBE GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 21572 , F 225, S 8, H M 383844, I/A 29 (10.06.15).
29 de Mayo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: AMON MAURICE A. Nombramientos. Consejero: ALEXANDER FREY RICHARD;MARTIAL GARDSTEPHAN. Datos registrales. T 21572 , F 224, S 8, H M 383844, I/A 27 (21.05.15).
05 de Marzo de 2014Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES . Datos registrales. T 21572 ,F 224, S 8, H M 383844, I/A 26 (24.02.14).
11 de Diciembre de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE YEREGUI GUILLEN FRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Datosregistrales. T 21572 , F 223, S 8, H M 383844, I/A 25 ( 3.12.13).
28 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apoderado: GARCIA MORENO MARIA DEL ROCIO. Datos registrales. T 21572 , F 222, S 8, H M 383844, I/A 24(21.11.13).
27 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: PEREZ RODRIGUEZ ALMUDENA;SAROBE GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 21572 , F222, S 8, H M 383844, I/A 23 (18.11.13).
11 de Noviembre de 2013Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 21572 , F 222, S 8, H M 383844, I/A 22 ( 4.11.13).
20 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: RUBIO DONATE MARIANO. Vicepresid.: RUBIO DONATE MARIANO. Datos registrales. T 21572 ,F 222, S 8, H M 383844, I/A 21 ( 7.02.12).
07 de Febrero de 2011Nombramientos. Consejero: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Con.Delegado: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Vicepresid.: SAROBEGONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 21572 , F 220, S 8, H M 383844, I/A 18 (27.01.11).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: RUBIO DONATE MARIANO. Revocaciones. Apoderado: GARCIA MORENO MARIA DELROCIO;SAROBE GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 21572 , F 220, S 8, H M 383844, I/A 19 (27.01.11).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MORENO MARIA DEL ROCIO. Datos registrales. T 21572 , F 220, S 8, H M 383844, I/A 20(27.01.11).
24 de Diciembre de 2010Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 21572 , F 219, S 8, H M 383844, I/A 17 (13.12.10).
25 de Octubre de 2010Revocaciones. Apoderado: GOYA OLARTE JAVIER. Datos registrales. T 21572 , F 219, S 8, H M 383844, I/A 16 (14.10.10).
01 de Octubre de 2010Reelecciones. Consejero: AMON PHILIPPE;RUBIO DONATE MARIANO;AMON MAURICE A. Presidente: AMON PHILIPPE.Vicepresid.: RUBIO DONATE MARIANO. Con.Delegado: RUBIO DONATE MARIANO. Datos registrales. T 21572 , F 218, S 8, H M383844, I/A 14 (20.09.10).
Ampliacion del objeto social. LA CREACION, DESARROLLO,PROMOCION Y VENTA DE SOFTWARE PARA LA PROTECCIONDE BIENES INDUSTRIALES Y DE CONSUMO, ASI COMO DE MARCAS REGISTRADAS. Datos registrales. T 21572 , F 219, S 8, HM 383844, I/A 15 (20.09.10).
08 de Abril de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 21572 , F 218, S8, H M 383844, I/A 13 (25.03.10).
29 de Marzo de 2010Revocaciones. Apoderado: GARCIA MORENO MARIA DEL ROCIO. Apo.Man.Soli: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Otrosconceptos: SE REVOCAN LOS PODERES OTORGADOS EN LA INSCRIPCION 2& A DONJAVIER GOYA OLARTE SOLORESPECTO A LAS FACULTADES NUMEROS QUINTA Y SEXTA. Datos registrales. T 21572 , F 216, S 8, H M 383844, I/A 11(15.03.10).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA MORENO MARIA DEL ROCIO;SAROBE GONZALEZ MARTIN. Apo.Manc.: RUBIO DONATEMARIANO. Datos registrales. T 21572 , F 216, S 8, H M 383844, I/A 12 (17.03.10).
23 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAROBE GONZALEZ MARTIN. Apo.Manc.: GARCIA MORENO MARIA DEL ROCIO;GOYA OLARTEJAVIER. Datos registrales. T 21572 , F 118, S 8, H M 383844, I/A 10 (14.09.09).
15 de Junio de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 21572 , F 117, S8, H M 383844, I/A 9 ( 2.06.09).
16 de Abril de 2009Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SICPA SA. Datos registrales. T 21572 , F 117, S 8, H M 383844, I/A 8 ( 3.04.09).