Actos BORME de Siderurgica Sevillana Sa
11 de Agosto de 2023Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6348 , F 170, S 8, H SE1629, I/A 118 ( 4.08.23).
16 de Marzo de 2022Reelecciones. Consejero: RUZ ORAA IGNACIO. Presidente: RIVA CLAUDIO. Cons.Del.Sol: RIVA CLAUDIO. Cons.Del.Man:IPPOLITI ANGELO;RUZ ORAA IGNACIO. Datos registrales. T 6348 , F 169, S 8, H SE 1629, I/A 117 ( 8.03.22).
05 de Noviembre de 2020Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 6348 , F 169, S 8, HSE 1629, I/A 116 (26.10.20).
03 de Julio de 2020Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: RUZ ORAA IGNACIO. Cons.Del.Sol: RIVA CLAUDIO. Cons.Del.Man: IPPOLITI ANGELO.Nombramientos. Cons.Del.Sol: RIVA CLAUDIO. Cons.Del.Man: IPPOLITI ANGELO;RUZ ORAA IGNACIO. Reelecciones.Consejero: RIVA CLAUDIO;IPPOLITI ANGELO. Presidente: RIVA CLAUDIO. Datos registrales. T 6348 , F 168, S 8, H SE 1629, I/A115 (25.06.20).
15 de Enero de 2020Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6348 , F 168, S 8, H SE 1629, I/A 114 (7.01.20).
07 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CASTRO RAMOS CARLOS MANUEL. Nombramientos. SecreNoConsj: CASTRO ALBERTOMANUEL. Datos registrales. T 6348 , F 167, S 8, H SE 1629, I/A 113 (26.12.19).
09 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6348 , F 167, S 8, H SE 1629, I/A 112(28.12.18).
25 de Octubre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: SAMORE MARTIN MARCO;RUZ ORAA IGNACIO;CASTRO ALBERTO MANUEL;IPPOLITI ANGELO.Datos registrales. T 6348 , F 166, S 8, H SE 1629, I/A 110 (17.10.18).
Nombramientos. Apo.Manc.: RUZ ORAA IGNACIO;SAMORE MARTIN MARCO;ORTIZ MOYANO PABLO;CASTRO ALBERTOMANUEL. Datos registrales. T 6348 , F 166, S 8, H SE 1629, I/A 111 (17.10.18).
10 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6348 , F 166, S 8, H SE 1629, I/A 109 (2.01.18).
11 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: CARRILLO DE ALBORNOZ LOPEZ IGNACIO. Cons.Del.Man: CARRILLO DE ALBORNOZ LOPEZIGNACIO. Revocaciones. Apo.Manc.: CARRILLO DE ALBORNOZ LOPEZ IGNACIO;RUZ ORAA IGNACIO;CASTRO ALBERTO
Nombramientos. Apo.Manc.: SAMORE MARTIN MARCO;RUZ ORAA IGNACIO;CASTRO ALBERTO MANUEL;IPPOLITI ANGELO.Datos registrales. T 6348 , F 165, S 8, H SE 1629, I/A 108 ( 3.04.17).
19 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5712 , F 10, S 8, H SE 1629, I/A 106(12.01.17).
27 de Octubre de 2016Fusi贸n por uni贸n. Sociedades que se fusi贸nan: HIERROS DEL SUR SA. Datos registrales. T 5712 , F 6, S 8, H SE 1629, I/A 105(18.10.16).
13 de Mayo de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: IPPOLITI ANGELO;CARRILLO DE ALBORNOZ LOPEZ IGNACIO;RUZ ORAA IGNACIO. Datosregistrales. T 5712 , F 5, S 8, H SE 1629, I/A 104 ( 5.05.16).
12 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5712 , F 4, S 8, H SE 1629, I/A 103(29.12.15).
25 de Agosto de 2015Nombramientos. Apo.Manc.: CARRILLO DE ALBORNOZ LOPEZ IGNACIO;RUZ ORAA IGNACIO;CASTRO ALBERTOMANUEL;IPPOLITI ANGELO;SAMORE MARTIN MARCO. Datos registrales. T 5712 , F 4, S 8, H SE 1629, I/A 102 (17.08.15).
10 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RIVA NICOLA;RIVA CESARE;POZZI MAURO. Presidente: RIVA NICOLA. Vicepresid.: RIVACESARE. Cons.Del.Sol: RIVA NICOLA;RIVA CESARE. Revocaciones. Apoderado: POZZI MAURO. Apo.Manc.: CARRILLO DEALBORNOZ LOPEZ IGNACIO;PALOMO GARCIA ANTONIO. Nombramientos. Consejero: RIVA CLAUDIO;IPPOLITIANGELO;CARRILLO DE ALBORNOZ LOPEZ IGNACIO. Presidente: RIVA CLAUDIO. Cons.Del.Sol: RIVA CLAUDIO. Cons.Del.Man:IPPOLITI ANGELO;CARRILLO DE ALBORNOZ LOPEZ IGNACIO. Datos registrales. T 5712 , F 3, S 8, H SE 1629, I/A 101 (2.07.15).
05 de Junio de 2015Modificaciones estatutarias. 32. Retribuci贸n.-. Datos registrales. T 5712 , F 2, S 8, H SE 1629, I/A 100 (28.05.15).
16 de Diciembre de 2014Reelecciones. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5712 , F 2, S 8, H SE 1629, I/A 99 (9.12.14).
21 de Marzo de 2014Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 13潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ADICIONADO A LOSESTATUTOS SOCIALES EL ARTICULO 23潞BIS.. ADICIONADO A LOS ESTATUTOS SOCIALES EL ARTICULO 32潞BIS. P谩gina webde la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.siderurgicasevillana.com. Datos registrales. T 5712 , F 2, S 8, H SE1629, I/A 98 (11.03.14).
14 de Febrero de 2014Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Aud.C.Con.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5712 , F 1, S 8, H SE 1629, I/A 97 (3.02.14).
04 de Julio de 2013Reelecciones. Consejero: RIVA NICOLA;RIVA CESARE;POZZI MAURO. Presidente: RIVA NICOLA. Vicepresid.: RIVA CESARE.Cons.Del.Sol: RIVA NICOLA;RIVA CESARE. Modificaciones estatutarias. 32.Retribuci贸n .-. Datos registrales. T 4189 , F 140, S8, H SE 1629, I/A 96 (26.06.13).
31 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4189 , F 140, S 8, H SE 1629, I/A 95 (19.12.12).
07 de Febrero de 2012Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 65.000.000,00 Euros. Desembolsado: 65.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 98.100.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 98.100.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 4189 , F 139, S 8, H SE 1629, I/A 94 (25.01.12).
03 de Febrero de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4189 , F 139, S 8, H SE 1629, I/A 93 (24.01.12).
27 de Diciembre de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: LEON MATEO MARIANO. Nombramientos. SecreNoConsj: CASTRO RAMOS CARLOSMANUEL. Datos registrales. T 4189 , F 138, S 8, H SE 1629, I/A 92 ( 7.12.11).
10 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 27.000.000,00 Euros. Desembolsado: 27.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 33.100.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 33.100.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: MODIFICACIONDEL ARTICULO 5潞 DELOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 4189 , F 137, S 8, H SE 1629, I/A 91 (31.01.11).
28 de Diciembre de 2010Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4189 , F 137, S 8, H SE 1629, I/A 90 (17.12.10).
22 de Diciembre de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4189 , F 137, S 8, H SE 1629, I/A 89 (11.12.09).
10 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: CARRILLO DE ALBORNOZ LOPEZ IGNACIO;PALOMO GARCIA ANTONIO. Datos registrales. T4189 , F 136, S 8, H SE 1629, I/A 87 (26.10.09).
Revocaciones. Apo.Manc.: CARRILLO DE ALBORNOZ LOPEZ IGNACIO;LEON MATEOS MARIANO;PALOMO GARCIA ANTONIO.Datos registrales. T 4189 , F 137, S 8, H SE 1629, I/A 88 (26.10.09).
16 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: RIVA FABIO. Nombramientos. Consejero: POZZI MAURO. Reelecciones. Presidente: RIVANICOLA. Vicepresid.: RIVA CESARE. Cons.Del.Sol: RIVA NICOLA;RIVA CESARE. Datos registrales. T 4189 , F 136, S 8, H SE1629, I/A 86 (29.09.09).
03 de Junio de 2009Revocaciones. Apoderado: POZZI MAURO. Nombramientos. Apoderado: MAURO POZZI. Datos registrales. T 4189 , F 135, S 8,H SE 1629, I/A 85 (19.05.09).
20 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BENITEZ ROMERO ENRIQUE. Nombramientos. SecreNoConsj: LEON MATEO MARIANO.Datos registrales. T 4189 , F 134, S 8, H SE 1629, I/A 83 ( 7.01.09).
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4189 , F 134, S 8, H SE 1629, I/A 84 ( 7.01.09).