Actos BORME de Sidra Trabanco Sa
21 de Septiembre de 2022Revocaciones. Cons.Del.Man: TRABANCO MENENDEZ JACQUELINE;TRABANCO FERNANDEZ LORENZO;TRABANCOMENENDEZ EMILIO;TRABANCO FERNANDEZ MARIA DE LA MERCED. Vicepresid.: TRABANCO FERNANDEZ LORENZO.Nombramientos. Cons.Del.Man: TRABANCO FERNANDEZ MARIA DE LA MERCED;TRABANCO MENENDEZ EMILIO;TRABANCOFERNANDEZ LORENZO;TRABANCO MENENDEZ JACQUELINE. Reelecciones. Consejero: TRABANCO MENENDEZJACQUELINE. Presidente: TRABANCO MENENDEZ EMILIO. Consejero: TRABANCO FERNANDEZ LORENZO;TRABANCOMENENDEZ EMILIO;TRABANCO FERNANDEZ MARIA DE LA MERCED. Secretario: TRABANCO MENENDEZ JACQUELINE. Datosregistrales. T 1086 , F 109, S 8, H AS 1568, I/A 16 (13.09.22).
11 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: TRABANCO MENENDEZ EMILIO;TRABANCO FERNANDEZ LORENZO;TRABANCOMENENDEZ JACQUELINE;TRABANCO FERNANDEZ MARIA DE LA MERCED. Nombramientos. Cons.Del.Man: TRABANCOMENENDEZ EMILIO;TRABANCO FERNANDEZ LORENZO;TRABANCO MENENDEZ JACQUELINE;TRABANCO FERNANDEZMARIA DE LA MERCED. Reelecciones. Consejero: TRABANCO FERNANDEZ LORENZO;TRABANCO FERNANDEZ MARIA DE LAMERCED. Presidente: TRABANCO MENENDEZ EMILIO. Vicepresid.: TRABANCO FERNANDEZ LORENZO. Secretario: TRABANCOMENENDEZ JACQUELINE. Consejero: TRABANCO MENENDEZ EMILIO;TRABANCO MENENDEZ JACQUELINE. Datosregistrales. T 1086 , F 109, S 8, H AS 1568, I/A 15 ( 3.09.18).
06 de Abril de 2015Nombramientos. Auditor: CONDE PANASA LUIS ALFONSO. Aud.Supl.: CORUJEDO FERNANDEZ LUIS. Otros conceptos:Cambio de orden de los apellidos de los miembros del consejo de administraci贸n DO脩A JACQUELINE MENENDEZ TRABANCO yDON EMILIO MENENDEZ TRABANCO, que pasan a ser TRABANCO MENENDEZ. Datos registrales. T 1086 , F 108, S 8, H AS1568, I/A 13 (24.03.15).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.001.300,00 Euros. Desembolsado: 1.001.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.101.300,00 Euros.Resultante Desembolsado: 3.101.300,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 1086 , F 109, S 8, H AS 1568, I/A 14 (25.03.15).
16 de Mayo de 2012Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: TRABANCO FERNANDEZ MARIA DE LA MERCED;MENENDEZ TRABANCOJACQUELINE;MENENDEZ TRABANCO EMILIO;TRABANCO FERNANDEZ LORENZO. Nombramientos. Cons.Del.Man:MENENDEZ TRABANCO EMILIO;TRABANCO FERNANDEZ LORENZO;MENENDEZ TRABANCO JACQUELINE;TRABANCOFERNANDEZ MARIA DE LA MERCED. Reelecciones. Consejero: MENENDEZ TRABANCO EMILIO;TRABANCO FERNANDEZLORENZO;MENENDEZ TRABANCO JACQUELINE;TRABANCO FERNANDEZ MARIA DE LA MERCED. Presidente: MENENDEZTRABANCO EMILIO. Vicepresid.: TRABANCO FERNANDEZ LORENZO. Secretario: MENENDEZ TRABANCO JACQUELINE. Datosregistrales. T 1086 , F 108, S 8, H AS 1568, I/A 12 ( 3.05.12).
26 de Octubre de 2011Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 300.000,00 Euros. Desembolsado: 300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.100.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 2.100.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 1086 , F 108, S 8, H AS 1568, I/A 11 (14.10.11).
03 de Septiembre de 2009Nombramientos. Auditor: CONDE PANASA LUIS ALFONSO. Aud.Supl.: CORUJEDO FERNANDEZ LUIS. Datos registrales. T1086 , F 107, S 8, H AS 1568, I/A 9 (20.08.09).
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.703.840,00 Euros. Desembolsado: 1.703.840,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.800.000,00 Euros.Resultante Desembolsado: 1.800.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Capital.-. Datosregistrales. T 1086 , F 107, S 8, H AS 1568, I/A 10 (20.08.09).