Actos BORME de Siemens Renting Sa
07 de Junio de 2023Nombramientos. Apoderado: LEUFFEN SARAH. Datos registrales. T 42222 , F 172, S 8, H M 172561, I/A 170 (31.05.23).
Cambio de denominación social. SIEMENS FINANCIAL SERVICES SA. Datos registrales. T 42222 , F 174, S 8, H M 172561, I/A171 (31.05.23).
12 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: KLEIN MARTIN. Nombramientos. Consejero: DEPO-STANISZEWSKA ANETA. Datos registrales.T 42222 , F 172, S 8, H M 172561, I/A 169 ( 4.01.23).
16 de Diciembre de 2022Revocaciones. Apoderado: HIDALGO CASAS JOSE MARIA;SORIA GUTIERREZ EUGENIO. Datos registrales. T 42222 , F 169, S8, H M 172561, I/A 168 ( 9.12.22).
21 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 42222 , F 169, S 8, H M 172561, I/A 167 (14.11.22).
23 de Mayo de 2022Reelecciones. Consejero: FOLTYN CHRISTIAN. Datos registrales. T 42222 , F 164, S 8, H M 172561, I/A 163 (13.05.22).
Reelecciones. Presidente: FOLTYN CHRISTIAN. Datos registrales. T 42222 , F 164, S 8, H M 172561, I/A 164 (13.05.22).
Revocaciones. Apoderado: SORIA GUTIERREZ EUGENIO;CONDE TRUJILLO JOSE JAVIER;PEÑA JIMENEZ YOANA.Apo.Man.Soli: WOLFF ANDREAS KLAUS;CADENAS VAZQUEZ ANTONIO. Apoderado: CADENAS VAZQUEZ ANTONIO;GOMEZMILLAN ELENA;WOLFF ANDREAS. Nombramientos. Apoderado: GARCIA GUILLEN BLANCA;ROJO REVENGA CLARA;GOMEZMILLAN ELENA;BERRIO JIMENEZ FATIMA;CORNEJO ALONSO MARIA CAMINO;GONZALEZ GARCIA MARIA JOSE. Otrosconceptos: Revocada la facultad 11, otorgada a doña Clara Rojo Revenga, en virtud de escritura de poder, en escritura autorizada el4/2/2020 por el Notario don David del Arco Ramos, número 236 de su protocolo, que causó la inscripción 150ª de la Hoja social.Revocada la facultad 11, otorgada a don Vasile Andrei Nechifor, en virtud de escritura de poder, en escritura autorizada el 22/10/2020por el Notario don David del Arco Ramos, número 1889 de su protocolo, que causó la inscripción 151ª de la Hoja social. Revocadas lasfacultades 2,3,4,5,8,9,10,13,16,17,23,25,28,33,34,35,40,41,42 y 43 otorgadas a don Eugenio Soria Gutiérrez el 31/1/2014 ante elNotario don David del Arco Ramos número 149 de protocolo, que causó la inscripción 76ª. Revocadas las facultades 19 y 38,otorgadas a don Andreas Klaus Wolf, en virtud de escritura de poder, en escritura autorizada el 4/6/2018 por el Notario don David delArco Ramos, número 957 de su protocolo, que causó la inscripción 141ª de la Hoja social. Revocadas las facultades 4,5,6,13 y 18,otorgadas a don Antonio Cadenas Vázque, en virtud de escritura de poder, en escritura autorizada el 25/7/2018 por el Notario donDavid del Arco Ramos, número 1582 de su protocolo, que causó la inscripción 142ª de la Hoja social. Datos registrales. T 42222 , F164, S 8, H M 172561, I/A 165 (13.05.22).
02 de Noviembre de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 42222 , F 164, S 8, H M 172561, I/A 162 (25.10.21).
29 de Octubre de 2021Nombramientos. Apo.Manc.: ARIZA BERTOLIM THAIS;BEUSS FRANK. Apo.Man.Soli: LEGARRETA LEGARRETA HIART.Apo.Manc.: CADENAS VAZQUEZ ANTONIO. Datos registrales. T 42222 , F 160, S 8, H M 172561, I/A 161 (23.10.21).
24 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apoderado: VON HESLER NIKOLAUS MARIA INNOZENZ RASSO KONSTANTI. Nombramientos. Apoderado:RIDDER SUSANNE. Datos registrales. T 40956 , F 60, S 8, H M 172561, I/A 160 (17.09.21).
20 de Julio de 2021Reelecciones. Consejero: KLEIN MARTIN. Datos registrales. T 40956 , F 60, S 8, H M 172561, I/A 159 (13.07.21).
19 de Julio de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: SIEMENS FINANCIAL SERVICES GMBH. Datos registrales. T40956 , F 60, S 8, H M 172561, I/A 158 (12.07.21).
13 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Man.Soli: CELDRAN GONZALEZ MARTA. Apo.Manc.: GONZALEZ GARCIA MARIA JOSE. Otros conceptos:Revocadas las facultades 9, 11 y 14 a doña Marta Celdrán González, otorgadas en la escritura autorizada el día 14 de enero de 2019por el notario de Tres Cantos, don David del Arco Ramos, número 63 de protocolo y que causó la inscripción 145ª en la hoja social.Datos registrales. T 40956 , F 57, S 8, H M 172561, I/A 157 ( 6.05.21).
22 de Marzo de 2021Revocaciones. Apoderado: SANZ SANZ GEMA. Apo.Sol.: HERRERO GARCIA SAGRARIO. Nombramientos. Apoderado: GARCIAGUILLEN BLANCA;ARIZA BERTOLIM THAYS. Datos registrales. T 40956 , F 53, S 8, H M 172561, I/A 155 (12.03.21).
Reelecciones. Consejero: CAMPON ALONSO ANA. Datos registrales. T 40956 , F 57, S 8, H M 172561, I/A 156 (12.03.21).
09 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 40956 , F 53, S 8, H M 172561, I/A 154 ( 2.03.21).
31 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apoderado: HERRERA ARMAS ADELA;GONZALEZ GARCIA MARIA JOSE;SANZ GONZALEZ JUAN;WOLFFANDREAS.Apo.Man.Soli: CADENAS VAZQUEZ ANTONIO. Apoderado: ESCALONILLA FERNANDEZ RAFAEL;SIERRA LOPEZALFONSO;JUNCADELLA GUIA CRISTINA;AREVALO OLMO AFRICA;GOMEZ MILLAN ELENA;CORNEJO ALONSO MARIACAMINO;GARCIA GUIL JOSE LUIS;REMIS FERNANDEZ GEMA;SANTIAGO CASTILLO ANGELICA;FERNANDEZ GARCIABEATRIZ. Nombramientos. Apoderado: CADENAS VAZQUEZ ANTONIO;JUNCADELLA GUIA CRISTINA;AREVALO OLMOAFRICA;CORNEJO ALONSO MARIA CAMINO;HERRERA ARMAS ADELA;FERNANDEZ GARCIA BEATRIZ;GARCIA GUIL JOSELUIS;SANTIAGO CASTILLO ANGELICA;GONZALEZ GARCIA MARIA JOSE;REMIS FERNANDEZ GEMA;GOMEZ MILLANELENA;SANZ GONZALEZ JUAN;WOLFF ANDREAS;MUÑIZ GARCIA MANUEL;SIERRA LOPEZ ALFONSO. Datos registrales. T40956 , F 50, S 8, H M 172561, I/A 153 (23.12.20).
16 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: NECHIFOR VASILE ANDREI. Datos registrales. T 38676 , F 66, S 8, H M 172561, I/A 151 ( 6.11.20).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ VALCARCEL CECILIA;BEUSS FRANK;HERRERA MORGADEZ ISABEL;MOREDAGALANTE ANA MARIA. Datos registrales. T 38676 , F 69, S 8, H M 172561, I/A 152 ( 6.11.20).
04 de Marzo de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARIGIL ALDA LAURA. Apo.Manc.: ROJO REVENGA CLARA. Datos registrales. T 38676 , F 63,S 8, H M 172561, I/A 150 (27.02.20).
11 de Noviembre de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: FIORINI TALAVERA MABELA LAURA. Apo.Sol.: FIORINI TALAVERA MABELA LAURA. Apo.Manc.:SANCHEZ TORRES BEATRIZ. Apo.Sol.: SANCHEZ TORRES BEATRIZ. Datos registrales. T 38676 , F 61, S 8, H M 172561, I/A 149( 4.11.19).
14 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: CORNEJO ALONSO MARIA CAMINO;SIERRA LOPEZ ALFONSO;SANTIAGO CASTILLOANGELICA;GARCIA GUIL JOSE LUIS;REMIS FERNANDEZ GEMA;GOMEZ MILLAN ELENA. Apo.Man.Soli: AREVALO OLMOAFRICA;JUNCADELLA GUIA CRISTINA. Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GARCIA MARIA JOSE;SIERRA LOPEZALFONSO;JUNCADELLA GUIA CRISTINA;HERRERA ARMAS ADELA;AREVALO OLMO AFRICA;GOMEZ MILLANELENA;CORNEJO ALONSO MARIA CAMINO;GARCIA GUIL JOSE LUIS;REMIS FERNANDEZ GEMA;SANTIAGO CASTILLOANGELICA;FERNANDEZ GARCIA BEATRIZ. Datos registrales. T 38676 , F 58, S 8, H M 172561, I/A 148 ( 7.10.19).
01 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 38676 , F 58, S 8, H M 172561, I/A 147 (24.09.19).
30 de Abril de 2019Reelecciones. Consejero: FOLTYN CHRISTIAN. Presidente: FOLTYN CHRISTIAN. Datos registrales. T 38676 , F 57, S 8, H M172561, I/A 146 (23.04.19).
18 de Febrero de 2019Nombramientos. Apoderado: VON HESLER NIKOLAUS MARIA INNOZENZ RASSO KONSTANTI;CELDRAN GONZALEZMARTA;LOZANO MARTINEZ LYDIA;GOMEZ MILLAN ELENA;ESCALONILLA FERNANDEZ RAFAEL. Datos registrales. T 38676 , F55, S 8, H M 172561, I/A 145 (11.02.19).
07 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31861 , F 147, S 8, H M 172561, I/A 144 (30.11.18).
16 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apoderado: REYNALDO SANCHEZ RICARDO;CUESTA ESCRIBANO EMILIANO. Nombramientos. Apo.Sol.:MARTINEZ PEREZ MARIA. Apo.Man.Soli: EINICKE MARIA LUISA;AREVALO OLMO AFRICA;WOLFF ANDREAS KLAUS;CADENASVAZQUEZ ANTONIO;JUNCADELLA GUIA CRISTINA. Datos registrales. T 31861 , F 144, S 8, H M 172561, I/A 143 ( 8.11.18).
27 de Agosto de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: SALAMANCA CEJUDO SUSANA;HERRERO GARCIA SAGRARIO. Apo.Man.Soli: CADENAS VAZQUEZANTONIO. Datos registrales. T 31861 , F 142, S 8, H M 172561, I/A 142 (20.08.18).
29 de Junio de 2018Revocaciones. Apoderado: GRESKA RAINER. Apo.Manc.: GRESKA RAINER. Nombramientos. Apoderado: PALOMO RAMOSNURIA;GARCIA DE PABLO SILVIA;GONZALEZ ESTEBAN SILVIA;SANZ SANZ GEMA;REYNALDO SANCHEZ RICARDO;CUESTAESCRIBANO EMILIANO;GOMEZ MILLAN ELENA;SANZ GONZALEZ JUAN;WOLFF ANDREAS. Datos registrales. T 31861 , F 139,S 8, H M 172561, I/A 141 (22.06.18).
25 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MURNIEKS JAMES. Nombramientos. Consejero: KLEIN MARTIN. Datos registrales. T 31861 , F138, S 8, H M 172561, I/A 140 (16.05.18).
03 de Enero de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: HARO FERNANDEZ MARTA. Apoderado: HARO FERNANDEZ MARTA;HARO FERNANDEZ MARTA.Nombramientos. Apoderado: SANZ GONZALEZ JUAN. Datos registrales. T 31861 , F 135, S 8, H M 172561, I/A 139 (22.12.17).
15 de Diciembre de 2017Revocaciones. Apoderado: DUQUE ALCORTA JESUS. Apo.Sol.: DUQUE ALCORTA JESUS. Apo.Manc.: DUQUE ALCORTAJESUS. Apoderado: DUQUE ALCORTA JESUS. Apo.Manc.: DUQUE ALCORTA JESUS. Datos registrales. T 31861 , F 135, S 8, HM 172561, I/A 138 ( 9.12.17).
11 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31861 , F 134, S 8, H M 172561, I/A 137 (29.11.17).
26 de Octubre de 2017Revocaciones. Apoderado: BROCH RODRIGUEZ MARIA-LUISA. Datos registrales. T 31861 , F 134, S 8, H M 172561, I/A 136(18.10.17).
24 de Agosto de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: FOLTYN CHRISTIAN. Apo.Sol.: FOLTYN CHRISTIAN. Datos registrales. T 31861 , F 131, S 8, H M172561, I/A 135 (14.08.17).
07 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN CELEMIN JUAN JOSE. Nombramientos. Consejero: CAMPON ALONSO ANA. Datosregistrales. T 31861 , F 131, S 8, H M 172561, I/A 134 (28.07.17).
05 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: DUQUE ALCORTA JESUS;GRESKA RAINER. Otros conceptos: Revocación de la facultad 19otorgada a favor de D. Jesús Duque Alcorta el 31 de enero de 2014 ante el notario D. David del Arco Ramos con el número deprotocolo 149 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con el número 76. Revocación de la facultad 19 otorgada a favor de D.Rainer Greska el 2 de julio de 2015 ante el notario D. David del Arco Ramos con el número de protocolo 1064 e inscrita en el RegistroMercantil de Madrid con el número 79 . Datos registrales. T 31861 , F 130, S 8, H M 172561, I/A 133 (24.04.17).
08 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: DUQUE ALCORTA JESUS. Datos registrales. T 31861 , F 127, S 8, H M 172561, I/A 131 (31.01.17).
Nombramientos. Apoderado: SALAMANCA CEJUDO ESTRELLA MARIA;MENENDEZ SORIA LUIS FIDEL;BARTOLOMEU OVEJASUSANA;ORTIZ UZABAL BEGOÑA;BENEDICTO DUQUE OLGA;GARCIA RUIZ DE LEON CELIA;GARCIA GUIL JOSELUIS;GONZALEZ GARCIA MARIA JOSE;REMIS FERNANDEZ GEMA;HARO FERNANDEZ MARTA;NAVARRO SANCHEZ RAQUEL.Datos registrales. T 31861 , F 127, S 8, H M 172561, I/A 132 ( 1.02.17).
23 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: PITA BARROS FERNANDO;VON SCHELLWITZ CHIRSTIAN;PITA BARROS FERNANDO;BENITOSANCHEZ LUIS ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: BROCH RODRIGUEZ MARIA-LUISA. Datos registrales. T 31861 , F127, S 8, H M 172561, I/A 130 (14.11.16).
06 de Octubre de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31861 , F 126, S 8, H M 172561, I/A 129 (28.09.16).
05 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: SCHMUTZER PETER. Nombramientos. Consejero: MURNIEKS JAMES. Datos registrales. T31861 , F 126, S 8, H M 172561, I/A 128 (23.09.16).
17 de Agosto de 2016Nombramientos. Apoderado: HERRERA ARMAS ADELA;SANTIAGO CASTILLO ANGELICA;CORNEJO ALONSO MARIACAMINO;FERNANDEZ GARCIA BEATRIZ;SIERRA LOPEZ ALFONSO. Datos registrales. T 31861 , F 126, S 8, H M 172561, I/A 127( 5.08.16).
08 de Julio de 2016Ampliacion del objeto social. C) La financiación de empresas, pertenezcan o no al Grupo Siemens, mediante operaciones talescomo el descuento de derechos de crédito, la concesión de crédito comercial, factoring, forfeiting, renting, leasing, cesión, adquisición ygestión de créditos y/o derechos de cobro, etc... Datos registrales. T 31861 , F 125, S 8, H M 172561, I/A 126 (30.06.16).
14 de Abril de 2016Reelecciones. Consejero: FOLTYN CHRISTIAN;SCHMUTZER PETER. Presidente: FOLTYN CHRISTIAN. Consejero: DUQUEALCORTA JESUS;MARTIN CELEMIN JUAN JOSE. Datos registrales. T 31861 , F 125, S 8, H M 172561, I/A 125 ( 7.04.16).
03 de Marzo de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31861 , F 124, S 8, H M 172561, I/A 80 (23.02.16).
16 de Septiembre de 2015Revocaciones. Apoderado: SANZ GONZALEZ JUAN. Apo.Man.Soli: SANZ GONZALEZ JUAN. Apoderado: SANZ GONZALEZ JUAN.Nombramientos. Apoderado: GRESKA RAINER. Datos registrales. T 31861 , F 121, S 8, H M 172561, I/A 79 ( 8.09.15).
16 de Abril de 2015Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 77 LA FECHA DE REELECCION DEL AUDITOR ERNST & YOUNGSL, SIENDO LA CORRECTA 12/02/2014. Datos registrales. T 31861 , F 120, S 8, H M 172561, I/A 77 (25.04.14).
06 de Junio de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: PEREZ PEREZ JOSE AURELIO. Datos registrales. T 31861 , F 120, S 8, H M 172561, I/A 78(30.05.14).
06 de Mayo de 2014Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 31861 , F 120, S 8, H M 172561, I/A 77 (25.04.14).
14 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: CONDE TRUJILLO JOSE JAVIER;VON SCHELLWITZ CHIRSTIAN;CORNEJO ALONSO MARIACAMINO;DUQUE ALCORTA JESUS;SANZ GONZALEZ JUAN;SORIA GUTIERREZ EUGENIO;PITA BARROS FERNANDO;SIERRALOPEZ ALFONSO;FERNANDEZ GARCIA BEATRIZ;HERRERA ARMAS ADELA;BUDACH DIRK;HARO FERNANDEZMARTA;BENITO SANCHEZ LUIS ALBERTO;PEÑA JIMENEZ YOANA;SANTIAGO CASTILLO ANGELICA. Datos registrales. T17316 , F 111, S 8, H M 172561, I/A 76 ( 6.02.14).
25 de Junio de 2013Cambio de objeto social. A) LA PROMOCION DE ACTOS U OPERACIONES DE COMERCIO POR CUENTA AJENA Y ACONCLUIRLOS POR CUENTA AJENA, IGUALMENTE RESPECTO DE PRODUCTOS, APARATOS Y SERVICIOS REALIZADOS OFABRICADOS POR EL GRUPO SIEMENS. B) LA COMPRA, VENTA, ADMINISTRACION, ARRENDAMIENTO SUBARRIENDO YCESION, POR CUALQUIER TITULO, DE. Datos registrales. T 17316 , F 111, S 8, H M 172561, I/A 75 (17.06.13).
20 de Junio de 2013Revocaciones. Apoderado: BORT ALONSO VICENTE;UTRERO AGUDO VICTORIA;BORT ALONSO VICENTE;UTRERO AGUDOVICTORIA. Datos registrales. T 17316 , F 111, S 8, H M 172561, I/A 74 (13.06.13).
22 de Mayo de 2013Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 17316 , F 110, S 8, H M 172561, I/A 73 (13.05.13).
26 de Abril de 2013Reelecciones. Consejero: DUQUE ALCORTA JESUS;MARTIN CELEMIN JUAN JOSE. Datos registrales. T 17316 , F 110, S 8, H M172561, I/A 72 (18.04.13).
05 de Diciembre de 2012Revocaciones. Apoderado: ECKHOFF THOMAS. Datos registrales. T 17316 , F 110, S 8, H M 172561, I/A 71 (26.11.12).
03 de Diciembre de 2012Nombramientos. Presidente: FOLTYN CHRISTIAN. Datos registrales. T 17316 , F 109, S 8, H M 172561, I/A 68 (21.11.12).
Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa:http://finance.siemens.com/financialservices/es/Pages/Home.aspx. Datos registrales. T 17316 , F 109, S 8, H M 172561, I/A 69(21.11.12).
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 17316 ,F 109, S 8, H M 172561, I/A 70 (21.11.12).
29 de Octubre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ANDREW JONATHAN;SCHNEIDER BERNHARD. Presidente: ANDREW JONATHAN.Nombramientos. Consejero: FOLTYN CHRISTIAN;SCHMUTZER PETER. Datos registrales. T 17316 , F 109, S 8, H M 172561, I/A67 (18.10.12).
03 de Septiembre de 2012Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 17316 , F 108, S 8, H M 172561, I/A 66 (21.08.12).
17 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DE ROSSI PIERFRANCESCO. Revocaciones. Apoderado: VON SCHELLWITZ CHIRSTIAN.Apo.Manc.: BORT ALONSO VICENTE;UTRERO AGUDO VICTORIA. Nombramientos. Secretario: ORTEGA LOPEZ DE SANTAMARIA FERNANDO. Apo.Man.Soli: SANZ GONZALEZ JUAN;HARO FERNANDEZ MARTA. Apoderado: CELDRAN GONZALEZMALTA. Datos registrales. T 17316 , F 108, S 8, H M 172561, I/A 65 ( 3.10.11).
16 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: BABINET OLIVIER. Reducción de capital. Importe reducción: 8.259.151,65 Euros. ResultanteSuscrito: 2.740.828,35 Euros. Ampliación de capital. Suscrito: 4.999.997,60 Euros. Desembolsado: 4.999.997,60 Euros. ResultanteSuscrito: 7.740.825,95 Euros. Resultante Desembolsado: 7.740.825,95 Euros. Datos registrales. T 17316 , F 107, S 8, H M 172561,I/A 64 ( 5.09.11).
08 de Abril de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: DUQUE ALCORTA JESUS. Apo.Manc.: DUQUE ALCORTA JESUS. Datos registrales. T 17316 , F 106,S 8, H M 172561, I/A 63 (30.03.11).
07 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Secretario: OLIVER ROMERO ISMAEL. Nombramientos. SecreNoConsj: DE ROSSI PIERFRANCESCO.Datos registrales. T 17316 , F 105, S 8, H M 172561, I/A 62 (28.03.11).
28 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ECKHOFF THOMAS;BORT ALONSO VICENTE. Presidente: ECKHOFF THOMAS. Nombramientos.Consejero: DUQUE ALCORTA JESUS;SCHNEIDER BERNHARD. Presidente: ANDREW JONATHAN. Consejero: MARTIN CELEMINJUAN JOSE. Datos registrales. T 17316 , F 105, S 8, H M 172561, I/A 61 (16.03.11).
25 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: LANGE ANDREAS. Reelecciones. Consejero: ANDREW JONATHAN. Datos registrales. T 17316 ,F 105, S 8, H M 172561, I/A 60 (15.03.11).
04 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: BORT ALONSO VICENTE;UTRERO AGUDO VICTORIA. Datos registrales. T 17316 , F 104, S 8, H M172561, I/A 59 (23.02.10).
02 de Marzo de 2010Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 17316 , F 104, S 8, H M 172561, I/A 58 (18.02.10).
01 de Marzo de 2010Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 17316 , F 104, S 8, H M 172561, I/A 57 (17.02.10).