Actos BORME de Siempre Seremos Cuatro -grupo Martinez- Sl
02 de Agosto de 2022Nombramientos. APOD.MANCOMU: JIMENEZ GOZALVEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 42076 , F 209, S 8, H B 401209,I/A 11 (26.07.22).
Nombramientos. APOD.MANCOMU: SERRATOSA FRANSI DAVID. Datos registrales. T 42076 , F 209, S 8, H B 401209, I/A 12(26.07.22).
Nombramientos. APOD.MANCOMU: ALTES BLASI ELISENDA. Datos registrales. T 42076 , F 210, S 8, H B 401209, I/A 13(26.07.22).
13 de Septiembre de 2017Nombramientos. ADM.UNICO: MARTINEZ VIVANCOS JOSE MARIA. Datos registrales. T 42076 , F 209, S 8, H B 401209, I/A 10 (6.09.17).
08 de Junio de 2017Nombramientos. APODERAD.SOL: MARTINEZ VIVANCOS JULIA. Datos registrales. T 42076 , F 208, S 8, H B 401209, I/A 9 (1.06.17).
13 de Enero de 2017Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: MARTINEZ VIVANCOS JOSE MARIA;MARTINEZ VIVANCOS JULIA. Nombramientos.ADM.UNICO: MARTINEZ VIVANCOS JOSE MARIA. Datos registrales. T 42076 , F 208, S 8, H B 401209, I/A 8 ( 4.01.17).
13 de Mayo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 333.682,00 Euros. Resultante Suscrito: 21.331.640,00 Euros. Datos registrales. T 42076 , F 208, S8, H B 401209, I/A 7 ( 5.05.16).
18 de Diciembre de 2015Modificaciones estatutarias. ART.19.-RETRIBUCION DEL CARGO DE ADMINISTRADOR. Datos registrales. T 42076 , F 207, S8, H B 401209, I/A 6 (10.12.15).
04 de Diciembre de 2015Revocaciones. CONSEJERO: VIVANCOS BOIX NIEVES. PRESIDENTE: VIVANCOS BOIX NIEVES. CONS. DELEG.: VIVANCOSBOIX NIEVES. CONSEJERO: MARTINEZ VIVANCOS JOSE MARIA. SECRETARIO: MARTINEZ VIVANCOS JOSE MARIA.CONSEJERO: MARTINEZ VIVANCOS JULIA. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: MARTINEZ VIVANCOS JOSE MARIA;MARTINEZVIVANCOS JULIA. Datos registrales. T 42076 , F 207, S 8, H B 401209, I/A 5 (26.11.15).
18 de Febrero de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: MARTINEZ VIVANCOS JOSE MARIA. Datos registrales. T 42076 , F 206, S 8, H B 401209, I/A4 (10.02.15).
12 de Febrero de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 911.923,00 Euros. Resultante Suscrito: 20.997.958,00 Euros. Datos registrales. T 42076 , F 206, S8, H B 401209, I/A 3 ( 4.02.15).
08 de Marzo de 2013Modificaciones estatutarias. ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 42076 , F 205, S 8, H B 401209, I/A 2 (28.02.13).
16 de Septiembre de 2010Fe de erratas: En el BORME no.171/2010 y con referencia 341415 DONDE SE LEE COMO DENOMINACION SOCIAL " SIEMPRESEREMOS CUATRO GRUPO MARTINEZ SL " DEBE LEERSE " SIEMPRE SEREMOS CUATRO (GRUPO MARTINEZ) SL. Datosregistrales. T 42076 , F 199, S 8, H B 401209, I/A 1 (23.08.10).
06 de Septiembre de 2010Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 14.05.10. Objeto social: LA ADQUISICION,TENENCIA,ADMINISTRACION,ENAJENACIONDE TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS REPRSENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES RESIDENTES ENESPA脩A,Y NO RESIDENTES EN ESPA脩A,ETC. Domicilio: RD SANT ANTONI 36-38 (BARCELONA). Capital: 20.086.035,00 Euros.Nombramientos. CONSEJERO: VIVANCOS BOIX NIEVES. PRESIDENTE: VIVANCOS BOIX NIEVES. CONS. DELEG.: VIVANCOSBOIX NIEVES. CONSEJERO: MARTINEZ VIVANCOS JOSE MARIA. SECRETARIO: MARTINEZ VIVANCOS JOSE MARIA.CONSEJERO: MARTINEZ VIVANCOS JULIA. Datos registrales. T 42076 , F 199, S 8, H B 401209, I/A 1 (23.08.10).