Buscador CIF Logo

Actos BORME Silanes Idf Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Silanes Idf Sl

Actos BORME Silanes Idf Sl - B85510659

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Silanes Idf Sl con CIF B85510659

🔙 Perfil de Silanes Idf Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Silanes Idf Sl

24 de Noviembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ DE SILANES PEREZ JAIME. Presidente: LOPEZ DE SILANES PEREZ JAIME.Nombramientos. Presidente: LOPEZ DE SILANES ALBAFULL ALEJANDRO. VOCAL: DE ROBINA LOPEZ DE SILANESALFONSO;LOPEZ DE SILANES GOMEZ ELOISA. Datos registrales. T 25922 , F 95, S 8, H M 467224, I/A 17 (17.11.22).

19 de Agosto de 2022
Nombramientos. Consejero: LOPEZ DE SILANES ALBAFULL ALEJANDRO. Datos registrales. T 25922 , F 95, S 8, H M 467224,I/A 16 (11.08.22).

04 de Marzo de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE ROBINA LOPEZ DE SILANES JAVIER. SecreNoConsj: GUSTAVO GALAN ABAD.

26 de Abril de 2021
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ DE SILANES VALGAÑON CRESCENCIO. Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE SILANESGOMEZ ELOISA. Datos registrales. T 25922 , F 94, S 8, H M 467224, I/A 14 (19.04.21).

22 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE SILANES GOMEZ ELOISA. Datos registrales. T 25922 , F 93, S 8, H M 467224, I/A 13(15.04.21).

13 de Abril de 2021
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ DE SILANES PEREZ JAIME;LOPEZ DE SILANES VALGAÑON CRESCENCIO;DE ROBINALOPEZ DE SILANES ALFONSO;LOPEZ DE SILANES ALBAFULL ALEJANDRO. Datos registrales. T 25922 , F 92, S 8, H M 467224,I/A 12 ( 6.04.21).

12 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ DE SILANES VALGAÑON CRESCENCIO. Vicepresid.: LOPEZ DE SILANES VALGAÑONCRESCENCIO. Nombramientos. Consejero: LOPEZ DE SILANES GOMEZ ELOISA. Reducción de capital. Importe reducción:512.729,00 Euros. Resultante Suscrito: 663.979,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 7. Capital social.-.Datos registrales. T 25922 , F 91, S 8, H M 467224, I/A 11 ( 8.02.21).

11 de Febrero de 2021
Declaración de unipersonalidad. Socio único: NETHERLANDS FINANCE SARL. Datos registrales. T 25922 , F 91, S 8, H M467224, I/A 10 ( 4.02.21).

23 de Octubre de 2018
Ampliación de capital. Capital: 343.208,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.176.708,00 Euros. Datos registrales. T 25922 , F 90, S 8,H M 467224, I/A 9 (16.10.18).

11 de Mayo de 2017
Cambio de domicilio social. C/ SANTIAGO GRISOLIA 2 - RECINTO PTM 148. (TRES CANTOS). Datos registrales. T 25922 , F90, S 8, H M 467224, I/A 8 ( 3.05.17).

05 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ DE SILANES PEREZ ANTONIO. Consejero: LOPEZ DE SILANES PEREZ ANTONIO.Presidente: LOPEZ DE SILANES PEREZ ANTONIO. Consejero: LOPEZ DE SILANES VALGAÑON CRESCENCIO. Vicepresid.:LOPEZ DE SILANES VALGAÑON CRESCENCIO. Consejero: TIMS BV;DE ROBINA LOPEZ DE SILANES ALFONSO. SecreNoConsj:GALAN ABAD GUSTAVO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ DE SILANES PEREZ ANTONIO;LOPEZ DE SILANES VALGAÑONCRESCENCIO;DE ROBINA LOPEZ DE SILANES ALFONSO. Apoderado: TIMS BV. Nombramientos. SecreNoConsj: GUSTAVOGALAN ABAD. Consejero: LOPEZ DE SILANES PEREZ JAIME;DE ROBINA LOPEZ DE SILANES JAVIER;LOPEZ DE SILANESVALGAÑON CRESCENCIO;DE ROBINA LOPEZ DE SILANES ALFONSO. Presidente: LOPEZ DE SILANES PEREZ JAIME.Vicepresid.: LOPEZ DE SILANES VALGAÑON CRESCENCIO. Datos registrales. T 25922 , F 89, S 8, H M 467224, I/A 7 (25.04.17).

19 de Abril de 2017
Nombramientos. Apoderado: TIMS BV. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 5ª LA PUBLICACION DELPODER OTORGADO A "TIMS BV". Datos registrales. T 25922 , F 87, S 8, H M 467224, I/A 5 (20.03.14).

28 de Febrero de 2017
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 5ª EL NOMBRAMIENTO DE LOPEZ DE SILANES VALGAÑONCRESCENCIO COMO VICEPRESIDENTE, DEBIENDO QUEDAR EL MISMO VIGENTE EN DICHO CARGO POR LA INSCRIPCION1ª. Datos registrales. T 25922 , F 87, S 8, H M 467224, I/A 5 (20.03.14).

10 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apoderado: GALAN ABAD GUSTAVO ENRIQUE;CRUZADO PEREZ FERNANDO. Datos registrales. T 25922 , F89, S 8, H M 467224, I/A 6 ( 2.03.15).

28 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Secretario: GAXIOLA SAENZ JUAN JOSE. Consejero: LOPEZ DE SILANES PEREZ JUAN. Vicepresid.: LOPEZ

27 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ DE AYALA MAYORAL ANGEL. Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ DE AYALAMAYORAL ANGEL. Datos registrales. T 25922 , F 87, S 8, H M 467224, I/A 4 (20.03.14).

18 de Mayo de 2009
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Nombramientos. Consejero: LOPEZ DE SILANES PEREZ JUAN;TIMS BV. Representan:GAXIOLA SAENZ JUAN JOSE. Ampliación de capital. Capital: 830.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 833.500,00 Euros. Cambiode domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 139 2º A (MADRID). Datos registrales. T 25922 , F 86, S 8, H M 467224, I/A 2 (5.05.09).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ DE SILANES PEREZ ANTONIO;LOPEZ DE SILANES VALGAÑON CRESCENCIO;PEREZ DEAYALA MAYORAL ANGEL. Nombramientos. Vicepresid.: LOPEZ DE SILANES PEREZ JUAN. Apo.Man.Soli: LOPEZ DE SILANESPEREZ ANTONIO;LOPEZ DE SILANES PEREZ JUAN;LOPEZ DE SILANES VALGAÑON CRESCENCIO;PEREZ DE AYALAMAYORAL ANGEL;TIMS BV. Datos registrales. T 25922 , F 86, S 8, H M 467224, I/A 3 ( 5.05.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información